Actos BORME de Monvaga Sl
03 de Enero de 2023Nombramientos. Apo.Sol.: BUJ ALANDI MARTA;BUJ ALANDI JAVIER. Datos registrales. T 145 , F 83, S 8, H L 2605, I/A 14(19.12.22).
30 de Diciembre de 2022Reducci贸n de capital. Importe reducci贸n: 592.263,83 Euros. Resultante Suscrito: 253.844,53 Euros. Datos registrales. T 145 , F 83,S 8, H L 2605, I/A 13 (19.12.22).
09 de Mayo de 2019Ceses/Dimisiones. Consejero: BUJ COTES JUAN MANUEL;MONTARDIT ESTRUCH FERNANDO;VAREA CORRAL LUIS;GARCIAMATAS BLAS. Presidente: BUJ COTES JUAN MANUEL. Con.Delegado: BUJ COTES JUAN MANUEL. Secretario: MONTARDITESTRUCH FERNANDO. Nombramientos. Consejero: BUJ COTES JUAN MANUEL;MONTARDIT ESTRUCH FERNANDO;ROGERMARTI ANTONIO. Presidente: BUJ COTES JUAN MANUEL. Secretario: MONTARDIT ESTRUCH FERNANDO. Con.Delegado: BUJCOTES JUAN MANUEL. Datos registrales. T 145 , F 82, S 8, H L 2605, I/A 12 ( 2.05.19).
25 de Mayo de 2016Nombramientos. Apoderado: BUJ COTES JUAN MANUEL;MONTARDIT ESTRUCH FERNANDO;VAREA CORRAL LUIS;GARCIAMATAS BLAS. Ampliaci贸n de capital. Capital: 324.113,12 Euros. Resultante Suscrito: 846.108,36 Euros. Datos registrales. T 141 ,F 224, S 8, H L 2605, I/A 11 (18.05.16).
27 de Agosto de 2012Ampliaci贸n de capital. Capital: 461.885,24 Euros. Resultante Suscrito: 521.995,24 Euros. Datos registrales. T 141 , F 223, S 8, H L2605, I/A 10 (16.08.12).