Actos BORME de Mosquililla Sl
27 de Abril de 2023Nombramientos. Auditor: BDO AUDITORES SLP. Datos registrales. T 35170 , F 9, S 8, H M 418992, I/A 36 (20.04.23).
17 de Enero de 2023Reducci贸n de capital. Importe reducci贸n: 25.800.000,00 Euros. Resultante Suscrito: 19.002.000,00 Euros. Datos registrales. T35170 , F 9, S 8, H M 418992, I/A 35 (10.01.23).
16 de Enero de 2023Ceses/Dimisiones. Presidente: CALVO CAMINERO MERCEDES. Vicepr.1: VALDEQUINILLA SL. Vicepr.2: ANGERAN SL.Nombramientos. Presidente: GERVAS HIERRO ANA FRANCISCA. Vicepr.1: ANGERAN SL. Vicepr.2: CANETONIN SL. Datosregistrales. T 35170 , F 8, S 8, H M 418992, I/A 34 ( 9.01.23).
20 de Octubre de 2021Ceses/Dimisiones. Presidente: GERVAS GERMINA CHRISTELLE EVA. Vicepr.1: CANETONIN SL. Vicepr.2: VALDEQUINILLA SL.Nombramientos. Presidente: CALVO CAMINERO MERCEDES. Vicepr.1: VALDEQUINILLA SL. Vicepr.2: ANGERAN SL. Datosregistrales. T 35170 , F 8, S 8, H M 418992, I/A 33 (13.10.21).
27 de Noviembre de 2020Ceses/Dimisiones. Presidente: GERVAS HIERRO ANA FRANCISCA. Vicepr.1: ANGERAN SL. Vicepr.2: CANETONIN SL.Nombramientos. Presidente: GERVAS GERMINA CHRISTELLE EVA. Vicepr.1: CANETONIN SL. Vicepr.2: VALDEQUINILLA SL.Datos registrales. T 35170 , F 7, S 8, H M 418992, I/A 32 (20.11.20).
31 de Diciembre de 2019Ceses/Dimisiones. Representan: RUEDA GONZALEZ PEDRO ANTONIO. Nombramientos. Representan: FERNANDEZ CALVOGERARDO. Datos registrales. T 35170 , F 7, S 8, H M 418992, I/A 31 (23.12.19).
04 de Julio de 2019Ceses/Dimisiones. Presidente: CALVO CAMINERO MERCEDES. Vicepr.1: VALDEQUINILLA SL. Vicepr.2: ANGERAN SL.Nombramientos. Presidente: GERVAS HIERRO ANA FRANCISCA. Vicepr.1: ANGERAN SL. Vicepr.2: CANETONIN SL. Datosregistrales. T 35170 , F 7, S 8, H M 418992, I/A 30 (27.06.19).
12 de Febrero de 2019Ceses/Dimisiones. Vicesecret.: GUARDO GALDON MARIA LUISA. Nombramientos. Vicesecret.: SILVA RUIZ DEL OLMOBLANCA. Datos registrales. T 35170 , F 6, S 8, H M 418992, I/A 29 ( 5.02.19).
17 de Julio de 2018Ceses/Dimisiones. Presidente: GERVAS GERMINA CHRISTELLE EVA. Vicepr.1: CANETONIN SL. Vicepr.2: VALDEQUINILLA SL.Nombramientos. Presidente: CALVO CAMINERO MERCEDES. Vicepr.1: VALDEQUINILLA SL. Vicepr.2: ANGERAN SL. Datosregistrales. T 35170 , F 6, S 8, H M 418992, I/A 28 ( 9.07.18).
29 de Septiembre de 2017Ceses/Dimisiones. Presidente: GERVAS HIERRO ANA FRANCISCA. Vicepr.1: ANGERAN SL. Vicepr.2: CANETONIN SL.Nombramientos. Presidente: GERVAS GERMINA CHRISTELLE EVA. Vicepr.1: CANETONIN SL. Vicepr.2: VALDEQUINILLA SL.Datos registrales. T 35170 , F 5, S 8, H M 418992, I/A 27 (22.09.17).
26 de Julio de 2017Ceses/Dimisiones. Representan: LOPEZ DE HIERRO PEREZ MINGUEZ FRANCISCO JAVIER. Nombramientos. Representan:VARELA TORRES NURIA MARTA. Datos registrales. T 35170 , F 5, S 8, H M 418992, I/A 26 (18.07.17).
10 de Octubre de 2016Ceses/Dimisiones. Vicepresid.: GERVAS GERMINA CHRISTELLE EVA. Nombramientos. Consejero: ANGERANSL;VALDEQUINILLA SL;CANETONIN SL. Representan: RUEDA GONZALEZ PEDRO ANTONIO;LOPEZ DE HIERRO PEREZ
08 de Agosto de 2016Ceses/Dimisiones. Presidente: CALVO CAMINERO MERCEDES. Vicepresid.: GERVAS HIERRO ANA FRANCISCA.Nombramientos. Presidente: GERVAS HIERRO ANA FRANCISCA. Vicepresid.: GERVAS GERMINA CHRISTELLE EVA. Datosregistrales. T 23361 , F 216, S 8, H M 418992, I/A 24 (29.07.16).
15 de Junio de 2015Ceses/Dimisiones. Presidente: GERVAS GERMINA CHRISTELLE EVA. Vicepresid.: CALVO CAMINERO MERCEDES.Nombramientos. Presidente: CALVO CAMINERO MERCEDES. Vicepresid.: GERVAS HIERRO ANA FRANCISCA. Datosregistrales. T 23361 , F 216, S 8, H M 418992, I/A 23 ( 8.06.15).
29 de Enero de 2015Fe de erratas: SE PUBLICO POR ERROR EN LA INSCRIPCION 22& EL NOMBRAMIENTO DE GERVAS HIERRO ANAFRANCISCA Y GERVAS GERMINA CHRISTELLE EVA COMO PRESIDENTA Y VICEPRESIDENTA RESPECTIVAMENTE, SIENDOLO CORRECTO GERVAS GERMINA CHRISTELLE EVA COMO PRESIDENTA Y CALVO CAMINERO MERCEDES COMOVICEPRESIDENTA. Datos registrales. T 23361 , F 216, S 8, H M 418992, I/A 22 (11.06.14).
Ceses/Dimisiones. Presidente: GERVAS HIERRO ANA FRANCISCA. Vicepresid.: GERVAS GERMINA CHRISTELLE EVA.Nombramientos. Presidente: GERVAS GERMINA CHRISTELLE EVA. Vicepresid.: CALVO CAMINERO MERCEDES. Datosregistrales. T 23361 , F 216, S 8, H M 418992, I/A 22 (11.06.14).
20 de Junio de 2014Reelecciones. Presidente: GERVAS HIERRO ANA FRANCISCA. Vicepresid.: GERVAS GERMINA CHRISTELLE EVA. Datosregistrales. T 23361 , F 216, S 8, H M 418992, I/A 22 (11.06.14).
09 de Septiembre de 2013Nombramientos. Auditor: ATA AUDITORES SL. Datos registrales. T 23361 , F 215, S 8, H M 418992, I/A 21 ( 2.09.13).
19 de Julio de 2013Nombramientos. Apo.Manc.: CALVO CAMINERO MERCEDES;GERVAS HIERRO ANA FRANCISCA;GERVAS GERMINACHRISTELLE EVA. Datos registrales. T 23361 , F 215, S 8, H M 418992, I/A 20 (11.07.13).
28 de Junio de 2013Ceses/Dimisiones. Presidente: CALVO CAMINERO MERCEDES. Vicepresid.: GERVAS HIERRO ANA FRANCISCA.Nombramientos. Presidente: GERVAS HIERRO ANA FRANCISCA. Vicepresid.: GERVAS GERMINA CHRISTELLE EVA. Datosregistrales. T 23361 , F 214, S 8, H M 418992, I/A 19 (20.06.13).
24 de Abril de 2013Nombramientos. Apoderado: CALVO CAMINERO MERCEDES;GERVAS HIERRO ANA FRANCISCA;GERVAS GERMINACHRISTELLE EVA. Datos registrales. T 23361 , F 214, S 8, H M 418992, I/A 18 (16.04.13).
04 de Julio de 2012Cambio de domicilio social. C/ GUZMAN EL BUENO 133 9& (MADRID). Datos registrales. T 23361 , F 214, S 8, H M 418992, I/A17 (22.06.12).
29 de Junio de 2012Ceses/Dimisiones. Presidente: GERVAS GERMINA CHRISTELLE EVA. Vicepresid.: CALVO CAMINERO MERCEDES.Nombramientos. Presidente: CALVO CAMINERO MERCEDES. Vicepresid.: GERVAS HIERRO ANA FRANCISCA. Datosregistrales. T 23361 , F 213, S 8, H M 418992, I/A 16 (20.06.12).
17 de Junio de 2011Ceses/Dimisiones. Presidente: GERVAS HIERRO ANA FRANCISCA. Vicepresid.: GERVAS GERMINA CHRISTELLE EVA.Nombramientos. Presidente: GERVAS GERMINA CHRISTELLE EVA. Vicepresid.: CALVO CAMINERO MERCEDES. Datosregistrales. T 23361 , F 213, S 8, H M 418992, I/A 15 ( 7.06.11).
10 de Septiembre de 2010Ceses/Dimisiones. Presidente: CALVO CAMINERO MERCEDES. SecreNoConsj: TRINCHANT BLASCO CARLOS JOSE.Revocaciones. Apoderado: GONZALEZ PI脩AL MARGARITA. Apo.Man.Soli: TRINCHANT BLASCO CARLOS. Apo.Manc.: DIAZALBISU JOSE LUIS. Apo.Man.Soli: DIAZ ALBISU JOSE LUIS. Apo.Manc.: TRINCHANT BLASCO CARLOS. Apoderado: TRINCHANTBLASCO CARLOS JOSE. Nombramientos. SecreNoConsj: TRIGO SIERRA LUIS FERNANDO. Presidente: GERVAS HIERRO ANAFRANCISCA. Vicepresid.: GERVAS GERMINA CHRISTELLE EVA. VsecrNoConsj: GUARDO GALDON MARIA LUISA. Datosregistrales. T 23361 , F 212, S 8, H M 418992, I/A 14 (26.08.10).
28 de Octubre de 2009Ceses/Dimisiones. SecreNoConsj: DIAZ ALBISU JOSE LUIS. Vicesecret.: TRINCHANT BLASCO CARLOS JOSE. Con.Delegado:CALVO CAMINERO MERCEDES. Consejero: GERVAS DIEZ GERMAN. Presidente: GERVAS DIEZ GERMAN. Nombramientos.Presidente: CALVO CAMINERO MERCEDES. SecreNoConsj: TRINCHANT BLASCO CARLOS JOSE. Datos registrales. T 23361 , F11, S 8, H M 418992, I/A 11 (16.10.09).
Nombramientos. Apoderado: CALVO CAMINERO MERCEDES;GERVAS HIERRO ANA FRANCISCA;GERVAS GERMINACHRISTELLE EVA. Datos registrales. T 23361 , F 12, S 8, H M 418992, I/A 12 (16.10.09).
Nombramientos. Apoderado: TRINCHANT BLASCO CARLOS JOSE;CALVO CAMINERO MERCEDES;GERVAS HIERRO ANAFRANCISCA;GERVAS GERMINA CHRISTELLE EVA. Datos registrales. T 23361 , F 13, S 8, H M 418992, I/A 13 (16.10.09).