Buscador CIF Logo

Actos BORME Mostoles Industrial Sa

驴Quieres acceder a la API de EMPRESAS CIF? Obten la informaci贸n de todas las empresas en tiempo real desde tu plataforma.
Ahora con un 25% de DESCUENTO el primer MES. Quiero la API de EMPRESAS

Logo cabecera Mostoles Industrial Sa

Actos BORME Mostoles Industrial Sa - A28160711

Tenemos registrados 69 Actos BORME del Registro Mercantil de Madrid para Mostoles Industrial Sa con CIF A28160711

馃敊 Perfil de Mostoles Industrial Sa
馃洅 Comprar listado completo de Empresas de Madrid

Actos BORME de Mostoles Industrial Sa

12 de Abril de 2023
Modificaciones estatutarias. Creaci贸n del art铆culo 13 bis de los Estatutos Sociales. Datos registrales. T 38446 , F 153, S 8, H M8908, I/A 177 ( 3.04.23).

28 de Febrero de 2023
Nombramientos. Apoderado: MORON MAZARIO LUIS ALBERTO. Datos registrales. T 38446 , F 151, S 8, H M 8908, I/A 176(21.02.23).

22 de Febrero de 2023
Nombramientos. Apo.Man.Soli: VILCHES VILCHES PEDRO ANTONIO. Datos registrales. T 38446 , F 150, S 8, H M 8908, I/A 175(15.02.23).

30 de Noviembre de 2022
Fusi贸n por absorci贸n. Sociedades absorbidas: TECNYDIS INSTALACIONES SA. Datos registrales. T 38446 , F 148, S 8, H M8908, I/A 174 (23.11.22).

01 de Agosto de 2022
Cancelaciones de oficio de nombramientos. Consejero: ALVAREZ ALVAREZ CESAR. Nombramientos. Consejero: ALVAREZPENELLA CAROLINA. Datos registrales. T 38446 , F 147, S 8, H M 8908, I/A 173 (22.07.22).

08 de Junio de 2021
Nombramientos. Apoderado: MORON MAZARIO LUIS ALBERTO. Datos registrales. T 38446 , F 147, S 8, H M 8908, I/A 172 (1.06.21).

16 de Abril de 2021
Cambio de domicilio social. C/ PLASENCIA 49 - POLIGONO INDUSTRIAL LAS NIEVES (MOSTOLES). Datos registrales. T38446 , F 146, S 8, H M 8908, I/A 171 ( 9.04.21).

23 de Octubre de 2020
Reelecciones. Auditor: ERNST & YOUNG SL. Aud.C.Con.: ERNST & YOUNG SL. Modificaciones estatutarias. 20.Funcionamiento Junta General.-. Datos registrales. T 38446 , F 146, S 8, H M 8908, I/A 170 (18.10.20).

09 de Octubre de 2020
Ceses/Dimisiones. SecreNoConsj: HERNANDEZ GIL ALVAREZ CIENFUEGOS ANTONIO. Nombramientos. SecreNoConsj:LORENZO ROMERO CARLOS. Datos registrales. T 38446 , F 145, S 8, H M 8908, I/A 169 ( 2.10.20).

11 de Septiembre de 2020
Nombramientos. Apoderado: RODRIGUEZ PE脩IL ALVARO;GIL ALBURQUERQUE ROMAN;HERNAN GARCIA ERNESTO;HEVIATEMPRANO FERNANDO VALDES;GARCIA FERNANDEZ JUAN RICARDO;GOERLICH LEON ANA. Datos registrales. T 38446 , F144, S 8, H M 8908, I/A 167 ( 4.09.20).

Nombramientos. Apo.Sol.: CORROCHANO GONZALEZ CRISTIAN. Datos registrales. T 38446 , F 145, S 8, H M 8908, I/A 168 (4.09.20).

19 de Marzo de 2020
Reelecciones. Aud.C.Con.: ERNST & YOUNG SL. Datos registrales. T 38446 , F 144, S 8, H M 8908, I/A 166 (12.03.20).

26 de Diciembre de 2019
Reelecciones. Auditor: ERNST & YOUNG SL. Datos registrales. T 38446 , F 143, S 8, H M 8908, I/A 165 (18.12.19).

29 de Noviembre de 2019
Nombramientos. Apo.Sol.: MORON MAZARIO LUIS ALBERTO. Datos registrales. T 38446 , F 142, S 8, H M 8908, I/A 162(22.11.19).

Nombramientos. Apo.Sol.: VILCHES VILCHES PEDRO ANTONIO. Datos registrales. T 38446 , F 142, S 8, H M 8908, I/A 163(22.11.19).

Nombramientos. Consejero: MORON MAZARIO LUIS ALBERTO;NIETO FERNANDEZ FRANCISCO JOSE. Reelecciones.Consejero: LASAGA MUNARRIZ FLORENCIO;MARTINEZ ECHAVARRIA ANSELMO CARLOS. Presidente: MARTINEZECHAVARRIA ANSELMO CARLOS. Datos registrales. T 38446 , F 143, S 8, H M 8908, I/A 164 (22.11.19).

05 de Marzo de 2019
Fe de erratas: Se public贸 por error el n煤mero de Inscripci贸n como 160, siendo lo correcto 161. Datos registrales. T 38446 , F 142, S8, H M 8908, I/A 161 (14.02.19).

21 de Febrero de 2019
Ceses/Dimisiones. Consejero: GIMENO ALVAREZ DIMAS RODRIGO. Datos registrales. T 38446 , F 142, S 8, H M 8908, I/A 160(14.02.19).

23 de Enero de 2019
Reelecciones. Auditor: ERNST & YOUNG SL. Aud.C.Con.: ERNST & YOUNG SL. Datos registrales. T 22585 , F 200, S 8, H M8908, I/A 160 (15.01.19).

20 de Julio de 2018
Ceses/Dimisiones. Consejero: ALVAREZ LOPEZ JOSE ANTONIO. Datos registrales. T 22585 , F 200, S 8, H M 8908, I/A 159(12.07.18).

17 de Enero de 2018
Reelecciones. Auditor: ERNST & YOUNG SL. Aud.C.Con.: ERNST & YOUNG SL. Datos registrales. T 22585 , F 200, S 8, H M8908, I/A 158 ( 8.01.18).

26 de Julio de 2017
Otros conceptos: Ratificaci贸n del nombramiento como consejero de Don Cesar Alvarez Alvarez designado por cooptaci贸n en reuni贸ncelebrada el 22 de marzo de 2017 y que caus贸 la inscripci贸n 156陋 de la hoja social. Datos registrales. T 22585 , F 199, S 8, H M8908, I/A 157 (18.07.17).

11 de Julio de 2017
Fe de erratas: Se public贸 por error en la Inscripci贸n 156陋 el nombramiento como Consejero de MANTECON ALVAREZ CESAR,siendo lo correcto ALVAREZ ALVAREZ CESAR. Datos registrales. T 22585 , F 199, S 8, H M 8908, I/A 156 (26.06.17).

04 de Julio de 2017
Nombramientos. Consejero: MANTECON ALVAREZ CESAR. Datos registrales. T 22585 , F 199, S 8, H M 8908, I/A 156(26.06.17).

24 de Enero de 2017
Nombramientos. Apoderado: MORAL DE LA ROSA JUAN. Datos registrales. T 22585 , F 199, S 8, H M 8908, I/A 155 (16.01.17).

28 de Noviembre de 2016
Nombramientos. Apoderado: POLAN COBO CATALINA. Datos registrales. T 22585 , F 198, S 8, H M 8908, I/A 154 (17.11.16).

04 de Noviembre de 2016
Ceses/Dimisiones. Consejero: RORIGUEZ-PONGA SALAMANCA ESTANISLAO. Datos registrales. T 22585 , F 198, S 8, H M8908, I/A 153 (26.10.16).

03 de Agosto de 2016
Nombramientos. Apoderado: VILCHES VILCHES PEDRO ANTONIO. Datos registrales. T 22585 , F 197, S 8, H M 8908, I/A 151(26.07.16).

Nombramientos. Apoderado: MORON MAZARIO LUIS ALBERTO. Datos registrales. T 22585 , F 198, S 8, H M 8908, I/A 152(26.07.16).

31 de Marzo de 2016
Nombramientos. Apo.Sol.: MORON MAZARIO LUIS ALBERTO. Datos registrales. T 22585 , F 195, S 8, H M 8908, I/A 148(18.03.16).

Nombramientos. Apoderado: CORROCHANO GONZALEZ CRISTIAN. Datos registrales. T 22585 , F 196, S 8, H M 8908, I/A 149(18.03.16).

Nombramientos. Apoderado: VILCHES VILCHES PEDRO ANTONIO. Datos registrales. T 22585 , F 196, S 8, H M 8908, I/A 150(18.03.16).

15 de Marzo de 2016
Revocaciones. Apoderado: MARTINEZ OLIVARES GOMEZ CESAR. Fe de erratas: SE OMITIO POR ERROR EN LAINSCRIPCION 147& LA PUBLICACION DE LA REVOCACION DEL PODER OTORGADO A MARTINEZ OLIVARES GOMEZ CESAREN LA INSCRIPCION 138&. Datos registrales. T 22585 , F 195, S 8, H M 8908, I/A 147 (23.02.16).

02 de Marzo de 2016
Revocaciones. Apoderado: VILCHES VILCHES PEDRO ANTONIO. Datos registrales. T 22585 , F 195, S 8, H M 8908, I/A 147(23.02.16).

26 de Mayo de 2015
Ceses/Dimisiones. Secretario: SORIANO ATENCIA FAUSTINO JOSE. Nombramientos. SecreNoConsj: HERNANDEZ GILALVAREZ CIENFUEGOS ANTONIO. Datos registrales. T 22585 , F 194, S 8, H M 8908, I/A 146 (19.05.15).

14 de Mayo de 2015
Revocaciones. Apoderado: CASADO SAENZ JAIME;ESCALONA MOYANO ENRIQUE;NIETO BLAZQUEZ CONSTANCIO;PEREZNEGRILLO JOSE MARIA;MU脩OZ PINEDA EDUARDO;ALONSO GONZALEZ JENARO JAVIER. Apo.Sol.: DIAZ DIAZ JOSEENRIQUE;RODRIGUEZ JARA RAUL. Apoderado: PEREZ GIANNINI SANTOS JORGE;VIDAL DE FERRER SERGIO;MU脩OZ PINEDAEDUARDO;PEREZ GIANNINI SANTOS JORGE;DIAZ SANTANA LUIS JESUS. Otros conceptos: REVOCADO EL PODERCONFERIDO A FAVOR DE DON JOSE MARIA SALMERON ARCE EN VIRTUD DE ESCRITURA AUTORIZADA POR EL NOTARIODE MOSTOLES, DON CARLOS SANZ-PASTOR Y FERNANDEZ DE PIEROLA, EL DIA 13 DE MARZO DE 1987, CON EL NUMERO590 DE SU PROTOCOLO, QUE CAUSO EN ESTE REGISTRO LA INSCRIPCION 36& DE SU HOJA. Datos registrales. T 22585 , F194, S 8, H M 8908, I/A 145 ( 6.05.15).

01 de Abril de 2015
Nombramientos. Apoderado: ORTEGA RODRIGUEZ JOSE MIGUEL. Datos registrales. T 22585 , F 193, S 8, H M 8908, I/A 144(24.03.15).

09 de Marzo de 2015
Ceses/Dimisiones. Aud.C.Con.: BDO AUDITORES SL. Nombramientos. Auditor: ERNST & YOUNG SL. Aud.C.Con.: ERNST &YOUNG SL. Datos registrales. T 22585 , F 193, S 8, H M 8908, I/A 143 ( 2.03.15).

19 de Diciembre de 2014
Ceses/Dimisiones. Consejero: CORPORACION CESLAR SL. Representan: ARECES GALAN JAVIER. Datos registrales. T 22585 ,F 193, S 8, H M 8908, I/A 142 (11.12.14).

04 de Noviembre de 2014
Nombramientos. Apoderado: MORON MAZARIO LUIS ALBERTO. Datos registrales. T 22585 , F 192, S 8, H M 8908, I/A 141(28.10.14).

07 de Octubre de 2014
Revocaciones. Apoderado: CASADO VICENTE CARLOS. Datos registrales. T 22585 , F 192, S 8, H M 8908, I/A 140 (29.09.14).

26 de Septiembre de 2014
Ceses/Dimisiones. Consejero: RODRIGUEZ PONGA Y SALAMANCA ESTANISLAO. Presidente: ALVAREZ ALVAREZ ISIDORO.Consejero: MARTINEZ ECHAVARRIA ANSELMO CARLOS;LASAGA MUNARRIZ FLORENCIO;ALVAREZ LOPEZ JOSEANTONIO;ALVAREZ ALVAREZ ISIDORO;CORPORACION CESLAR SL. Representan: ARECES GALAN JAVIER. Nombramientos.Representan: ARECES GALAN JAVIER. Consejero: ALVAREZ LOPEZ JOSE ANTONIO;CORPORACION CESLAR SL;GIMENOALVAREZ DIMAS RODRIGO;LASAGA MUNARRIZ FLORENCIO;MARTINEZ ECHAVARRIA ANSELMO CARLOS;RORIGUEZ-PONGA SALAMANCA ESTANISLAO. Presidente: MARTINEZ ECHAVARRIA ANSELMO CARLOS. Datos registrales. T 22585 , F191, S 8, H M 8908, I/A 139 (18.09.14).

10 de Abril de 2014
Nombramientos. Apoderado: MARTINEZ OLIVARES GOMEZ CESAR;VILCHES VILCHES PEDRO ANTONIO. Datos registrales. T22585 , F 189, S 8, H M 8908, I/A 138 ( 3.04.14).

14 de Enero de 2014
Nombramientos. Apoderado: DIAZ SANTANA LUIS JESUS. Datos registrales. T 22585 , F 189, S 8, H M 8908, I/A 137 ( 7.01.14).

13 de Enero de 2014
Reelecciones. Auditor: BDO AUDITORES SL. Datos registrales. T 22585 , F 189, S 8, H M 8908, I/A 136 ( 2.01.14).

12 de Agosto de 2013
Revocaciones. Apo.Sol.: MARTINEZ PUYO CARLOS-ENRIQUE. Datos registrales. T 22585 , F 189, S 8, H M 8908, I/A 135 (1.08.13).

19 de Junio de 2013
Revocaciones. Apoderado: ALARCON MARTIN RAFAEL. Datos registrales. T 22585 , F 188, S 8, H M 8908, I/A 132 (11.06.13).

Revocaciones. Apoderado: ALONSO GONZALEZ JAVIER;ALONSO GONZALEZ JAVIER. Datos registrales. T 22585 , F 188, S 8,H M 8908, I/A 133 (11.06.13).

Revocaciones. Apo.Sol.: PONCE GARCIA MANUEL-FRANCISCO. Datos registrales. T 22585 , F 188, S 8, H M 8908, I/A 134(11.06.13).

20 de Mayo de 2013
Ceses/Dimisiones. Secretario: DE MINGO CONTRERAS JUAN MANUEL. Consejero: DE MINGO CONTRERAS JUAN MANUEL.Nombramientos. Secretario: SORIANO ATENCIA FAUSTINO JOSE. Datos registrales. T 22585 , F 188, S 8, H M 8908, I/A 131(10.05.13).

13 de Diciembre de 2012
Nombramientos. Aud.C.Con.: BDO AUDITORES SL. Reelecciones. Auditor: BDO AUDITORES SL. Datos registrales. T 22585 , F187, S 8, H M 8908, I/A 130 ( 5.12.12).

13 de Agosto de 2012
Revocaciones. Apoderado: BRAVO HERNANDEZ JOSE;BRAVO HERNANDEZ JOSE. Datos registrales. T 22585 , F 187, S 8, H M8908, I/A 128 (23.07.12).

25 de Enero de 2012
Reelecciones. Auditor: BDO AUDITORES SL. Datos registrales. T 22585 , F 187, S 8, H M 8908, I/A 127 (12.01.12).

24 de Enero de 2012
Revocaciones. Apoderado: VIVES SERRANO LUIS. Datos registrales. T 22585 , F 187, S 8, H M 8908, I/A 126 ( 9.01.12).

23 de Septiembre de 2011
Modificaciones estatutarias. 2. Domicilio.-. Cambio de domicilio social. C/ GRANADA 50 (MOSTOLES). Cambio de objetosocial. LA FABRICACION, VENTA, INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE TODA CLASE DE MUEBLES, CARPINTERIA,ARTICULOS Y ELEMENTOS PARA LA DECORACION DE INTERIORES Y EXTERIORES. Datos registrales. T 22585 , F 186, S 8,H M 8908, I/A 125 (13.09.11).

20 de Mayo de 2011
Nombramientos. Apoderado: CASADO VICENTE CARLOS. Datos registrales. T 22585 , F 185, S 8, H M 8908, I/A 124 (10.05.11).

15 de Marzo de 2011
Nombramientos. Apoderado: MU脩OZ PINEDA EDUARDO. Datos registrales. T 22585 , F 180, S 8, H M 8908, I/A 122 ( 4.03.11).

Nombramientos. Apoderado: PEREZ GIANNINI SANTOS JORGE. Datos registrales. T 22585 , F 183, S 8, H M 8908, I/A 123 (4.03.11).

02 de Marzo de 2011
Revocaciones. Apo.Sol.: GARCIA LANA JOSE ANTONIO. Datos registrales. T 22585 , F 180, S 8, H M 8908, I/A 121 (18.02.11).

02 de Noviembre de 2010
Reelecciones. Auditor: BDO AUDITORES SL. Datos registrales. T 22585 , F 180, S 8, H M 8908, I/A 120 (19.10.10).

19 de Octubre de 2010
Nombramientos. Apoderado: FERNANDEZ CORDEIRO FERRANDIZ JESUS SANTIAGO. Datos registrales. T 22585 , F 179, S 8,H M 8908, I/A 119 ( 5.10.10).

14 de Mayo de 2010
Revocaciones. Apoderado: MU脩OZ RIESCO MIGUEL ANGEL. Datos registrales. T 22585 , F 179, S 8, H M 8908, I/A 118 (

21 de Abril de 2010
Revocaciones. Apo.Sol.: PEREZ NEGRILLO JOSE MARIA. Datos registrales. T 22585 , F 179, S 8, H M 8908, I/A 117 ( 8.04.10).

19 de Abril de 2010
Revocaciones. Apo.Sol.: HERNANDEZ TEJEDOR RICARDO. Datos registrales. T 22585 , F 179, S 8, H M 8908, I/A 115 ( 7.04.10).

Revocaciones. Apo.Sol.: NIETO BLAZQUEZ CONSTANCIO. Datos registrales. T 22585 , F 179, S 8, H M 8908, I/A 116 ( 7.04.10).

26 de Febrero de 2010
Nombramientos. Apoderado: VIDAL DE FERRER SERGIO. Datos registrales. T 22585 , F 178, S 8, H M 8908, I/A 113 (16.02.10).

Nombramientos. Apoderado: MARTINEZ OLIVARES GOMEZ CESAR. Datos registrales. T 22585 , F 178, S 8, H M 8908, I/A 114(16.02.10).

26 de Octubre de 2009
Reelecciones. Auditor: BDO AUDIBERIA AUDITORES SL. Datos registrales. T 22585 , F 177, S 8, H M 8908, I/A 112 (14.10.09).

06 de Agosto de 2009
Ceses/Dimisiones. Consejero: CONDE MARTIN CESAREO. Nombramientos. Consejero: RODRIGUEZ PONGA Y SALAMANCAESTANISLAO. Reelecciones. Representan: ARECES GALAN JAVIER. Presidente: ALVAREZ ALVAREZ ISIDORO. Secretario: DEMINGO CONTRERAS JUAN MANUEL. Consejero: ALONSO GONZALEZ JENARO JAVIER;DE MINGO CONTRERAS JUANMANUEL;MARTINEZ ECHAVARRIA ANSELMO CARLOS;LASAGA MUNARRIZ FLORENCIO;ALVAREZ LOPEZ JOSEANTONIO;ALVAREZ ALVAREZ ISIDORO;CORPORACION CESLAR SL. Datos registrales. T 22585 , F 177, S 8, H M 8908, I/A 111(27.07.09).

Utilizamos cookies de terceros con finalidades anal铆ticas, de personalizaci贸n, y de publicidad comportamental. Puede configurar ahora el uso de esta tecnolog铆a. Si acepta o contin煤a navegando, consideramos que est谩 de acuerdo con su uso. Mas informaci贸n