Actos BORME de Motema Sl
11 de Octubre de 2022Nombramientos. Apoderado: REVERTER GARCIA JOSEP. Datos registrales. T 21864 , F 209, S 8, H M 37938, I/A 56 ( 4.10.22).
11 de Noviembre de 2020Nombramientos. Apoderado: REVERTER GARCIA JOSEP. Datos registrales. T 21864 , F 208, S 8, H M 37938, I/A 55 ( 3.11.20).
15 de Octubre de 2019Nombramientos. Apoderado: BOIX BOIX PABLO. Datos registrales. T 21864 , F 208, S 8, H M 37938, I/A 54 ( 8.10.19).
22 de Abril de 2019Revocaciones. Apoderado: GARCIA JIMENEZ MARIA DELFINA;GRIERA LOPEZ ANTONIO;GARCIA JIMENEZ MARIADELFINA;ARRESE ZABALETA FERNANDO;SANCHEZ SAUGAR MARIA JULIA;REVERTER GARCIA JOSE;GARCIA JIMENEZMARIA DELFINA. Apo.Manc.: GARCIA JIMENEZ MARIA DELFINA;REVERTER GARCIA JOSEP;ARRESE ZABALETAFERNANDO;SANCHEZ SAUGAR MARIA JULIA. Apoderado: CANO ABADIN JESUS;GARCIA JIMENEZ MARIA
Nombramientos. Apo.Man.Soli: REVERTER GARCIA JOSEP;SANCHEZ SAUGAR JULIA;FILIP CORRAL MARIA-ANGELES;SEGURA ALONSO VICENTE. Datos registrales. T 21864 , F 206, S 8, H M 37938, I/A 53 (11.04.19).
30 de Octubre de 2017Nombramientos. Apoderado: BOIX BOIX PABLO. Datos registrales. T 21864 , F 205, S 8, H M 37938, I/A 51 (20.10.17).
29 de Octubre de 2015Nombramientos. Apoderado: BOIX BOIX PABLO. Datos registrales. T 21864 , F 205, S 8, H M 37938, I/A 50 (21.10.15).
21 de Mayo de 2015Ampliaci贸n de capital. Capital: 9.099.861,20 Euros. Resultante Suscrito: 91.724.139,20 Euros. Datos registrales. T 21864 , F 106,S 8, H M 37938, I/A 49 (11.05.15).
06 de Mayo de 2014Reelecciones. Auditor: EDULIS AUDITORES SL. Datos registrales. T 21864 , F 105, S 8, H M 37938, I/A 48 (22.04.14).
30 de Enero de 2014Ampliaci贸n de capital. Capital: 53.300.286,00 Euros. Resultante Suscrito: 82.624.278,00 Euros. Datos registrales. T 21864 , F 104,
14 de Noviembre de 2013Nombramientos. Apoderado: BOIX BOIX PABLO. Datos registrales. T 21864 , F 104, S 8, H M 37938, I/A 46 ( 6.11.13).
14 de Agosto de 2013Modificaciones estatutarias. 22. El cargo de Administrador ser谩 retribuido.. Datos registrales. T 21864 , F 104, S 8, H M 37938, I/A45 ( 2.08.13).
24 de Noviembre de 2011Nombramientos. Apoderado: BOIX BOIX PABLO. Datos registrales. T 21864 , F 103, S 8, H M 37938, I/A 44 (14.11.11).
11 de Abril de 2011Reelecciones. Auditor: EDULIS AUDITORES SL. Datos registrales. T 21864 , F 103, S 8, H M 37938, I/A 43 (30.03.11).
21 de Julio de 2010Reelecciones. Auditor: EDULIS AUDITORES SL. Datos registrales. T 21864 , F 103, S 8, H M 37938, I/A 42 (12.07.10).
01 de Marzo de 2010Nombramientos. Apo.Manc.: REVERTER GARCIA JOSEP;SANCHEZ SAUGAR MARIA JULIA;SANCHEZ GOMEZ ANTONIO.Datos registrales. T 21864 , F 102, S 8, H M 37938, I/A 41 (17.02.10).
19 de Noviembre de 2009Nombramientos. Apo.Manc.: REVERTER GARCIA JOSEP;SANCHEZ SAUGAR MARIA JULIA. Datos registrales. T 21864 , F 100,S 8, H M 37938, I/A 39 ( 5.11.09).
Nombramientos. Apoderado: BOIX BOIX PABLO. Datos registrales. T 21864 , F 101, S 8, H M 37938, I/A 40 ( 5.11.09).
30 de Octubre de 2009Reelecciones. Auditor: EDULIS AUDITORES SL. Datos registrales. T 21864 , F 100, S 8, H M 37938, I/A 38 (20.10.09).