Buscador CIF Logo

Actos BORME Movilizer Spain Sl

驴Quieres acceder a la API de EMPRESAS CIF? Obten la informaci贸n de todas las empresas en tiempo real desde tu plataforma.
Ahora con un 25% de DESCUENTO el primer MES. Quiero la API de EMPRESAS

Logo cabecera Movilizer Spain Sl

Actos BORME Movilizer Spain Sl - B87200580

Tenemos registrados 20 Actos BORME del Registro Mercantil de Madrid para Movilizer Spain Sl con CIF B87200580

馃敊 Perfil de Movilizer Spain Sl
馃洅 Comprar listado completo de Empresas de Madrid

Actos BORME de Movilizer Spain Sl

06 de Junio de 2023
Nombramientos. Apoderado: ALESSI CATERINA. Datos registrales. T 33502 , F 94, S 8, H M 603070, I/A 18 (30.05.23).

Nombramientos. Apo.Manc.: PANDEY PAROMITA;KURUGOVINAKOPPA HANUMARADDI;KUMAR VEERESH;CHANDRAGIRISREENIVASULU;MUTHUKRISHNA SHEELA;KUMAR JAIN RAMESH DINESH;SATHIYAMOORTHY SARAVANARAJ;DUTTARGIRIGIRISHANKAR. Datos registrales. T 44017 , F 71, S 8, H M 603070, I/A 19 (30.05.23).

Revocaciones. Apo.Man.Soli: FERNANDEZ CARNEIRO JOSE-ALBERTO. Apoderado: FERNANDEZ DE CORDOVA YBA脩EZ

22 de Noviembre de 2022
Ceses/Dimisiones. Secretario: EGUIA MORENO JOSE MARIA. VsecrNoConsj: GARCIA FUSTER ALFONSO. Consejero: LORENZOBASSOLS NURIA;ORTEGA CANO FRANCISCO;TRINCHANT BLASCO CARMEN. Presidente: TRINCHANT BLASCO CARMEN.Nombramientos. Adm. Solid.: LORENZO BASSOLS NURIA;ORTEGA CANO FRANCISCO. Otros conceptos: Cambio del Organode Administraci贸n: Consejo de administraci贸n a Administradores solidarios. Datos registrales. T 33502 , F 94, S 8, H M 603070, I/A16 (15.11.22).

Nombramientos. Apo.Sol.: EGUIA MORENO JOSE MARIA;RIVERA GONZALEZ DE GOR JOSE LUIS;NARANJO GOMEZPAULA;CONTRERAS GARCIA GUILLERMO. Datos registrales. T 33502 , F 94, S 8, H M 603070, I/A 17 (15.11.22).

06 de Septiembre de 2022
Revocaciones. Apo.Manc.: FERNANDEZ CARNEIRO JOSE-ALBERTO. Nombramientos. Apoderado: AYMARD VANESSAJOSEFINA;STAVARACHE CARMEN CATALINA. Datos registrales. T 33502 , F 92, S 8, H M 603070, I/A 14 (30.08.22).

Nombramientos. Apoderado: AYMARD VANESSA JOSEFINA;FERNANDEZ DE CORDOVA YBA脩EZ AYMAR;BELENGUERFERNANDEZ CRISTINA. Datos registrales. T 33502 , F 93, S 8, H M 603070, I/A 15 (30.08.22).

05 de Septiembre de 2022
Ceses/Dimisiones. SecreNoConsj: IRIBAS POHER MARIA BLANCA. Consejero: FERNANDEZ CARNEIRO JOSE-ALBERTO.Presidente: FERNANDEZ CARNEIRO JOSE-ALBERTO. Nombramientos. Secretario: EGUIA MORENO JOSE MARIA. Consejero:TRINCHANT BLASCO CARMEN. Presidente: TRINCHANT BLASCO CARMEN. Cambio de domicilio social. C/ MARIA DEPORTUGAL 1-5 - EDIFICIO 3. OFICINAS P (MADRID). Datos registrales. T 33502 , F 92, S 8, H M 603070, I/A 13 (29.08.22).

22 de Marzo de 2021
Nombramientos. Apo.Sol.: OLOKO NDIANG JESSIE NELSON;BELENGUER FERNANDEZ CRISTINA. Datos registrales. T 33502 ,F 91, S 8, H M 603070, I/A 12 (12.03.21).

20 de Julio de 2020
Revocaciones. Apoderado: CAMPABADAL CASTELLS JORDI. Apo.Manc.: CAMPABADAL CASTELLS JORDI. Apoderado:VANHULLE FRANCK MARC GEORGES. Datos registrales. T 33502 , F 91, S 8, H M 603070, I/A 11 (13.07.20).

13 de Julio de 2020
Ceses/Dimisiones. Consejero: CAMPABADAL CASTELLS JORDI. Nombramientos. Consejero: ORTEGA CANO FRANCISCO.Datos registrales. T 33502 , F 91, S 8, H M 603070, I/A 10 ( 6.07.20).

03 de Febrero de 2020
Revocaciones. Apoderado: MINGUEZ MARTIN NORBERTO. Datos registrales. T 33502 , F 91, S 8, H M 603070, I/A 9 (27.01.20).

05 de Agosto de 2019
Ceses/Dimisiones. SecreNoConsj: ALONSO BARBAS ALICIA. Nombramientos. SecreNoConsj: IRIBAS POHER MARIA BLANCA.VsecrNoConsj: GARCIA FUSTER ALFONSO. Datos registrales. T 33502 , F 90, S 8, H M 603070, I/A 8 (29.07.19).

08 de Octubre de 2018
Revocaciones. Apoderado: MONEO DE BLAS ROMINA. Nombramientos. Apoderado: FERNANDEZ DE CORDOVA YBA脩EZAYMAR;MINGUEZ MARTIN NORBERTO. Datos registrales. T 33502 , F 90, S 8, H M 603070, I/A 7 ( 1.10.18).

21 de Diciembre de 2017
Nombramientos. Apoderado: VANHULLE FRANCK MARC GEORGES. Datos registrales. T 33502 , F 89, S 8, H M 603070, I/A 6(12.12.17).

10 de Abril de 2017
Ceses/Dimisiones. Adm. Unico: ZAMORA PUEYO ALBERTO. Nombramientos. Consejero: FERNANDEZ CARNEIRO JOSE-ALBERTO;LORENZO BASSOLS NURIA;CAMPABADAL CASTELLS JORDI.Presidente: FERNANDEZ CARNEIRO JOSE-ALBERTO.SecreNoConsj: ALONSO BARBAS ALICIA. Apo.Manc.: FERNANDEZ CARNEIRO JOSE-ALBERTO;LORENZO BASSOLSNURIA;CAMPABADAL CASTELLS JORDI.Apo.Man.Soli: FERNANDEZ CARNEIRO JOSE-ALBERTO;FERNANDEZ MENCHEROJOSE MARIA;ORTEGA CANO FRANCISCO. Apoderado: MONEO DE BLAS ROMINA. Otros conceptos: Cambio del Organo deAdministraci贸n: Administrador 煤nico a Consejo de administraci贸n. Datos registrales. T 33502 , F 87, S 8, H M 603070, I/A 4(31.03.17).

Cambio de domicilio social. C/ JOSEFA VALCARCEL 24 (MADRID). Datos registrales. T 33502 , F 89, S 8, H M 603070, I/A 5 (3.04.17).

18 de Junio de 2015
Constituci贸n. Comienzo de operaciones: 28.01.15. Objeto social: REALIZACION DE SERVICIOS DE TRATAMIENTO DE DATOS.Domicilio: PASEO DE LA CASTELLANA 190 1潞 - 2 (MADRID). Capital: 3.000,00 Euros. Declaraci贸n de unipersonalidad. Socio煤nico: MOVILIZER GMBH. Nombramientos. Adm. Unico: CAMPABADAL CASTELLS JORDI. Datos registrales. T 33502 , F 84, S8, H M 603070, I/A 1 (10.06.15).

Ceses/Dimisiones. Adm. Unico: CAMPABADAL CASTELLS JORDI. Nombramientos. Adm. Unico: ZAMORA PUEYO ALBERTO.Datos registrales. T 33502 , F 86, S 8, H M 603070, I/A 2 (10.06.15).

Nombramientos. Apoderado: CAMPABADAL CASTELLS JORDI. Datos registrales. T 33502 , F 86, S 8, H M 603070, I/A 3(10.06.15).

Utilizamos cookies de terceros con finalidades anal铆ticas, de personalizaci贸n, y de publicidad comportamental. Puede configurar ahora el uso de esta tecnolog铆a. Si acepta o contin煤a navegando, consideramos que est谩 de acuerdo con su uso. Mas informaci贸n