Actos BORME de Movilway Sl
26 de Junio de 2015Revocaciones. Auditor: SM AUDITORES SOCIEDAD ANONIMA PROFESIONAL;BAKER TILLY FMAC SOCIEDAD LIMITADAPROFESIONAL. Nombramientos. Auditor: BAKER TILLY FMAC SOCIEDAD LIMITADA PROFESIONAL. Aud.C.Con.: BAKER TILLYFMAC SOCIEDAD LIMITADA PROFESIONAL. Datos registrales. T 27107 , F 221, S 8, H M 488398, I/A 37 (18.06.15).
21 de Febrero de 2014Ceses/Dimisiones. Consejero: BERACHA WUANI MORIS. Presidente: BERACHA WUANI MORIS. Consejero: DIAZGRANADOSMANGLANO DANILO ALFONSO. Vicepresid.: DIAZGRANADOS MANGLANO DANILO ALFONSO. Consejero: BOORD LEONARD.SecreNoConsj: DE MARTIN MU脩OZ JESUS ALBERTO. Nombramientos. Adm. Unico: PAZ LUIS ALBERTO. Modificacionesestatutarias. Cambio del Organo de Administraci贸n: Consejo de administraci贸n a Administrador 煤nico. Datos registrales. T 27107 ,F 221, S 8, H M 488398, I/A 36 (12.02.14).
14 de Enero de 2014Revocaciones. Apo.Sol.: GARCIA NAVARRO JAVIER;SALOMON DAN COHEN. Apoderado: CRASNY ZYMAN ALEJANDRO.Apo.Sol.: RIERA ANDRES JOSE-LUIS;DELGADO GARCIA SANTIAGO;DE MARTIN MU脩OZ JESUS ALBERTO. Datos registrales.T 27107 , F 221, S 8, H M 488398, I/A 35 ( 7.01.14).
26 de Noviembre de 2013Nombramientos. Apo.Sol.: DE MARTIN MU脩OZ JESUS ALBERTO;ANTON HERRERIAS CARMEN;APARICIO ALFAROJAVIER;AYUSO FEIJOO CRISTINA;BAZ VILLORIA FERNANDO. Datos registrales. T 27107 , F 220, S 8, H M 488398, I/A 34(18.11.13).
14 de Noviembre de 2013Revocaciones. Apoderado: DE MARTIN MU脩OZ JESUS ALBERTO. Datos registrales. T 27107 , F 220, S 8, H M 488398, I/A 33 (6.11.13).
07 de Noviembre de 2013Nombramientos. Apo.Sol.: RIERA ANDRES JOSE-LUIS. Datos registrales. T 27107 , F 219, S 8, H M 488398, I/A 32 (29.10.13).
11 de Octubre de 2013Nombramientos. Apoderado: DELLO STROLOGO MORALES AUGUSTO ALEJANDRO. Datos registrales. T 27107 , F 216, S 8, HM 488398, I/A 29 ( 2.10.13).
Nombramientos. Apoderado: DELGADO MARTINEZ ANA BELLA. Datos registrales. T 27107 , F 217, S 8, H M 488398, I/A 30 (3.10.13).
Modificaciones estatutarias. 20. Modificaci贸n del art铆culo 20潞 de los estatutos sociales, relativo a la retribuci贸n de losAdministradores..Art铆culo de los estatutos: 4. Domicilio.-. Cambio de domicilio social. PLAZA DE COLON, N潞 2, PLANTA 15,TORRE I, EDIFICIO (MADRID). Datos registrales. T 27107 , F 218, S 8, H M 488398, I/A 31 ( 4.10.13).
09 de Octubre de 2013Nombramientos. Apoderado: DELGADO GARCIA SANTIAGO. Datos registrales. T 27107 , F 215, S 8, H M 488398, I/A 28(27.09.13).
04 de Octubre de 2013Ceses/Dimisiones. Consejero: SALOMON DAN COHEN. Datos registrales. T 27107 , F 215, S 8, H M 488398, I/A 27 (26.09.13).
08 de Mayo de 2013Revocaciones. Auditor: KPMG AUDITORES SL. Aud.C.Con.: KPMG AUDITORES SL. Nombramientos. Auditor: SM AUDITORESSOCIEDAD ANONIMA PROFESIONAL. Datos registrales. T 27107 , F 214, S 8, H M 488398, I/A 26 (26.04.13).
07 de Mayo de 2013Ceses/Dimisiones. SecreNoConsj: CRASNY ZYMAN ALEJANDRO. VsecrNoConsj: CRASNY SAVIZCKI FELIPE. Consejero:FIKSMAN JEWRESCKY LEON FERNANDO. Con.Delegado: FIKSMAN JEWRESCKY LEON FERNANDO. Nombramientos.SecreNoConsj: DE MARTIN MU脩OZ JESUS ALBERTO. Consejero: BOORD LEONARD. Datos registrales. T 27107 , F 210, S 8, HM 488398, I/A 22 (25.04.13).
Modificaciones estatutarias. 14. Otros.-.21. Otros.-. Datos registrales. T 27107 , F 210, S 8, H M 488398, I/A 23 (25.04.13).
Nombramientos. Apoderado: DE MARTIN MU脩OZ JESUS ALBERTO. Datos registrales. T 27107 , F 211, S 8, H M 488398, I/A 24(25.04.13).
Nombramientos. Apoderado: ALBERTO PAZ LUIS. Datos registrales. T 27107 , F 213, S 8, H M 488398, I/A 25 (25.04.13).
20 de Noviembre de 2012Ampliaci贸n de capital. Capital: 4.363.314,00 Euros. Resultante Suscrito: 12.617.573,00 Euros. Datos registrales. T 27107 , F 209,S 8, H M 488398, I/A 21 ( 6.11.12).
25 de Septiembre de 2012Nombramientos. Apoderado: DELGADO MARTINEZ ANA BELLA. Datos registrales. T 27107 , F 208, S 8, H M 488398, I/A 20(17.09.12).
21 de Septiembre de 2012Ceses/Dimisiones. Consejero: OWENS JOHN V. Datos registrales. T 27107 , F 208, S 8, H M 488398, I/A 18 (10.09.12).
14 de Febrero de 2012Revocaciones. Apo.Sol.: MARTINEZ GUTIERREZ ALEJANDRO. Datos registrales. T 27107 , F 208, S 8, H M 488398, I/A 17 (2.02.12).
22 de Noviembre de 2011Nombramientos. Apo.Sol.: DELGADO GARCIA SANTIAGO. Datos registrales. T 27107 , F 207, S 8, H M 488398, I/A 16 (10.11.11).
05 de Agosto de 2011Ampliaci贸n de capital. Capital: 8.244.259,00 Euros. Resultante Suscrito: 8.254.259,00 Euros. Datos registrales. T 27107 , F 73, S8, H M 488398, I/A 15 (26.07.11).
27 de Junio de 2011Nombramientos. Auditor: KPMG AUDITORES SL. Aud.C.Con.: KPMG AUDITORES SL. Datos registrales. T 27107 , F 72, S 8, H M488398, I/A 14 (14.06.11).
20 de Junio de 2011Ceses/Dimisiones. Consejero: OTERO CERVELA LUIS. Vicepresid.: OTERO CERVELA LUIS. Nombramientos. Vicepresid.:DIAZGRANADOS MANGLANO DANILO ALFONSO. Datos registrales. T 27107 , F 72, S 8, H M 488398, I/A 13 ( 9.06.11).
23 de Mayo de 2011Nombramientos. Consejero: DIAZGRANADOS MANGLANO DANILO ALFONSO. Datos registrales. T 27107 , F 72, S 8, H M488398, I/A 12 (11.05.11).
08 de Abril de 2011Nombramientos. Consejero: OWENS JOHN V. Datos registrales. T 27107 , F 72, S 8, H M 488398, I/A 11 (28.03.11).
16 de Noviembre de 2010Revocaciones. Apo.Sol.: LATTASSA PEDRAZA JUAN CARLOS. Datos registrales. T 27107 , F 71, S 8, H M 488398, I/A 10 (3.11.10).
09 de Julio de 2010Nombramientos. Apo.Sol.: RIERA ANDRES JOSE-LUIS. Datos registrales. T 27107 , F 70, S 8, H M 488398, I/A 9 (29.06.10).
06 de Julio de 2010Nombramientos. Apoderado: CRASNY ZYMAN ALEJANDRO. Datos registrales. T 27107 , F 69, S 8, H M 488398, I/A 8 (24.06.10).
20 de Mayo de 2010Ceses/Dimisiones. Adm. Unico: FIKSMAN JEWRESCKY LEON FERNANDO. Nombramientos. Consejero: BERACHA WUANIMORIS. Presidente: BERACHA WUANI MORIS. Consejero: OTERO CERVELA LUIS. Vicepresid.: OTERO CERVELA LUIS.Consejero: FIKSMAN JEWRESCKY LEON FERNANDO;SALOMON DAN COHEN. SecreNoConsj: CRASNY ZYMAN ALEJANDRO.VsecrNoConsj: CRASNY SAVIZCKI FELIPE. Modificaciones estatutarias. 17. .Cambio del Organo de Administraci贸n:Administrador 煤nico a Consejo de administraci贸n. Datos registrales. T 27107 , F 67, S 8, H M 488398, I/A 6 (10.05.10).
Nombramientos. Con.Delegado: FIKSMAN JEWRESCKY LEON FERNANDO. Datos registrales. T 27107 , F 68, S 8, H M 488398,I/A 7 (10.05.10).
17 de Noviembre de 2009Constituci贸n. Comienzo de operaciones: 9.10.09. Objeto social: LA ADQUISICION, TENENCIA, GESTION Y ADMINISTRACION DEVALORES REPRESENTATIVOS DE LOS FONDOS PROPIOS DE ENTIDADES NO RESIDENTES;. Domicilio: C/ JOSE SILVA 17 1潞(MADRID). Capital: 10.000,00 Euros. Nombramientos. Adm. Unico: FIKSMAN JEWRESCKY LEON FERNANDO. Datosregistrales. T 27107 , F 62, S 8, H M 488398, I/A 1 ( 4.11.09).
Nombramientos. Apo.Sol.: MARTINEZ GUTIERREZ ALEJANDRO. Datos registrales. T 27107 , F 64, S 8, H M 488398, I/A 2 (4.11.09).
Nombramientos. Apo.Sol.: LATTASSA PEDRAZA JUAN CARLOS. Datos registrales. T 27107 , F 64, S 8, H M 488398, I/A 3 (4.11.09).
Nombramientos. Apo.Sol.: GARCIA NAVARRO JAVIER. Datos registrales. T 27107 , F 65, S 8, H M 488398, I/A 4 ( 4.11.09).
Nombramientos. Apo.Sol.: SALOMON DAN COHEN. Datos registrales. T 27107 , F 67, S 8, H M 488398, I/A 5 ( 4.11.09).