Buscador CIF Logo

Actos BORME Muchohotel Sa

驴Quieres acceder a la API de EMPRESAS CIF? Obten la informaci贸n de todas las empresas en tiempo real desde tu plataforma.
Ahora con un 25% de DESCUENTO el primer MES. Quiero la API de EMPRESAS

Logo cabecera Muchohotel Sa

Actos BORME Muchohotel Sa - A63314272

Tenemos registrados 12 Actos BORME del Registro Mercantil de Madrid para Muchohotel Sa con CIF A63314272

馃敊 Perfil de Muchohotel Sa
馃洅 Comprar listado completo de Empresas de Madrid

Actos BORME de Muchohotel Sa

02 de Junio de 2021
Reelecciones. Adm. Unico: LOPEZ SEIJAS AMANCIO. Datos registrales. T 35757 , F 190, S 8, H M 642589, I/A 4 (26.05.21).

05 de Junio de 2018
Revocaciones. Apoderado: GARMENDIA SANZ CARLOS;BARREDO AGRAS ALBERTO;DIEZ GARCIA JOSE MARIA;DIEZ GARCIAJOSE MARIA. Datos registrales. T 35757 , F 189, S 8, H M 642589, I/A 3 (28.05.18).

29 de Mayo de 2017
Cambio de domicilio social. C/ XAURADO 24 (MADRID). Datos registrales. T 35757 , F 189, S 8, H M 642589, I/A 2 (18.05.17).

10 de Marzo de 2017
Cambio de objeto social. LAS ACTIVIDADES PROPIAS DE LAS AGENCIAS DE VIAJES,ESTO ES,LACOMERCIALIZACION,INTERMEDIACION Y ORGANIZACION DE TODA CLASE DE VIAJES,ASI COMO LA PRESTACION DESERVICIOS RELACIONADOS CON LOS MISMOS,DESTINADOS A TODO TIPO ... Datos registrales. T 40585 , F 165, S 8, H B278521, I/A 20 ( 1.03.17).

30 de Septiembre de 2016
Revocaciones. APODERADO: FERNANDEZ VELASCO IGLESIAS JOSE MANUEL. CONSEJERO: LOPEZ SEIJAS AMANCIO.PRESIDENTE: LOPEZ SEIJAS AMANCIO. CONSEJERO: FERNANDEZ VELASCO IGLESIAS JOSE MANUEL. SECRETARIO:FERNANDEZ VELASCO IGLESIAS JOSE MANUEL. CONSEJERO: BARREDO AGRAS ALBERTO. CONS. DELEG.: BARREDOAGRAS ALBERTO. CONSEJERO: TORRENTS VALENTI JOAN. VICESECRET.: TORRENTS VALENTI JOAN. CONSEJERO:FERNANDEZ MU脩IZ JOSE MANUEL;SANJURJO FERNANDEZ ANA MARIA. Nombramientos. ADM.UNICO: LOPEZ SEIJASAMANCIO. Modificaciones estatutarias. MODIFICACION Y REFUNDICION DE LOS ESTATUTOS SOCIALES. CAMBIO DE

28 de Septiembre de 2016
Reducci贸n de capital. Importe reducci贸n: 60.102,00 Euros. Resultante Suscrito: 0,00 Euros. Ampliaci贸n de capital. Suscrito:60.102,00 Euros. Desembolsado: 60.102,00 Euros. Resultante Suscrito: 60.102,00 Euros. Resultante Desembolsado: 60.102,00 Euros.Datos registrales. T 40585 , F 162, S 8, H B 278521, I/A 18 (21.09.16).

31 de Julio de 2012
Revocaciones. CONSEJERO: MAS SUMALLA RAMON. Datos registrales. T 40585 , F 162, S 8, H B 278521, I/A 17 (18.07.12).

28 de Junio de 2012
Nombramientos. CONSEJERO: LOPEZ SEIJAS AMANCIO. PRESIDENTE: LOPEZ SEIJAS AMANCIO. CONSEJERO: FERNANDEZVELASCO IGLESIAS JOSE MANUEL. SECRETARIO: FERNANDEZ VELASCO IGLESIAS JOSE MANUEL. CONSEJERO: BARREDOAGRAS ALBERTO. CONS. DELEG.: BARREDO AGRAS ALBERTO. CONSEJERO: TORRENTS VALENTI JOAN. VICESECRET.:TORRENTS VALENTI JOAN. CONSEJERO: FERNANDEZ MU脩IZ JOSE MANUEL;MAS SUMALLA RAMON;SANJURJOFERNANDEZ ANA MARIA. Datos registrales. T 40585 , F 162, S 8, H B 278521, I/A 16 (19.06.12).

18 de Junio de 2012
Nombramientos. APODERADO: DIEZ GARCIA JOSE MARIA. Datos registrales. T 40585 , F 161, S 8, H B 278521, I/A 15 (6.06.12).

30 de Mayo de 2012
Revocaciones. CONSEJERO: SANCHEZ MARTINEZ JOANA. Nombramientos. CONSEJERO: MAS SUMALLA RAMON. Datosregistrales. T 40585 , F 161, S 8, H B 278521, I/A 14 (18.05.12).

20 de Enero de 2011
Nombramientos. APODERADO: DIEZ GARCIA JOSE MARIA. Datos registrales. T 40585 , F 161, S 8, H B 278521, I/A 13 (7.01.11).

09 de Octubre de 2009
Revocaciones. CONSEJERO: SOMALO PECI脩A IGNACIO. Nombramientos. CONSEJERO: SANCHEZ MARTINEZ JOANA.Datos registrales. T 40585 , F 161, S 8, H B 278521, I/A 12 (29.09.09).

Utilizamos cookies de terceros con finalidades anal铆ticas, de personalizaci贸n, y de publicidad comportamental. Puede configurar ahora el uso de esta tecnolog铆a. Si acepta o contin煤a navegando, consideramos que est谩 de acuerdo con su uso. Mas informaci贸n