Actos BORME de Murcia Emprende Sociedad De Capital Riesgo Sa
13 de Julio de 2022Otros conceptos: MODIFICACION DE LOS ARTICULOS 13 Y 15 DE LOS ESTATUTOS SOCIALES. Datos registrales. T 3457 , F110, S 8, H MU 47397, I/A 71 ( 6.07.22).
01 de Diciembre de 2021Revocaciones. Apo.Man.Soli: DIEGO RODRIGUEZ-LINARES REY. Datos registrales. T 3457 , F 108, S 8, H MU 47397, I/A 66
Nombramientos. Apo.Man.Soli: JOAQUIN GOMEZ GOMEZ. Datos registrales. T 3457 , F 109, S 8, H MU 47397, I/A 67 (24.11.21).
Revocaciones. Apo.Sol.: DIEGO RODRIGUEZ-LINARES REY. Nombramientos. Apo.Sol.: JOAQUIN GOMEZ GOMEZ. Datosregistrales. T 3457 , F 109, S 8, H MU 47397, I/A 68 (24.11.21).
Revocaciones. Apo.Sol.: DIEGO RODRIGUEZ-LINARES REY. Nombramientos. Apo.Sol.: JOAQUIN GOMEZ GOMEZ. Datosregistrales. T 3457 , F 110, S 8, H MU 47397, I/A 69 (24.11.21).
23 de Agosto de 2021Reelecciones. Consejero: INSTITUTO DE FOMENTO DE LA REGION DE MURCIA. Presidente: INSTITUTO DE FOMENTO DE LAREGION DE MURCIA. Datos registrales. T 3457 , F 108, S 8, H MU 47397, I/A 65 (16.08.21).
13 de Noviembre de 2020Reducci贸n de capital. Importe reducci贸n: 2.842.400,00 Euros. Resultante Suscrito: 2.556.800,00 Euros. Datos registrales. T 3457 ,F 108, S 8, H MU 47397, I/A 63 ( 5.11.20).
18 de Septiembre de 2020Reelecciones. Auditor: DELOITTE SL. Datos registrales. T 3336 , F 151, S 8, H MU 47397, I/A 60 (11.09.20).
Revocaciones. Apo.Sol.: JOAQUIN GOMEZ GOMEZ. Nombramientos. Apo.Sol.: DIEGO RODRIGUEZ-LINARES REY. Datosregistrales. T 3336 , F 151, S 8, H MU 47397, I/A 61 (11.09.20).
Revocaciones. Apo.Sol.: JOAQUIN GOMEZ GOMEZ. Nombramientos. Apo.Sol.: DIEGO RODRIGUEZ-LINARES REY. Datosregistrales. T 3336 , F 151, S 8, H MU 47397, I/A 62 (11.09.20).
25 de Junio de 2020Revocaciones. Apo.Man.Soli: JOAQUIN GOMEZ GOMEZ. Nombramientos. Apo.Man.Soli: DIEGO RODRIGUEZ-LINARES REY.Datos registrales. T 3336 , F 150, S 8, H MU 47397, I/A 59 (19.06.20).
16 de Enero de 2020Ceses/Dimisiones. Consejero: PILAR VALERO HUESCAR. Datos registrales. T 3336 , F 150, S 8, H MU 47397, I/A 57 (10.01.20).
27 de Septiembre de 2019Reelecciones. Consejero: CAJAMAR CAJA RURAL SOCIEDAD COOPERATIVA DE CREDITO. Datos registrales. T 3336 , F 150,S 8, H MU 47397, I/A 56 (20.09.19).
06 de Mayo de 2019Reducci贸n de capital. Importe reducci贸n: 1.400.800,00 Euros. Resultante Suscrito: 5.399.200,00 Euros. Datos registrales. T 3336 ,F 150, S 8, H MU 47397, I/A 55 (26.04.19).
09 de Abril de 2019Nombramientos. Apo.Sol.: JOAQUIN GOMEZ GOMEZ;RAMON GOMEZ PEREZ. Datos registrales. T 3336 , F 149, S 8, H MU47397, I/A 52 ( 2.04.19).
Revocaciones. Apo.Manc.: ANGEL MARTINEZ MARTINEZ;ANGEL MARTINEZ MARTINEZ;MANUEL MEDINA MARTINEZ;BENITOJAVIER MERCADER LEON;MANUEL MEDINA MARTINEZ;BENITO JAVIER MERCADER LEON;JUAN HERNANDEZALBARRACIN;MANUEL MEDINA MARTINEZ;BENITO JAVIER MERCADER LEON;JESUS HIDALGO PINTADO. Datos registrales.T 3336 , F 149, S 8, H MU 47397, I/A 53 ( 2.04.19).
Nombramientos. Apo.Sol.: JOAQUIN GOMEZ GOMEZ;MARIA ISABEL DEL REY CARRION. Datos registrales. T 3336 , F 149, S 8,H MU 47397, I/A 54 ( 2.04.19).
28 de Septiembre de 2018Fe de erratas: En la inscripcion 51 se designo por error apoderado a Don Javier Celdran Lorente, no debiendo aparecer dicho se帽orcomo apoderado. Datos registrales. T 3124 , F 130, S 8, H MU 47397, I/A 51 (19.09.18).
Nombramientos. Apo.Man.Soli: JOAQUIN GOMEZ GOMEZ. Datos registrales. T 3124 , F 130, S 8, H MU 47397, I/A 51 (19.09.18).
26 de Septiembre de 2018Ceses/Dimisiones. Consejero: MARIA CASAJUS GALVACHE. Nombramientos. Consejero: PILAR VALERO HUESCAR. Datosregistrales. T 3124 , F 130, S 8, H MU 47397, I/A 49 (19.09.18).
Ceses/Dimisiones. Consejero: BANCO MARE NOSTRUM SA;BANCO DE SABADELL SA. Nombramientos. Consejero:VALORACION Y CONTROL SLU;BANSABADELL INVERSIO DESENVOLUPAMENT SAU. Datos registrales. T 3124 , F 130, S 8, HMU 47397, I/A 50 (19.09.18).
Revocaciones. Apo.Man.Soli: MARIA JOSE BERNAL TORRES;BENITO MERCADER LEON;JAVIER CELDRAN LORENTE.Nombramientos. Apo.Man.Soli: JAVIER CELDRAN LORENTE;MARIA JOSE BERNAL TORRES;RAMON GOMEZ PEREZ. Datosregistrales. T 3124 , F 130, S 8, H MU 47397, I/A 51 (19.09.18).
08 de Marzo de 2018Reelecciones. Auditor: DELOITTE SL. Datos registrales. T 3124 , F 130, S 8, H MU 47397, I/A 47 ( 1.03.18).
20 de Diciembre de 2017Ceses/Dimisiones. Consejero: DANIEL MAZON SANCHEZ. Nombramientos. Consejero: MARIA CASAJUS GALVACHE. Datosregistrales. T 3124 , F 126, S 8, H MU 47397, I/A 45 (13.12.17).