Buscador CIF Logo

Actos BORME Murcia Emprende Sociedad De Capital Riesgo Sa

驴Quieres acceder a la API de EMPRESAS CIF? Obten la informaci贸n de todas las empresas en tiempo real desde tu plataforma.
Ahora con un 25% de DESCUENTO el primer MES. Quiero la API de EMPRESAS

Logo cabecera Murcia Emprende Sociedad De Capital Riesgo Sa

Actos BORME Murcia Emprende Sociedad De Capital Riesgo Sa - A73280786

Tenemos registrados 24 Actos BORME del Registro Mercantil de Murcia para Murcia Emprende Sociedad De Capital Riesgo Sa con CIF A73280786

馃敊 Perfil de Murcia Emprende Sociedad De Capital Riesgo Sa
馃洅 Comprar listado completo de Empresas de Murcia

Actos BORME de Murcia Emprende Sociedad De Capital Riesgo Sa

13 de Julio de 2022
Otros conceptos: MODIFICACION DE LOS ARTICULOS 13 Y 15 DE LOS ESTATUTOS SOCIALES. Datos registrales. T 3457 , F110, S 8, H MU 47397, I/A 71 ( 6.07.22).

01 de Diciembre de 2021
Revocaciones. Apo.Man.Soli: DIEGO RODRIGUEZ-LINARES REY. Datos registrales. T 3457 , F 108, S 8, H MU 47397, I/A 66

Nombramientos. Apo.Man.Soli: JOAQUIN GOMEZ GOMEZ. Datos registrales. T 3457 , F 109, S 8, H MU 47397, I/A 67 (24.11.21).

Revocaciones. Apo.Sol.: DIEGO RODRIGUEZ-LINARES REY. Nombramientos. Apo.Sol.: JOAQUIN GOMEZ GOMEZ. Datosregistrales. T 3457 , F 109, S 8, H MU 47397, I/A 68 (24.11.21).

Revocaciones. Apo.Sol.: DIEGO RODRIGUEZ-LINARES REY. Nombramientos. Apo.Sol.: JOAQUIN GOMEZ GOMEZ. Datosregistrales. T 3457 , F 110, S 8, H MU 47397, I/A 69 (24.11.21).

23 de Agosto de 2021
Reelecciones. Consejero: INSTITUTO DE FOMENTO DE LA REGION DE MURCIA. Presidente: INSTITUTO DE FOMENTO DE LAREGION DE MURCIA. Datos registrales. T 3457 , F 108, S 8, H MU 47397, I/A 65 (16.08.21).

13 de Noviembre de 2020
Reducci贸n de capital. Importe reducci贸n: 2.842.400,00 Euros. Resultante Suscrito: 2.556.800,00 Euros. Datos registrales. T 3457 ,F 108, S 8, H MU 47397, I/A 63 ( 5.11.20).

18 de Septiembre de 2020
Reelecciones. Auditor: DELOITTE SL. Datos registrales. T 3336 , F 151, S 8, H MU 47397, I/A 60 (11.09.20).

Revocaciones. Apo.Sol.: JOAQUIN GOMEZ GOMEZ. Nombramientos. Apo.Sol.: DIEGO RODRIGUEZ-LINARES REY. Datosregistrales. T 3336 , F 151, S 8, H MU 47397, I/A 61 (11.09.20).

Revocaciones. Apo.Sol.: JOAQUIN GOMEZ GOMEZ. Nombramientos. Apo.Sol.: DIEGO RODRIGUEZ-LINARES REY. Datosregistrales. T 3336 , F 151, S 8, H MU 47397, I/A 62 (11.09.20).

25 de Junio de 2020
Revocaciones. Apo.Man.Soli: JOAQUIN GOMEZ GOMEZ. Nombramientos. Apo.Man.Soli: DIEGO RODRIGUEZ-LINARES REY.Datos registrales. T 3336 , F 150, S 8, H MU 47397, I/A 59 (19.06.20).

16 de Enero de 2020
Ceses/Dimisiones. Consejero: PILAR VALERO HUESCAR. Datos registrales. T 3336 , F 150, S 8, H MU 47397, I/A 57 (10.01.20).

27 de Septiembre de 2019
Reelecciones. Consejero: CAJAMAR CAJA RURAL SOCIEDAD COOPERATIVA DE CREDITO. Datos registrales. T 3336 , F 150,S 8, H MU 47397, I/A 56 (20.09.19).

06 de Mayo de 2019
Reducci贸n de capital. Importe reducci贸n: 1.400.800,00 Euros. Resultante Suscrito: 5.399.200,00 Euros. Datos registrales. T 3336 ,F 150, S 8, H MU 47397, I/A 55 (26.04.19).

09 de Abril de 2019
Nombramientos. Apo.Sol.: JOAQUIN GOMEZ GOMEZ;RAMON GOMEZ PEREZ. Datos registrales. T 3336 , F 149, S 8, H MU47397, I/A 52 ( 2.04.19).

Revocaciones. Apo.Manc.: ANGEL MARTINEZ MARTINEZ;ANGEL MARTINEZ MARTINEZ;MANUEL MEDINA MARTINEZ;BENITOJAVIER MERCADER LEON;MANUEL MEDINA MARTINEZ;BENITO JAVIER MERCADER LEON;JUAN HERNANDEZALBARRACIN;MANUEL MEDINA MARTINEZ;BENITO JAVIER MERCADER LEON;JESUS HIDALGO PINTADO. Datos registrales.T 3336 , F 149, S 8, H MU 47397, I/A 53 ( 2.04.19).

Nombramientos. Apo.Sol.: JOAQUIN GOMEZ GOMEZ;MARIA ISABEL DEL REY CARRION. Datos registrales. T 3336 , F 149, S 8,H MU 47397, I/A 54 ( 2.04.19).

28 de Septiembre de 2018
Fe de erratas: En la inscripcion 51 se designo por error apoderado a Don Javier Celdran Lorente, no debiendo aparecer dicho se帽orcomo apoderado. Datos registrales. T 3124 , F 130, S 8, H MU 47397, I/A 51 (19.09.18).

Nombramientos. Apo.Man.Soli: JOAQUIN GOMEZ GOMEZ. Datos registrales. T 3124 , F 130, S 8, H MU 47397, I/A 51 (19.09.18).

26 de Septiembre de 2018
Ceses/Dimisiones. Consejero: MARIA CASAJUS GALVACHE. Nombramientos. Consejero: PILAR VALERO HUESCAR. Datosregistrales. T 3124 , F 130, S 8, H MU 47397, I/A 49 (19.09.18).

Ceses/Dimisiones. Consejero: BANCO MARE NOSTRUM SA;BANCO DE SABADELL SA. Nombramientos. Consejero:VALORACION Y CONTROL SLU;BANSABADELL INVERSIO DESENVOLUPAMENT SAU. Datos registrales. T 3124 , F 130, S 8, HMU 47397, I/A 50 (19.09.18).

Revocaciones. Apo.Man.Soli: MARIA JOSE BERNAL TORRES;BENITO MERCADER LEON;JAVIER CELDRAN LORENTE.Nombramientos. Apo.Man.Soli: JAVIER CELDRAN LORENTE;MARIA JOSE BERNAL TORRES;RAMON GOMEZ PEREZ. Datosregistrales. T 3124 , F 130, S 8, H MU 47397, I/A 51 (19.09.18).

08 de Marzo de 2018
Reelecciones. Auditor: DELOITTE SL. Datos registrales. T 3124 , F 130, S 8, H MU 47397, I/A 47 ( 1.03.18).

20 de Diciembre de 2017
Ceses/Dimisiones. Consejero: DANIEL MAZON SANCHEZ. Nombramientos. Consejero: MARIA CASAJUS GALVACHE. Datosregistrales. T 3124 , F 126, S 8, H MU 47397, I/A 45 (13.12.17).

Utilizamos cookies de terceros con finalidades anal铆ticas, de personalizaci贸n, y de publicidad comportamental. Puede configurar ahora el uso de esta tecnolog铆a. Si acepta o contin煤a navegando, consideramos que est谩 de acuerdo con su uso. Mas informaci贸n