Buscador CIF Logo

Actos BORME Mutualidad De Prevision Social De Asisa Dr Atilano Cerezo

驴Quieres acceder a la API de EMPRESAS CIF? Obten la informaci贸n de todas las empresas en tiempo real desde tu plataforma.
Ahora con un 25% de DESCUENTO el primer MES. Quiero la API de EMPRESAS

Logo cabecera Mutualidad De Prevision Social De Asisa Dr Atilano Cerezo

Actos BORME Mutualidad De Prevision Social De Asisa Dr Atilano Cerezo - G78022142

Tenemos registrados 46 Actos BORME del Registro Mercantil de Madrid para Mutualidad De Prevision Social De Asisa Dr Atilano Cerezo con CIF G78022142

馃敊 Perfil de Mutualidad De Prevision Social De Asisa Dr Atilano Cerezo
馃洅 Comprar listado completo de Empresas de Madrid

Actos BORME de Mutualidad De Prevision Social De Asisa Dr Atilano Cerezo

27 de Noviembre de 2023
Revocaciones. Apo.Sol.: RAZQUIN ILLARRAMENDI PEDRO;RODRIGUEZ-VILLA MATONS ANDRES;CABALLERO CABALLEROMARIANO;DELGADO SORIA MARIO. Apo.Manc.: RAZQUIN ILLARRAMENDI PEDRO;RODRIGUEZ-VILLA MATONSANDRES;CABALLERO CABALLERO MARIANO;DELGADO SORIA MARIO. Nombramientos. Apo.Man.Soli: DE PORRES ORTIZDE URBINA ENRIQUE;RODRIGUEZ VILLA MATONS ANDRES;CABALLERO CABALLERO MARIANO;GARCIA CALLELAURA;RAZQUIN ILLARRAMENDI PEDRO;HERNANDEZ MORENO-VENTAS RAUL. Datos registrales. T 35326 , F 220, S 8, H M77182, I/A 64 (21.11.23).

03 de Noviembre de 2023
Nombramientos. Consejero: ANGUITA ANGUITA FRANCISCO. Reelecciones. Miem.J.Rec: CAYRASSO IGLESIASJORGE;MAYERO FRANCO LUIS. Vic.Junt.Rec: CAYRASSO IGLESIAS JORGE. Miem.J.Rec: RAZQUIN ILLARRAMENDI PEDRO.Datos registrales. T 35326 , F 219, S 8, H M 77182, I/A 62 (26.10.23).

Reelecciones. Auditor: DELOITTE SL. Datos registrales. T 35326 , F 220, S 8, H M 77182, I/A 63 (26.10.23).

26 de Septiembre de 2023
Reelecciones. Auditor: DELOITTE SL. Datos registrales. T 35326 , F 218, S 8, H M 77182, I/A 61 (19.09.23).

04 de Septiembre de 2023
Fe de erratas: Se public贸 por error en las inscripciones 57陋 y 58陋 varios consejeros y un secretario, siendo en todos los casosMiembros de la Junta Rectora y Secretario de la Junta Rectora. Datos registrales. T 35326 , F 211, S 8, H M 77182, I/A 57(25.03.22).

Ceses/Dimisiones. Vicepresid.: SOLVAS MARTINEZ ANTONIA. Fe de erratas: Se omiti贸 por error en la inscripci贸n 60陋 lapublicaci贸n del cese de SOLVAS MARTINEZ ANTONIA como vicepresidenta. Datos registrales. T 35326 , F 218, S 8, H M 77182, I/A60 (24.08.23).

31 de Agosto de 2023
Ceses/Dimisiones. Presidente: VILAR MARTINEZ GERARDO. Miem.J.Rec: ALCALDE GOMEZ MARIA DOLORES. Consejero:RODRIGUEZ CORRALES MARIA LUISA;VILAR MARTINEZ GERARDO. Cancelaciones de oficio de nombramientos. Consejero:AGUDO BENITO ALBERTO. Nombramientos. Miem.J.Rec: ALCALDE GOMEZ MARIA DOLORES. Vic.Junt.Rec: CAYRASSOIGLESIAS JORGE. Miem.J.Rec: VILAR MARTINEZ GERARDO;RODRIGUEZ CORRALES MARIA LUISA;SOLVAS MARTINEZANTONIA;RAZQUIN ILLARRAMENDI PEDRO. Pres.J.Rec: SOLVAS MARTINEZ ANTONIA. Miem.J.Rec: MAESTRO MARTINEZLUIS. Datos registrales. T 35326 , F 218, S 8, H M 77182, I/A 60 (24.08.23).

12 de Diciembre de 2022
Revocaciones. Apo.Man.Soli: ALCALDE GOMEZ MARIA DOLORES. Apo.Manc.: IVORRA MIRALLES FRANCISCO;SOLVASMARTINEZ ANTONIA;DE PORRES ORTIZ DE URBINA ENRIQUE. Apoderado: SORIA FERNANDEZ DE CORDOBAMANUEL;RODRIGUEZ-VILLA MATONS ANDRES;CABALLERO CABALLERO MARIANO;ALCALDE GOMEZ MARIADOLORES;DELGADO SORIA MARIO. Apo.Manc.: ALCALDE GOMEZ MARIA DOLORES. Nombramientos. Apo.Sol.: RAZQUINILLARRAMENDI PEDRO;RODRIGUEZ-VILLA MATONS ANDRES;CABALLERO CABALLERO MARIANO;DELGADO SORIA MARIO.Apo.Manc.: RAZQUIN ILLARRAMENDI PEDRO;RODRIGUEZ-VILLA MATONS ANDRES;CABALLERO CABALLEROMARIANO;DELGADO SORIA MARIO. Datos registrales. T 35326 , F 217, S 8, H M 77182, I/A 59 ( 1.12.22).

13 de Mayo de 2022
Cancelaciones de oficio de nombramientos. Consejero: SOLVAS MARTINEZ ANTONIA. Datos registrales. T 35326 , F 206, S 8,H M 77182, I/A 50M ( 6.05.22).

Cancelaciones de oficio de nombramientos. Consejero: MOYA RUBIO INMACULADA. Datos registrales. T 35326 , F 205, S 8, HM 77182, I/A 47M ( 6.05.22).

01 de Abril de 2022
Reelecciones. Consejero: CAYRASSO IGLESIAS JORGE;MAYERO FRANCO LUIS. Modificaciones estatutarias. MODIFICADOSLOS ARTICULOS 9, 12, 25,27,28,31 Y 45 DE LOS ESTATUTOS SOCIALES.. Datos registrales. T 35326 , F 211, S 8, H M 77182,I/A 57 (25.03.22).

Reelecciones. Consejero: IVORRA MIRALLES FRANCISCO. Vicepresid.: SOLVAS MARTINEZ ANTONIA. Consejero: COLMENEROCOLMENERO JOSE MANUEL. Secretario: MOYA RUBIO INMACULADA. Datos registrales. T 35326 , F 216, S 8, H M 77182, I/A 58(25.03.22).

12 de Abril de 2021
Reelecciones. Consejero: VILAR MARTINEZ GERARDO. Fe de erratas: Se omiti贸 por error en la inscripci贸n 52陋 la publicaci贸n de lareelecci贸n de VILAR MARTINEZ GERARDO como consejero. Datos registrales. T 35326 , F 206, S 8, H M 77182, I/A 52 (30.12.19).

06 de Abril de 2021
Nombramientos. Apo.Man.Soli: RAZQUIN ILLARRAMENDI PEDRO. Apo.Manc.: DE PORRES ORTIZ DE URBINAENRIQUE;CABALLERO CABALLERO MARIANO;ALCALDE GOMEZ MARIA DOLORES. Datos registrales. T 35326 , F 209, S 8, HM 77182, I/A 56 (26.03.21).

01 de Diciembre de 2020
Nombramientos. Apoderado: SORIA FERNANDEZ DE CORDOBA MANUEL;RODRIGUEZ-VILLA MATONS ANDRES;CABALLEROCABALLERO MARIANO;ALCALDE GOMEZ MARIA DOLORES;DELGADO SORIA MARIO. Datos registrales. T 35326 , F 208, S 8,H M 77182, I/A 55 (24.11.20).

21 de Agosto de 2020
Nombramientos. Apoderado: RIVERA GONZALEZ MARTIN. Datos registrales. T 35326 , F 207, S 8, H M 77182, I/A 54 (14.08.20).

28 de Enero de 2020
Nombramientos. Auditor: DELOITTE S.L. Datos registrales. T 35326 , F 207, S 8, H M 77182, I/A 53 (21.01.20).

10 de Enero de 2020
Ceses/Dimisiones. Presidente: VILAR MARTINEZ GERARDO. Secretario: GIMENO MENENDEZ JUAN RAMON. Nombramientos.Presidente: VILAR MARTINEZ GERARDO. Secretario: MOYA RUBIO INMACULADA. Reelecciones. Secretario: GIMENOMENENDEZ JUAN RAMON. Consejero: RODRIGUEZ CORRALES MARIA LUISA;AGUDO BENITO ALBERTO. Datos registrales. T35326 , F 206, S 8, H M 77182, I/A 52 (30.12.19).

18 de Octubre de 2018
Reelecciones. Auditor: PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES SL. Datos registrales. T 35326 , F 206, S 8, H M 77182, I/A51 (10.10.18).

01 de Agosto de 2018
Reelecciones. Consejero: IVORRA MIRALLES FRANCISCO. Vicepresid.: SOLVAS MARTINEZ ANTONIA. Consejero: COLMENEROCOLMENERO JOSE MANUEL;SOLVAS MARTINEZ ANTONIA. Datos registrales. T 35326 , F 206, S 8, H M 77182, I/A 50(25.07.18).

04 de Mayo de 2018
Nombramientos. Apoderado: RIVERA GONZALEZ MARTIN. Datos registrales. T 35326 , F 205, S 8, H M 77182, I/A 49 (25.04.18).

20 de Febrero de 2018
Reelecciones. Auditor: PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES SL. Datos registrales. T 35326 , F 205, S 8, H M 77182, I/A48 (13.02.18).

16 de Enero de 2018
Reelecciones. Consejero: CAYRASSO IGLESIAS JORGE;MOYA RUBIO INMACULADA;MAYERO FRANCO LUIS. Datosregistrales. T 35326 , F 205, S 8, H M 77182, I/A 47 ( 5.01.18).

26 de Diciembre de 2017
Nombramientos. Consejero: VILAR MARTINEZ GERARDO. Presidente: VILAR MARTINEZ GERARDO. Otros conceptos:Ratificaci贸n como Presidente de la Junta Rectora de la Mutualidad a Don Gerardo Vilar Mart铆nez. Datos registrales. T 35326 , F 204,S 8, H M 77182, I/A 46 (14.12.17).

04 de Octubre de 2017
Revocaciones. Apo.Manc.: TIRADO GUALLART JESUS. Datos registrales. T 35326 , F 204, S 8, H M 77182, I/A 45 (26.09.17).

18 de Agosto de 2017
Revocaciones. Apo.Sol.: NAVARRO MERINO LUIS. Datos registrales. T 35326 , F 204, S 8, H M 77182, I/A 44 ( 4.08.17).

26 de Abril de 2017
Fe de erratas: SE PUBLICO POR ERROR EN LA INSCRIPCION 41潞 LA FE DE ERRATAS EN DONDE SE LEE CONSEJERODELEGADO, DEBE LEERSE CONSEJERO. Datos registrales. T 31345 , F 220, S 8, H M 77182, I/A 41 (22.09.15).

06 de Febrero de 2017
Reelecciones. Auditor: PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES SL. Datos registrales. T 35326 , F 204, S 8, H M 77182, I/A43 (26.01.17).

12 de Diciembre de 2016
Ceses/Dimisiones. Consejero: BENEDI MATA ALEJANDRO. Secretario: BENEDI MATA ALEJANDRO. Consejero: VILARMARTINEZ GERARDO. Presidente: VILAR MARTINEZ GERARDO. Nombramientos. Secretario: GIMENO MENENDEZ JUANRAMON. Reelecciones. Consejero: RODRIGUEZ CORRALES MARIA LUISA;AGUDO BENITO ALBERTO;GIMENO MENENDEZJUAN RAMON. Modificaciones estatutarias. Nuevo texto de los Estatutos sociales.. Datos registrales. T 31345 , F 221, S 8, H M77182, I/A 42 (30.11.16).

10 de Octubre de 2016
Nombramientos. Con.Delegado: SOLVAS MARTINEZ ANTONIA. Fe de erratas: SE OMITIO POR ERROR EN LA INSCRIPCION41陋 LA PUBLICACION DEL NOMBRAMIENTO DE SOLVAS MARTINEZ ANTONIA COMO CONSEJERA DELEGADA. Datosregistrales. T 31345 , F 220, S 8, H M 77182, I/A 41 (22.09.15).

30 de Septiembre de 2015
Reelecciones. Consejero: IVORRA MIRALLES FRANCISCO. Vicepresid.: SOLVAS MARTINEZ ANTONIA. Consejero: COLMENEROCOLMENERO JOSE MANUEL. Datos registrales. T 31345 , F 220, S 8, H M 77182, I/A 41 (22.09.15).

24 de Octubre de 2014
Revocaciones. Apoderado: ALONSO GIL JOSE LUIS. Apo.Manc.: ALONSO GIL JOSE LUIS. Nombramientos. Presidente: VILARMARTINEZ GERARDO. Apoderado: VILAR MARTINEZ GERARDO. Datos registrales. T 31345 , F 219, S 8, H M 77182, I/A 40(16.10.14).

03 de Septiembre de 2014
Ceses/Dimisiones. Consejero: ALONSO GIL JOSE LUIS. Presidente: ALONSO GIL JOSE LUIS. Nombramientos. Consejero:MAYERO FRANCO LUIS. Reelecciones. Consejero: CAYRASSO IGLESIAS JORGE;MOYA RUBIO INMACULADA. Datosregistrales. T 31345 , F 219, S 8, H M 77182, I/A 39 (27.08.14).

26 de Junio de 2014
Otros conceptos: RECTIFICACION DEL ARTICULADO LOS ESTATUTOS SOCIALES QUE CAUSARON LA INSCRIPCION 26 DELA HOJA DE LA SOCIEDAD. Datos registrales. T 31345 , F 215, S 8, H M 77182, I/A 38 (17.06.14).

04 de Abril de 2014
Otros conceptos: SE MODIFICA EL DOMICILIO SOCIAL QUE PASA A SER DEL NUMERO 10 AL NUMERO 12, SIN QUE ELLOCONLLEVE TRASLADO FISICO, POR TRATARSE DE UN MERO CAMBIO FORMAL DEL NUMERO DE POLICIA POR IMPOSICIONMUNICIPAL. Datos registrales. T 31345 , F 214, S 8, H M 77182, I/A 37 (27.03.14).

18 de Marzo de 2014
Revocaciones. Apoderado: DIEZ PASO TOMAS;DIEZ PASO TOMAS. Nombramientos. Apo.Man.Soli: ALCALDE GOMEZ MARIADOLORES. Apo.Manc.: IVORRA MIRALLES FRANCISCO;ALONSO GIL JOSE LUIS;SOLVAS MARTINEZ ANTONIA;DE PORRESORTIZ DE URBINA ENRIQUE. Apo.Sol.: NAVARRO MERINO LUIS. Apo.Manc.: TIRADO GUALLART JESUS. Datos registrales. T31345 , F 210, S 8, H M 77182, I/A 36 (10.03.14).

20 de Febrero de 2014
Reelecciones. Auditor: PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES SL. Datos registrales. T 31345 , F 209, S 8, H M 77182, I/A35 (13.02.14).

21 de Octubre de 2013
Reelecciones. Consejero: RODRIGUEZ CORRALES MARIA LUISA;BENEDI MATA ALEJANDRO;AGUDO BENITOALBERTO;GIMENO MENENDEZ JUAN RAMON. Secretario: BENEDI MATA ALEJANDRO. Datos registrales. T 31345 , F 209, S 8,H M 77182, I/A 34 (14.10.13).

09 de Septiembre de 2013
Nombramientos. Apoderado: DE PORRES ORTIZ DE URBINA ENRIQUE;DIEZ PASO TOMAS;ALBERT LUQUE JUAN. Datosregistrales. T 12827 , F 225, S 8, H M 77182, I/A 33 (30.08.13).

26 de Septiembre de 2012
Reelecciones. Consejero: IVORRA MIRALLES FRANCISCO;SOLVAS MARTINEZ ANTONIA;VILAR MARTINEZ GERARDO.Vicepresid.: SOLVAS MARTINEZ ANTONIA. Consejero: COLMENERO COLMENERO JOSE MANUEL. Datos registrales. T 12827 ,F 224, S 8, H M 77182, I/A 32 (17.09.12).

03 de Abril de 2012
Nombramientos. Auditor: PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES SL. Datos registrales. T 12827 , F 224, S 8, H M 77182,I/A 31 (22.03.12).

28 de Marzo de 2012
Ceses/Dimisiones. Consejero: CONCEPCION GUERRA CELESTINO. Nombramientos. Consejero: CAYRASSO IGLESIASJORGE. Reelecciones. Consejero: MOYA RUBIO INMACULADA;ALONSO GIL JOSE LUIS. Presidente: ALONSO GIL JOSE LUIS.Datos registrales. T 12827 , F 224, S 8, H M 77182, I/A 30 (16.03.12).

27 de Marzo de 2012
Nombramientos. Consejero: COLMENERO COLMENERO JOSE MANUEL. Reelecciones. Consejero: IVORRA MIRALLESFRANCISCO;SOLVAS MARTINEZ ANTONIA;VILAR MARTINEZ GERARDO. Vicepresid.: SOLVAS MARTINEZ ANTONIA. Datosregistrales. T 12827 , F 223, S 8, H M 77182, I/A 29 (15.03.12).

09 de Diciembre de 2011
Reelecciones. Consejero: RODRIGUEZ CORRALES MARIA LUISA;BENEDI MATA ALEJANDRO;AGUDO BENITOALBERTO;GIMENO MENENDEZ JUAN RAMON. Secretario: BENEDI MATA ALEJANDRO. Datos registrales. T 12827 , F 223, S 8,H M 77182, I/A 28 (25.11.11).

12 de Marzo de 2010
Reelecciones. Auditor: DELOITTE SL. Datos registrales. T 12827 , F 222, S 8, H M 77182, I/A 27 ( 2.03.10).

22 de Febrero de 2010
Modificaciones estatutarias. 10. INGRESOS DE MUTUALISTAS. 13. BAJA DE LOS SOCIOS PUNTO1. 14. REINGRESOS. Otrosconceptos: REFUNDICION DE ESTATUTOS. Datos registrales. T 12827 , F 209, S 8, H M 77182, I/A 26 (10.02.10).

Utilizamos cookies de terceros con finalidades anal铆ticas, de personalizaci贸n, y de publicidad comportamental. Puede configurar ahora el uso de esta tecnolog铆a. Si acepta o contin煤a navegando, consideramos que est谩 de acuerdo con su uso. Mas informaci贸n