Buscador CIF Logo

Actos BORME Mvci Playa Andaluza Holidays Sl

驴Quieres acceder a la API de EMPRESAS CIF? Obten la informaci贸n de todas las empresas en tiempo real desde tu plataforma.
Ahora con un 25% de DESCUENTO el primer MES. Quiero la API de EMPRESAS

Logo cabecera Mvci Playa Andaluza Holidays Sl

Actos BORME Mvci Playa Andaluza Holidays Sl - B92167188

Tenemos registrados 44 Actos BORME del Registro Mercantil de Malaga para Mvci Playa Andaluza Holidays Sl con CIF B92167188

馃敊 Perfil de Mvci Playa Andaluza Holidays Sl
馃洅 Comprar listado completo de Empresas de Malaga

Actos BORME de Mvci Playa Andaluza Holidays Sl

18 de Octubre de 2023
Reelecciones. Auditor: DELOITTE SL. Datos registrales. T 5212, L 4119, F 176, S 8, H MA 44312, I/A 71 (11.10.23).

29 de Mayo de 2023
Nombramientos. Apoderado: KADDOURA HASSAN. Datos registrales. T 5212, L 4119, F 176, S 8, H MA 44312, I/A 69 (18.05.23).

Nombramientos. Apoderado: GOYZUETA ESCOBAR CARLA PATRICIA. Datos registrales. T 5212, L 4119, F 176, S 8, H MA44312, I/A 70 (18.05.23).

24 de Octubre de 2022
Reelecciones. Auditor: DELOITTE SL. Datos registrales. T 5212, L 4119, F 175, S 8, H MA 44312, I/A 68 (11.10.22).

20 de Julio de 2022
Nombramientos. Apoderado: VAZQUEZ SANTIAGO DAVID VICENTE. Datos registrales. T 5212, L 4119, F 175, S 8, H MA 44312,I/A 67 (11.07.22).

13 de Junio de 2022
Reelecciones. Auditor: DELOITTE SL. Datos registrales. T 5212, L 4119, F 175, S 8, H MA 44312, I/A 66 ( 1.06.22).

21 de Marzo de 2022
Nombramientos. Apoderado: SADOUDI FAYCAL. Datos registrales. T 5212, L 4119, F 175, S 8, H MA 44312, I/A 65 (10.03.22).

24 de Noviembre de 2020
Reelecciones. Auditor: DELOITTE SL. Datos registrales. T 5212, L 4119, F 175, S 8, H MA 44312, I/A 64 (10.11.20).

22 de Octubre de 2019
Reelecciones. Auditor: DELOITTE SL. Datos registrales. T 5212, L 4119, F 174, S 8, H MA 44312, I/A 63 (10.10.19).

15 de Octubre de 2019
Nombramientos. Apoderado: GUERRERO DE LA ROSA MARIA TERESA. Datos registrales. T 5212, L 4119, F 174, S 8, H MA44312, I/A 62 ( 4.10.19).

14 de Agosto de 2019
Nombramientos. Apoderado: ASHLEY JONATHAN TODD. Datos registrales. T 5212, L 4119, F 174, S 8, H MA 44312, I/A 61 (6.08.19).

21 de Febrero de 2019
Nombramientos. Apoderado: KEATS JULIA ROSA. Datos registrales. T 5212, L 4119, F 174, S 8, H MA 44312, I/A 60 ( 8.02.19).

14 de Enero de 2019
Reelecciones. Auditor: DELOITTE SL. Datos registrales. T 5212, L 4119, F 174, S 8, H MA 44312, I/A 59 ( 2.01.19).

07 de Noviembre de 2018
Nombramientos. Apoderado: VAN GORP MICHIEL CHARLES THEODORUS CORNELIS. Datos registrales. T 5212, L 4119, F173, S 8, H MA 44312, I/A 58 (25.10.18).

17 de Octubre de 2018
Ceses/Dimisiones. Adm. Solid.: RYAN DONALD RANCE. Nombramientos. Adm. Solid.: LOONEY DENIS. Datos registrales. T5212, L 4119, F 173, S 8, H MA 44312, I/A 57 ( 8.10.18).

04 de Enero de 2018
Reelecciones. Auditor: DELOITTE SL. Datos registrales. T 5212, L 4119, F 173, S 8, H MA 44312, I/A 56 (22.12.17).

10 de Marzo de 2017
Nombramientos. Apoderado: ACEVEDO OMAR. Datos registrales. T 5212, L 4119, F 172, S 8, H MA 44312, I/A 55 ( 2.03.17).

22 de Agosto de 2016
Reelecciones. Auditor: DELOITTE SL. Datos registrales. T 5212, L 4119, F 172, S 8, H MA 44312, I/A 54 (11.08.16).

14 de Marzo de 2016
Revocaciones. Apo.Manc.: AZZOLINI FRANCESCO. Nombramientos. Apoderado: AUTIELLO DANIEL ANTHONY. Datosregistrales. T 5212, L 4119, F 172, S 8, H MA 44312, I/A 53 ( 4.03.16).

07 de Diciembre de 2015
Nombramientos. Apoderado: LUYPAERTS SERGE. Datos registrales. T 5212, L 4119, F 172, S 8, H MA 44312, I/A 52 (26.11.15).

02 de Noviembre de 2015
Reelecciones. Auditor: DELOITTE SL. Datos registrales. T 5212, L 4119, F 171, S 8, H MA 44312, I/A 51 (21.10.15).

25 de Junio de 2015
Nombramientos. Apo.Sol.: MEEMKEN SIEGMAR WILHELM;SARRION GILLIAN JOANNES;COPPACCHIOLI GAIA LIVIA. Datosregistrales. T 5212, L 4119, F 171, S 8, H MA 44312, I/A 50 (17.06.15).

03 de Marzo de 2015
Revocaciones. Apoderado: KERFOOT WILLIAM MICHAEL. Datos registrales. T 5212, L 4119, F 171, S 8, H MA 44312, I/A 48(19.02.15).

Nombramientos. Apo.Sol.: AZZOLINI FRANCESCO;HARRISON MADRIAN MARK. Datos registrales. T 5212, L 4119, F 171, S 8, HMA 44312, I/A 49 (19.02.15).

06 de Febrero de 2015
Reelecciones. Adm. Solid.: DOWLING LEE ANTONY;RYAN DONALD RANCE. Modificaciones estatutarias. 14. Administraci贸n yRepresentacion.-. Datos registrales. T 5212, L 4119, F 170, S 8, H MA 44312, I/A 46 (28.01.15).

Reelecciones. Auditor: DELOITTE SL. Datos registrales. T 5212, L 4119, F 170, S 8, H MA 44312, I/A 47 (28.01.15).

04 de Junio de 2014
Nombramientos. Apo.Sol.: GUERRERO DE LA ROSA MARIA TERESA. Datos registrales. T 5212, L 4119, F 169, S 8, H MA44312, I/A 43 (26.05.14).

Nombramientos. Apo.Sol.: CARRILLO JIMENEZ NURIA. Datos registrales. T 5212, L 4119, F 169, S 8, H MA 44312, I/A 44(26.05.14).

Nombramientos. Apo.Sol.: VAN GORP MICHIEL CHARLES THEODORUS CORNELIS. Datos registrales. T 5212, L 4119, F 169, S8, H MA 44312, I/A 45 (26.05.14).

07 de Enero de 2014
Reelecciones. Auditor: DELOITTE SL. Datos registrales. T 5212, L 4119, F 169, S 8, H MA 44312, I/A 42 (26.12.13).

11 de Diciembre de 2013
Nombramientos. Apo.Manc.: DOWLING LEE ANTONY;CROCOCK DECLAN JOSEPH;PLANA RUIZ JOSE MANUEL;GIBBKATHERINE;FULTON BEVERLY ANNE;NEVILLE JOHN DANIEL;RUIZ LUNA CRISTINA;BARBER JEANNIE;STRAND ANNA SOFIAEVA KAROLINA;SPAHIC KAREN MARIE;AZZOLINI FRANCESCO. Datos registrales. T 4574, L 3482, F 178, S 8, H MA 44312, I/A41 ( 2.12.13).

22 de Octubre de 2013
Nombramientos. Apo.Sol.: PLANA RUIZ JOSE MANUEL;DOWLING LEE ANTONY. Datos registrales. T 4574, L 3482, F 178, S 8,H MA 44312, I/A 40 (14.10.13).

21 de Marzo de 2013
Reelecciones. Auditor: DELOITTE SL. Datos registrales. T 4574, L 3482, F 178, S 8, H MA 44312, I/A 39 ( 8.03.13).

13 de Junio de 2012
Nombramientos. Apo.Sol.: VAN GORP MICHIEL CHARLES THEODORUS CORNELIS;CARRILLO JIMENEZ NURIA;BETT JULIEFIONNA PAULINE;FERNANDEZ ECHEGARAY VICTOR;DE LA CRUZ JIMENEZ FERNANDO DAVID. Datos registrales. T 4574, L3482, F 177, S 8, H MA 44312, I/A 38 (31.05.12).

19 de Abril de 2012
Reelecciones. Auditor: DELOITTE SL. Datos registrales. T 4574, L 3482, F 177, S 8, H MA 44312, I/A 37 ( 9.04.12).

13 de Enero de 2011
Reelecciones. Auditor: DELOITTE SL. Datos registrales. T 4574, L 3482, F 177, S 8, H MA 44312, I/A 36 (20.12.10).

15 de Abril de 2010
Nombramientos. Apo.Sol.: CROCOCK DECLAN JOSEPH;PLANA RUIZ JOSE MANUEL. Datos registrales. T 4574, L 3482, F 177,S 8, H MA 44312, I/A 35 (29.03.10).

14 de Enero de 2010
Reelecciones. Auditor: DELOITTE SL. Datos registrales. T 4574, L 3482, F 176, S 8, H MA 44312, I/A 33 (22.12.09).

Sociedad unipersonal. Cambio de identidad del socio 煤nico: MVCI HOLIDAYS SL. Datos registrales. T 4574, L 3482, F 176, S 8,H MA 44312, I/A 34 (22.12.09).

07 de Diciembre de 2009
Reelecciones. Auditor: DELOITTE SL. Datos registrales. T 4574, L 3482, F 176, S 8, H MA 44312, I/A 32 (25.11.09).

21 de Septiembre de 2009
Ceses/Dimisiones. Consejero: WOODGATE PAULA ANNE. Cons.Del.Sol: WOODGATE PAULA ANNE. Presidente: DOWLING LEEANTONY. Consejero: DOWLING LEE ANTONY. Cons.Del.Sol: DOWLING LEE ANTONY. Consejero: RYAN DONALD RANCE.Cons.Del.Sol: RYAN DONALD RANCE. Secretario: MULLERAT BALMA脩A RAMON MARIA. Nombramientos. Adm. Solid.:DOWLING LEE ANTONY;RYAN DONALD RANCE. Modificaciones estatutarias. Cambio del Organo de Administraci贸n: Consejo deadministraci贸n a Administradores solidarios. Datos registrales. T 4574, L 3482, F 174, S 8, H MA 44312, I/A 28 (31.08.09).

Nombramientos. Apoderado: DOWLING LEE ANTONY;TERRY TONY;EVANS TAMMY LYNN;SULLIVAN LAURIE ANNE;HANDLONCAROLYN BURRIS;WRIGHT ALLAN WILLIAM;SADLER MICHELLE MARIE;MARTIN KENNETH LLOYD;POPCHOCK RONALDGERARD;GIBBS KATHERINE;THARAN NAVIN CHANDRA;MCKEON AMANDA LEIGH;ANTONUCCI-SIMS HEATHERMARIE;FULTON BEVERLY ANNE;NEVILLE JOHN DANIEL;MU脩OZ MONINO VICTOR;LEON GULLSTRAND CRISTINA;CROCOCKDECLAN JOSEPH;PLANA RUIZ JOSE MANUEL;JAYARAMAN MANOHAR;BARBER JEANNIE;VAN GORP MICHIEL CHARLESTHEODORUS CORNELIS;RUIZ LUNA CRISTINA;CARRILLO JIMENEZ NURIA;BETT JULIE FIONA PAULINE. Datos registrales. T4574, L 3482, F 175, S 8, H MA 44312, I/A 29 (31.08.09).

Nombramientos. Apo.Sol.: VAN GORP MICHIEL CHARLES THEODORUS CORNELIS;BETT JULIE FIONA PAULINE;FERNANDEZECHEGARAY VICTOR;CARRILLO JIMENEZ NURIA. Datos registrales. T 4574, L 3482, F 175, S 8, H MA 44312, I/A 30 (31.08.09).

Nombramientos. Apo.Sol.: MULLERAT PRAT BERNAT;MARTIN BAUMEISTER BRUNO;ALOS DOMENCH JAVIER;SANTOSBERGASA MAIDER SOFIA;PALLARES MARTI MARIA;CURTO DEL VALLE SARA;MARIN BENITEZ LUIS;HAGENAERS CARBOALEJANDRO;VELASCO RICO EVA. Datos registrales. T 4574, L 3482, F 176, S 8, H MA 44312, I/A 31 (31.08.09).

Utilizamos cookies de terceros con finalidades anal铆ticas, de personalizaci贸n, y de publicidad comportamental. Puede configurar ahora el uso de esta tecnolog铆a. Si acepta o contin煤a navegando, consideramos que est谩 de acuerdo con su uso. Mas informaci贸n