Actos BORME de Nacora Correduria De Seguros Sa
06 de Octubre de 2023Nombramientos. Apo.Man.Soli: NIKOLIC RADE. Datos registrales. T 36406 , F 182, S 8, H M 643004, I/A 13 (29.09.23).
Nombramientos. Apo.Sol.: AMBIELLE FERNANDEZ MIGUEL MARIA;NIKOLIC RADE;ABAJO DURAN SERGIO;MORENO DE JUANJUAN;ARAUJO AVILA JOSE ANTONIO. Datos registrales. T 36406 , F 183, S 8, H M 643004, I/A 14 (29.09.23).
25 de Mayo de 2023Ceses/Dimisiones. Consejero: FRAGELA VIÑAS MARIA-JOSE. Nombramientos. Consejero: FRAGA GONZALEZ MARIA. Datosregistrales. T 36406 , F 182, S 8, H M 643004, I/A 11 (18.05.23).
Revocaciones. Apo.Sol.: FRAGELA VIÑAS MARIA-JOSE;FRAGELA VIÑAS MARIA-JOSE. Apo.Manc.: FRAGELA VIÑAS MARIA-JOSE. Datos registrales. T 36406 , F 182, S 8, H M 643004, I/A 12 (18.05.23).
20 de Abril de 2022Revocaciones. Apoderado: AMBIELLE FERNANDEZ MIGUEL MARIA;FRAGELA VIÑAS MARIA-JOSE. Apo.Sol.: LACAL HUESOISIDRO. Apo.Manc.: LACAL HUESO ISIDRO. Otros conceptos: Cesado como gerente el 31 de marzo de 2022 Don Isidro LacalHueso (DNI 38546275T), que fue nombrado el 22 de mayo de 1987 según la inscripción 3 de su hoja en el Registro Mercantil deBarcelona, transcrita por la uno de la hoja del Registro Mercantil de Madrid. Revocados los poderes conferidos a Don Isidro LacalHueso (DNI 38546275T) y a Don Busso von Bismarck (residencia nº601021) el 30 de junio de 1988, según la inscripción 5 de su hojaen el Registro Mercantil de Barcelona, transcrita por la uno de la hoja del Registro Mercantil de Madrid. Revocados los poderesconferidos a Isidro Lacal Hueso (38546275T), a Busso von Bismarck (residencia nº601021), y a Basilio Segura Soques(36535016) el 6de marzo de 1990, según la ins 9 de su hoja en el Registro Mercantil de Barcelona, transcrita por la uno de la hoja del Mercantil deMadrid. Revocados los poderes conferidos a Don Isidro Lacal Hueso (DNI 38546275T) el 9 de junio de 1999, según la inscripción 27 desu hoja en el Registro Mercantil de Barcelona, transcrita por la uno de la hoja del Registro Mercantil de Madrid. Datos registrales. T36406 , F 181, S 8, H M 643004, I/A 10 (11.04.22).
07 de Abril de 2022Nombramientos. Apo.Man.Soli: FRAGA GONZALEZ MARIA. Datos registrales. T 36406 , F 180, S 8, H M 643004, I/A 9 (31.03.22).
13 de Noviembre de 2019Reelecciones. Consejero: BERGHOLZ STEFFEN GUNTER. Presidente: BERGHOLZ STEFFEN GUNTER. Consejero: AMBIELLEFERNANDEZ MIGUEL MARIA;FRAGELA VIÑAS MARIA-JOSE. Datos registrales. T 36406 , F 179, S 8, H M 643004, I/A 8 (6.11.19).
26 de Abril de 2019Nombramientos. Apoderado: LACAL HUESO ISIDRO. Datos registrales. T 36406 , F 179, S 8, H M 643004, I/A 7 (17.04.19).
05 de Octubre de 2018Revocaciones. Apoderado: GRAU CARBONELL SONIA. Datos registrales. T 36406 , F 179, S 8, H M 643004, I/A 6 (28.09.18).
22 de Noviembre de 2017Nombramientos. Apo.Sol.: AMBIELLE FERNANDEZ MIGUEL;FRAGELA VIÑAS MARIA-JOSE;ARAUJO AVILA JOSE ANTONIO.
Nombramientos. Apo.Sol.: AMBIELLE FERNANDEZ MIGUEL;FRAGELA VIÑAS MARIA-JOSE;MORENO DE JUAN JUAN;LACALHUESO ISIDRO. Datos registrales. T 36406 , F 177, S 8, H M 643004, I/A 4 (15.11.17).
Nombramientos. Apo.Manc.: AMBIELLE FERNANDEZ MIGUEL;FRAGELA VIÑAS MARIA-JOSE;MORENO DE JUAN JUAN;LACALHUESO ISIDRO. Datos registrales. T 36406 , F 177, S 8, H M 643004, I/A 5 (15.11.17).
06 de Abril de 2017Cambio de domicilio social. C/ TAJO 8 - POLIGONO INDUSTRIAL LAS ACACIAS (MEJORADA DEL CAMPO). Datos registrales.T 35783 , F 102, S 8, H M 643004, I/A 2 (24.03.17).
03 de Febrero de 2017Revocaciones. SECR.NO CONS: MARIMON PRATS ANTONIO. Nombramientos. SECR.NO CONS: VON CARSTENNLICHTERFELDE MENENDEZ FERNANDO. Datos registrales. T 41698 , F 145, S 8, H B 85643, I/A 49 (27.01.17).
24 de Noviembre de 2014Nombramientos. CONSEJERO: STEFFEN GUNTER BERGHOLZ. PRESIDENTE: STEFFEN GUNTER BERGHOLZ. Datosregistrales. T 41698 , F 145, S 8, H B 85643, I/A 48 (17.11.14).
19 de Agosto de 2014Nombramientos. CONSEJERO: AMBIELLE FERNANDEZ MIGUEL MARIA;FRAGELA VIÑAS MARIA JOSE. Datos registrales. T41698 , F 145, S 8, H B 85643, I/A 47 ( 8.08.14).
28 de Agosto de 2012Revocaciones. SECR.NO CONS: MARIMON GARNIER LUIS FRANCISCO. Nombramientos. SECR.NO CONS: MARIMON PRATSANTONIO. Datos registrales. T 41698 , F 144, S 8, H B 85643, I/A 46 (16.08.12).
06 de Septiembre de 2011Revocaciones. APODERADO: JUNCOSA ARAGONES JAVIER;MARTINEZ DEL PERAL CAGIGAL FERNANDO. Datos registrales.T 41698 , F 144, S 8, H B 85643, I/A 45 (29.08.11).
06 de Julio de 2011Revocaciones. APODERADO: MORENO DE JUAN JUAN. Nombramientos. APODERADO: MORENO DE JUAN JUAN. Datosregistrales. T 41698 , F 143, S 8, H B 85643, I/A 44 (27.06.11).
18 de Mayo de 2011Nombramientos. APODERADO: AMBIELLE FERNANDEZ MIGUEL MARIA;FRAGELA VIÑAS MARIA JOSE. Datos registrales. T41698 , F 142, S 8, H B 85643, I/A 43 ( 6.05.11).
05 de Abril de 2011Nombramientos. APODERADO: ARAUJO AVILA JOSE ANTONIO. Datos registrales. T 41698 , F 141, S 8, H B 85643, I/A 42(24.03.11).
23 de Febrero de 2011Nombramientos. APODERADO: MORENO DE JUAN JUAN. Datos registrales. T 41698 , F 141, S 8, H B 85643, I/A 41 (10.02.11).
23 de Noviembre de 2010Cambio de domicilio social. CL DE L'ANTARTIC 13-19 (BARCELONA). Datos registrales. T 41698 , F 141, S 8, H B 85643, I/A 40(11.11.10).
24 de Febrero de 2010Revocaciones. CONSEJERO: GERARDUS VAN KESTEREN. PRESIDENTE: GERARDUS VAN KESTEREN. Nombramientos.CONSEJERO: STEFFEN GUNTER BERGHOLZ. PRESIDENTE: STEFFEN GUNTER BERGHOLZ. Datos registrales. T 26368 , F70, S 8, H B 85643, I/A 39 (11.02.10).
26 de Mayo de 2009Revocaciones. CONSEJERO: MARTINEZ DEL PERAL CAGIGAL FERNANDO;GEREON NIEMEIER. Nombramientos.CONSEJERO: AMBIELLE FERNANDEZ MIGUEL MARIA;FRAGELA VIÑAS MARIA JOSE. Datos registrales. T 26368 , F 70, S 8, HB 85643, I/A 38 (14.05.09).