Buscador CIF Logo

Actos BORME Nanta Sociedad Anonima

驴Quieres acceder a la API de EMPRESAS CIF? Obten la informaci贸n de todas las empresas en tiempo real desde tu plataforma.
Ahora con un 25% de DESCUENTO el primer MES. Quiero la API de EMPRESAS

Logo cabecera Nanta Sociedad Anonima

Actos BORME Nanta Sociedad Anonima - A58596628

Tenemos registrados 14 Actos BORME del Registro Mercantil de Murcia para Nanta Sociedad Anonima con CIF A58596628

馃敊 Perfil de Nanta Sociedad Anonima
馃洅 Comprar listado completo de Empresas de Murcia

Actos BORME de Nanta Sociedad Anonima

29 de Noviembre de 2023
Cambio de denominaci贸n social. NUTRECO ANIMAL NUTRITION IBERIA SA. Fusi贸n por absorci贸n. Sociedades absorbidas:TROUW NUTRITION ESPA脩A SA. TROUWFARMA SA. Datos registrales. T 45784 , F 3, S 8, H M 301680, I/A 114 (22.11.23).

20 de Noviembre de 2023
Nombramientos. Apoderado: COUDERC PIERRE;FOGLIATO MARIA VERONICA;PEINADO GONZALEZ JOAQUIN;RIBEIROANDRE SANTIAGO;DE ANCOS ARACIL MARIA ELENA;PICON CABRERA MARIA DOLORES;ALLOGGIA CARRILLO YIMMYBETLUI;QUINTANA RODRIGUEZ MARIA ANGELES;VILLAR SANCHEZ BEATRIZ;RODRIGUEZ PENA MARIA BLANCA;PIELAGOSOCHOA ANA MARIA;RUIZ MORENO ALBERTO. Datos registrales. T 45784 , F 1, S 8, H M 301680, I/A 113 (13.11.23).

06 de Octubre de 2023
Nombramientos. Apoderado: DE COLLANTES YLLERA ANTONIO. Datos registrales. T 41150 , F 225, S 8, H M 301680, I/A 111(29.09.23).

Revocaciones. Apo.Sol.: FERNANDEZ DEL POZO MARIA PALOMA;GONZALEZ ARDID CRISTEL;GIL RODRIGO JOSEFA. Datosregistrales. T 41150 , F 225, S 8, H M 301680, I/A 112 (29.09.23).

03 de Agosto de 2023
Revocaciones. Apoderado: CORDERO CASTILLO PEDRO LUIS. Apo.Manc.: GUILMAIN CORTES JOSE CARLOS;SLOCOMBEIAN. Nombramientos. Apo.Sol.: FOGLIATO MARIA VERONICA;DE ANCOS ARACIL MARIA ELENA;ALLOGGIA CARRILLO YIMMYBETLUI. Apo.Manc.: QUINTANA RODRIGUEZ MARIA ANGELES;VILLAR SANCHEZ BEATRIZ;PIELAGOS OCHOA ANA MARIADatos registrales. T 41150 , F 224, S 8, H M 301680, I/A 110 (27.07.23).

22 de Junio de 2023
Nombramientos. Apoderado: RODRIGUEZ PENA MARIA BLANCA. Datos registrales. T 41150 , F 221, S 8, H M 301680, I/A 106(14.06.23).

16 de Junio de 2023
Nombramientos. Apoderado: FERNANDEZ ARIAS GUSTAVO. Datos registrales. T 41150 , F 221, S 8, H M 301680, I/A 105 (9.06.23).

14 de Junio de 2023
Ceses/Dimisiones. Adm. Mancom.: CORDERO CASTILLO PEDRO LUIS. Nombramientos. Adm. Mancom.: COUDERC PIERRE.Datos registrales. T 41150 , F 220, S 8, H M 301680, I/A 104 ( 7.06.23).

02 de Marzo de 2023
Revocaciones. Apoderado: FERNANDEZ DEL POZO PALOMA. Apo.Man.Soli: CABRERA PONCE DE LEON MIGUEL;MARINECUESTA GERARD. Apo.Manc.: RIBOT CISA JOSE ENRIQUE;GUILMAIN CORTES JOSE CARLOS;GIMENO GONZALEZFRANCISCO IGNACIO. Apo.Sol.: FARRE PRIM ELIES RAMON. Apo.Manc.: FARRE PRIM ELIES RAMON;QUEIPO DE LLANONAVARRO GONZALO. Apoderado: RADIO PASTOR FERNANDO;PAREDES CUESTA LUCIA MARIA. Apo.Manc.: PICON CABRERAMARIA DOLORES;GUILMAIN CORTES JOSE CARLOS;GIMENO GONZALEZ FRANCISCO IGNACIO;QUEIPO DE LLANONAVARRO GONZALO;SLOCOMBE IAN;GARCIA-DONAS CERVIGON GUILLERMO. Apoderado: SLOCOMBE IAN;PICON CABRERAMARIA DOLORES;CORDERO CASTILLO PEDRO LUIS;CORDERO CASTILLO PEDRO LUIS;RODRIGUEZ COJO LUISRAUL;ALONSO USANO MARIA EUGENIA;ORTIZ MOYANO JOSE;FERNANDEZ GANDULLO JOSE ANTONIO;FERRE SANCHEZMARCELO FRANCISCO;MARINE CUESTA GERARD;RIBOT CISA JOSE ENRIQUE;FARRE PRIM ELIES RAMON;RIBOT CISAJOSE ENRIQUE;FARRE PRIM ELIES RAMON. Apo.Sol.: GOMEZ DE BONILLA GONZALEZ MARIA ELISA. Apoderado: GOMEZ DEBONILLA GONZALEZ MARIA ELISA;DEL CAMPO PASTOR AMALIA MARIA;FOGLIATO MARIA VERONICA;USALL MATEOJORDI;NEIRA VALLES RUTH. Apo.Sol.: PICON CABRERA MARIA DOLORES. Apoderado: GOMEZ DE BONILLA GONZALEZ MARIAELISA. Apo.Manc.: MARINE CUESTA GERARD. Apo.Sol.: MARINE CUESTA GERARD. Datos registrales. T 41150 , F 218, S 8, H M301680, I/A 103 (23.02.23).

29 de Noviembre de 2022
Nombramientos. Apo.Sol.: CARMONA BOTANA PATRICIA. Datos registrales. T 41150 , F 218, S 8, H M 301680, I/A 102(22.11.22).

09 de Septiembre de 2022
Nombramientos. Apoderado: GARCIA GARCIA BEATRIZ. Datos registrales. T 41150 , F 217, S 8, H M 301680, I/A 101 ( 2.09.22).

02 de Septiembre de 2022
Modificaciones estatutarias. Se aprueba un texto refundido de los Estatutos Sociales. Datos registrales. T 41150 , F 214, S 8, H M301680, I/A 100 (26.08.22).

21 de Enero de 2022
Nombramientos. Apo.Sol.: DIEZ BENITO GLORIA MARIA;FERNANDEZ DEL POZO MARIA PALOMA;GONZALEZ ARDIDCRISTEL;GIL RODRIGO JOSEFA. Datos registrales. T 41150 , F 213, S 8, H M 301680, I/A 99 (14.01.22).

03 de Diciembre de 2021
Reelecciones. Auditor: KPMG AUDITORES SL. Datos registrales. T 41150 , F 213, S 8, H M 301680, I/A 98 (26.11.21).

Utilizamos cookies de terceros con finalidades anal铆ticas, de personalizaci贸n, y de publicidad comportamental. Puede configurar ahora el uso de esta tecnolog铆a. Si acepta o contin煤a navegando, consideramos que est谩 de acuerdo con su uso. Mas informaci贸n