Actos BORME de Nascor Energias Sociedad Limitada
30 de Diciembre de 2022Reelecciones. Adm.Judicial: RUBI BLANC LUIS MANUEL. Datos registrales. T 35479 , F 61, S 8, H M 637715, I/A 15 (22.12.22).
10 de Agosto de 2022Reelecciones. Adm.Judicial: RUBI BLANC LUIS MANUEL. Datos registrales. T 35479 , F 61, S 8, H M 637715, I/A 14 ( 3.08.22).
24 de Junio de 2022Nombramientos. Apoderado: DIAZ FERNANDEZ JOSE DIEGO. Datos registrales. T 35479 , F 60, S 8, H M 637715, I/A 13(17.06.22).
21 de Febrero de 2022Ceses/Dimisiones. Adm. Unico: ANDRADE DE LA PEDRAJA ALFONSO RAMIRO. Nombramientos. Adm.Judicial: RUBI BLANCLUIS MANUEL. Otros conceptos: ANOTACION PREVENTIVA DEL AUTO ACORDANDO LA ADMINISTRACION JUDICIAL DE LASOCIEDAD; NOMBRAMIENTO DE ADMINISTRADOR JUDICIAL: don LUIS MANUEL RUBI BLANC FECHA NOMBRAMIENTO: 22NOVIEMBRE 2021; FECHA VENCIMIENTO: 22 DE MAYO DE 2022. CESE de don ALFONSO RAMIRO ANDRADE DE LA PEDRAJA.Datos registrales. T 35479 , F 60, S 8, H M 637715, I/A A (14.02.22).
20 de Julio de 2021Reducci贸n de capital. Importe reducci贸n: 1.500.000,00 Euros. Resultante Suscrito: 3.000.000,00 Euros. Datos registrales. T 35479, F 59, S 8, H M 637715, I/A 12 (13.07.21).
28 de Abril de 2021Ceses/Dimisiones. Consejero: MARTINEZ ALONSO JUANA;SAN ROMAN CASTRO IVAN;MECO SERNA JAVIER. Presidente:MARTINEZ ALONSO JUANA. Secretario: SAN ROMAN CASTRO IVAN. Nombramientos. Adm. Unico: ANDRADE DE LA PEDRAJAALFONSO RAMIRO. Otros conceptos: Cambio del Organo de Administraci贸n: Consejo de administraci贸n a Administrador 煤nico.Datos registrales. T 35479 , F 59, S 8, H M 637715, I/A 11 (21.04.21).
29 de Diciembre de 2020Reducci贸n de capital. Importe reducci贸n: 2.700.000,00 Euros. Resultante Suscrito: 4.500.000,00 Euros. Datos registrales. T 35479, F 58, S 8, H M 637715, I/A 10 (21.12.20).
28 de Diciembre de 2020Ampliaci贸n de capital. Capital: 2.700.000,00 Euros. Resultante Suscrito: 7.200.000,00 Euros. Modificaciones estatutarias.Modificados los Art铆culos 6潞 y 7潞 de los Estatutos Sociales.. Datos registrales. T 35479 , F 58, S 8, H M 637715, I/A 9 (18.12.20).
22 de Octubre de 2020Ceses/Dimisiones. Consejero: SIMON CASTILLO CRISTOBAL. Presidente: SIMON CASTILLO CRISTOBAL. Consejero: MARTINEZALONSO JUANA. Secretario: MARTINEZ ALONSO JUANA. Consejero: SIMON MARTINEZ AMELIA;NIETO SIMON JAVIER.Con.Delegado: NIETO SIMON JAVIER. Nombramientos. Consejero: MARTINEZ ALONSO JUANA;SAN ROMAN CASTROIVAN;MECO SERNA JAVIER. Presidente: MARTINEZ ALONSO JUANA. Secretario: SAN ROMAN CASTRO IVAN. Datos registrales.T 35479 , F 57, S 8, H M 637715, I/A 8 (15.10.20).
06 de Mayo de 2019Nombramientos. Auditor: G-AUDIT 2015 SLP. Datos registrales. T 35479 , F 57, S 8, H M 637715, I/A 7 (25.04.19).
25 de Octubre de 2018Cambio de domicilio social. C/ ZURBANO NUMERO 76, 1潞 5陋 (MADRID). Datos registrales. T 35479 , F 57, S 8, H M 637715, I/A6 (18.10.18).
21 de Marzo de 2017Ceses/Dimisiones. Consejero: SIMON MARTINEZ JUAN. Cons.Del.Sol: SIMON MARTINEZ JUAN. Nombramientos. Consejero:NIETO SIMON JAVIER. Con.Delegado: NIETO SIMON JAVIER. Datos registrales. T 35479 , F 57, S 8, H M 637715, I/A 5 (10.03.17).
18 de Enero de 2017Revocaciones. Apoderado: SIMON MARTINEZ JUAN. Datos registrales. T 35479 , F 56, S 8, H M 637715, I/A 3 (11.01.17).
Nombramientos. Apoderado: NIETO SIMON JAVIER. Datos registrales. T 35479 , F 56, S 8, H M 637715, I/A 4 (11.01.17).
13 de Enero de 2017Cambio de domicilio social. C/ SAN AGUSTIN 9 - BAJO IZQUIERDA (MADRID). Datos registrales. T 35479 , F 55, S 8, H M637715, I/A 2 ( 5.01.17).