Actos BORME de Natura De La India Sl
28 de Julio de 2023Ampliaci贸n de capital. Capital: 116.250,00 Euros. Resultante Suscrito: 4.903.000,00 Euros. Modificaciones estatutarias. 5.Modificaci贸n de art铆culo 5 de los estatutos "Capital social". Datos registrales. T 24194 , F 169, S 8, H M 434786, I/A 19 (21.07.23).
Modificaciones estatutarias. Modificaci贸n de art铆culo 20 Bis de los estatutos. . 30. Modificaci贸n de art铆culo 30 de los estatutos. .Cambio de domicilio social. C/ MARIE CURIE 7 2陋 8 - EDIFICIO BETA (RIVAS-VACIAMADRID). Datos registrales. T 24194 , F171, S 8, H M 434786, I/A 20 (21.07.23).
26 de Abril de 2023Nombramientos. Con.Delegado: NAVARRO PEROMINGO ALFONSO. Datos registrales. T 24194 , F 169, S 8, H M 434786, I/A 18(19.04.23).
02 de Junio de 2022Ceses/Dimisiones. Presidente: DIAZ BASTIEN LOPEZ HECTOR. Nombramientos. Presidente: NAVARRO PEROMINGOALFONSO. Datos registrales. T 24194 , F 169, S 8, H M 434786, I/A 17 (26.05.22).
22 de Marzo de 2021Ceses/Dimisiones. Consejero: DIAZ-BASTIEN LOPEZ ERNESTO. Datos registrales. T 24194 , F 169, S 8, H M 434786, I/A 16(12.03.21).
15 de Noviembre de 2017Nombramientos. Cons.Del.Sol: SALINAS MOYA RAFAEL. Otros conceptos: Informaci贸n sobre el estado de la ampliaci贸n decapital acordada en la sesion de 9 de marzo de 2015. Limitadas las facultades de los Consejeros Delegados. Ampliacion del objetosocial. LA ADQUISICION, TENENCIA, GESTION Y ADMINISTRACION DE VALORES REPRESENTATIVOS DE LOS FONDOSPROPIOS DE ENTIDADES RESIDENTES Y NO RESIDENTES EN TERRITORIO ESPA脩OL, TODO ELLO DE CONFORMIDAD CONLO PREVISTO EN LA LEY DEL IMPUESTO DE SOCIEDADES Y LAS DISPOSICIONES QUE LA DESARROLLEN. Datosregistrales. T 24194 , F 168, S 8, H M 434786, I/A 15 ( 6.11.17).
30 de Octubre de 2017Ampliaci贸n de capital. Capital: 240.750,00 Euros. Resultante Suscrito: 4.786.750,00 Euros. Datos registrales. T 24194 , F 167, S 8,H M 434786, I/A 14 (19.10.17).
23 de Noviembre de 2015Nombramientos. Consejero: NAVARRO PEROMINGO ALFONSO;SALINAS MOYA RAFAEL. Datos registrales. T 24194 , F 166, S8, H M 434786, I/A 13 (16.11.15).
03 de Agosto de 2015Ceses/Dimisiones. Secretario: MANRIQUE JUEGA GARCIA LUIS. Nombramientos. SecreNoConsj: FERNANDEZ IZQUIERDOMARTA. Consejero: INCA PIO XII SL. Representan: RAMOS BANUS JOSE MARIA. Modificaciones estatutarias. 18. Datosregistrales. T 24194 , F 166, S 8, H M 434786, I/A 12 (23.07.15).
19 de Junio de 2015Ceses/Dimisiones. Cons.Del.Sol: IZQUIERDO MERLO SL. Nombramientos. Cons.Del.Sol: INVERSIONES IZMER SL. Datosregistrales. T 24194 , F 165, S 8, H M 434786, I/A 11 (10.06.15).
24 de Abril de 2015Ceses/Dimisiones. Cons.Del.Sol: DIAZ-BASTIEN LOPEZ ERNESTO. Datos registrales. T 24194 , F 165, S 8, H M 434786, I/A 10(16.04.15).
03 de Diciembre de 2014Ceses/Dimisiones. Representan: VERA VAZQUEZ FRANCISCO. Consejero: GADESO 2003 SL;MU脩OZ ESCOLANO MANUEL.Nombramientos. Representan: DE LA PE脩A PRIMICIAS MARIA TERESA DEL CARMEN. Consejero: TRUANCONRADO;SANGUESA E HIJOS SL. Datos registrales. T 24194 , F 165, S 8, H M 434786, I/A 9 (25.11.14).
29 de Octubre de 2014Ceses/Dimisiones. Consejero: IZQUIERDO JIMENEZ EMILIO;DE LEON EGUES RICARDO;DIAZ BASTIEN LOPEZHECTOR;PROMOCIONES CORDOVILLA SA. Presidente: DIAZ BASTIEN LOPEZ HECTOR. Consejero: IZQUIERDO MERLOEMILIO;MU脩OZ ESCOLANO MANUEL;TABERNA SENOSIAIN CARLOS;SENOSIAIN MURILLO JOSE JOAQUIN. Con.Delegado:IZQUIERDO JIMENEZ EMILIO. Vicepresid.: IZQUIERDO JIMENEZ EMILIO. Consejero: DIAZ-BASTIEN LOPEZ ERNESTO.Cons.Del.Sol: DIAZ-BASTIEN LOPEZ ERNESTO. Cons.Del.Man: DIAZ-BASTIEN LOPEZ ERNESTO. Representan: SONOSIAINMURILLO FRANCISCO JAVIER. Nombramientos. Representan: IZQUIERDO JIMENEZ EMILIO. Consejero: INVERSIONES IZMERSL;IZQUIERDO MERLO SL;INVERSIONES HETASE SL;PROMOCIONES CORDOVILLA SA;NEGOCIOS SEJA SL;GADESO 2003SL;DIAZ BASTIEN LOPEZ HECTOR;DIAZ-BASTIEN LOPEZ ERNESTO;MU脩OZ ESCOLANO MANUEL. Representan: TABERNASENOSIAIN CARLOS;VERA VAZQUEZ FRANCISCO;SENOSIAIN MURILLO JOSE-JOAQUIN;SENOSIAIN MURILLO FRANCISCOJAVIER;IZQUIERDO MERLO EMILIO. Presidente: DIAZ BASTIEN LOPEZ HECTOR. Vicepresid.: IZQUIERDO MERLO SL.Cons.Del.Sol: DIAZ-BASTIEN LOPEZ ERNESTO;IZQUIERDO MERLO SL. Datos registrales. T 24194 , F 163, S 8, H M 434786, I/A8 (20.10.14).
17 de Septiembre de 2014Ampliaci贸n de capital. Capital: 45.000,00 Euros. Resultante Suscrito: 4.546.000,00 Euros. Datos registrales. T 24194 , F 162, S 8,H M 434786, I/A 7 (10.09.14).
17 de Octubre de 2011Ceses/Dimisiones. Consejero: TRUAN BLANCO RAFAEL. Cons.Del.Sol: TRUAN BLANCO RAFAEL. Nombramientos. Consejero:DIAZ-BASTIEN LOPEZ ERNESTO. Cons.Del.Sol: DIAZ-BASTIEN LOPEZ ERNESTO. Cons.Del.Man: DIAZ-BASTIEN LOPEZERNESTO. Cambio de domicilio social. C/ THOMAS EDISON 4 Bl.2 - OFICINA 2214 (RIVAS-VACIAMADRID). Datos registrales.T 24194 , F 161, S 8, H M 434786, I/A 6 ( 3.10.11).
29 de Diciembre de 2010Ceses/Dimisiones. Vicepresid.: VAZQUEZ VERA ANDRES. Consejero: VAZQUEZ VERA ANDRES. Nombramientos. Vicepresid.:IZQUIERDO JIMENEZ EMILIO. Datos registrales. T 24194 , F 161, S 8, H M 434786, I/A 5 (17.12.10).
23 de Febrero de 2010Ceses/Dimisiones. Cons.Del.Sol: VAZQUEZ VERA ANDRES. Nombramientos. Con.Delegado: IZQUIERDO JIMENEZ EMILIO.Datos registrales. T 24194 , F 161, S 8, H M 434786, I/A 4 (10.02.10).
10 de Diciembre de 2009Fe de erratas: SE PUBLICO POR ERROR EN LA INSCRIPCION 1&, EL NOMBRAMIENTO COMO VICESECRETARIO NOCONSEJERO DE RUEDA SILVA MIGUEL, SIENDO LO CORRECTO RUEDA SILVA DANIEL. Datos registrales. T 24194 , F 150, S8, H M 434786, I/A 1 ( 4.07.07).
Reducci贸n de capital. Importe reducci贸n: 1.500.000,00 Euros. Resultante Suscrito: 4.501.000,00 Euros. Datos registrales. T 24194, F 160, S 8, H M 434786, I/A 3 (30.11.09).