Buscador CIF Logo

Actos BORME Natural Salads Sociedad Limitada

驴Quieres acceder a la API de EMPRESAS CIF? Obten la informaci贸n de todas las empresas en tiempo real desde tu plataforma.
Ahora con un 25% de DESCUENTO el primer MES. Quiero la API de EMPRESAS

Logo cabecera Natural Salads Sociedad Limitada

Actos BORME Natural Salads Sociedad Limitada - B73145294

Tenemos registrados 21 Actos BORME del Registro Mercantil de Murcia para Natural Salads Sociedad Limitada con CIF B73145294

馃敊 Perfil de Natural Salads Sociedad Limitada
馃洅 Comprar listado completo de Empresas de Murcia

Actos BORME de Natural Salads Sociedad Limitada

02 de Agosto de 2022
Situaci贸n concursal. Procedimiento concursal 275/2022. FIRME: No, Fecha de resoluci贸n 11/07/2022. Auto de declaraci贸n deconcurso. Voluntario. Juzgado: num. 0 JUZGADO DE LO MERCANTIL NUMERO 1 DE MURCIA. Juez: MARIA DOLORES DE LASHERAS GARCIA. Situaci贸n concursal. Procedimiento concursal 275/2022. Fecha de resoluci贸n 12/07/2022. Nombramiento deadministradores. Juzgado: num. 0 JUZGADO DE LO MERCANTIL NUMERO 1 DE MURCIA. Juez: MARIA DOLORES DE LAS HERASGARCIA. Administrador Concursal. Fecha 12/07/2022, NIF/CIF B05551601. NAVARRO Y VIGUERAS ADMINISTRADORESCONCURSALES SOCIEDAD LIMITADA PROFESIONAL. Situaci贸n concursal. Procedimiento concursal 275/2022. FIRME: No,Fecha de resoluci贸n 11/07/2022. Resoluciones acordando la intervenci贸n o suspensi贸n de las factultades de administraci贸n ydisposici贸n del concursado. Juzgado: num. 0 JUZGADO DE LO MERCANTIL NUMERO 1 DE MURCIA. Juez: MARIA DOLORES DELAS HERAS GARCIA. Datos registrales. T 2850 , F 35, S 8, H MU 39269, I/A A (25.07.22).

12 de Abril de 2019
Ceses/Dimisiones. Apo.Manc.: ANDRES ROMAN RE. Datos registrales. T 2850 , F 35, S 8, H MU 39269, I/A 29 ( 5.04.19).

03 de Enero de 2019
Nombramientos. Auditor: A.C.L. AUDITORES SLP. Datos registrales. T 2850 , F 33, S 8, H MU 39269, I/A 28 a (26.12.18).

28 de Diciembre de 2018
Nombramientos. Apoderado: MANUEL GARCIA GARCIA. Datos registrales. T 2850 , F 33, S 8, H MU 39269, I/A 28 (21.12.18).

21 de Diciembre de 2018
Ceses/Dimisiones. Consejero: ANTONIO GABARRON QUESADA. Presidente: ANTONIO GABARRON QUESADA. Consejero:FERNANDO CUADRADO SOLER. Vicepresid.: FERNANDO CUADRADO SOLER. Consejero: JOSE LOPEZ ACOSTA. Secretario:JOSE LOPEZ ACOSTA. Consejero: JUAN JOSE VERA GARCIA;JULIAN GARCIA GARCIA. Cons.Del.Man: ANTONIO GABARRONQUESADA;FERNANDO CUADRADO SOLER;JULIAN GARCIA GARCIA. Datos registrales. T 2850 , F 33, S 8, H MU 39269, I/A 27(14.12.18).

07 de Diciembre de 2018
Otros conceptos: Solicitud de anotaci贸n de asistencia de Notario y levantamiento de acta notarial de la junta a celebrar el 21 denoviembre de 2018. Datos registrales. T 2850 , F 33, S 8, H MU 39269, I/A B (29.11.18).

30 de Noviembre de 2018
Ceses/Dimisiones. Cons.Del.Man: FRANCISCO ALFONSO ABELLANEDA MARTINEZ;ANTONIO GABARRON QUESADA;JULIANGARCIA GARCIA. Nombramientos. Cons.Del.Man: ANTONIO GABARRON QUESADA;FERNANDO CUADRADO SOLER;JULIANGARCIA GARCIA. Datos registrales. T 2850 , F 33, S 8, H MU 39269, I/A 26 (23.11.18).

22 de Noviembre de 2018
Otros conceptos: Solicitud de asistencia de Notario y levantamiento de acta notarial de la junta a celebrar el 8 de noviembre de 2018.Datos registrales. T 2850 , F 31, S 8, H MU 39269, I/A A (15.11.18).

16 de Octubre de 2018
Nombramientos. Apo.Manc.: ANDRES ROMAN RE;MANUEL GARCIA GARCIA. Datos registrales. T 2850 , F 31, S 8, H MU39269, I/A 25 ( 5.10.18).

28 de Septiembre de 2018
Articulo 378.5 del Reglamento del Registro Mercantil. Justificacion de no aprobacion de cuentas del ejercicio 2016 mediantecertificacion del organo de administracion. Datos registrales. T 2850 , F 31, S 8, H MU 39269, I/A 23 (21.09.18).

Nombramientos. Consejero: JUAN PEDRO ABELLANEDA MARTINEZ. Datos registrales. T 2850 , F 31, S 8, H MU 39269, I/A 24(21.09.18).

09 de Mayo de 2016
Nombramientos. Auditor: JOAQUIN MARTINEZ ALFONSO. Aud.Supl.: GABINETE DE AUDITORIA EVG SLP. Datos registrales. T2850 , F 30, S 8, H MU 39269, I/A 22 ( 2.05.16).

19 de Febrero de 2015
Otros conceptos: Modificaci贸n del punto 12 del articulo 29 de los estatutos sociales, y la eliminaci贸n del punto 14 del citado articulo.Datos registrales. T 2850 , F 30, S 8, H MU 39269, I/A 21 (12.02.15).

04 de Abril de 2014
Reducci贸n de capital. Importe reducci贸n: 188.112,00 Euros. Resultante Suscrito: 1.362.366,00 Euros. Datos registrales. T 2850 , F30, S 8, H MU 39269, I/A 20 (28.03.14).

31 de Diciembre de 2013
Ceses/Dimisiones. Consejero: ANTONIO GABARRON QUESADA;DOMINGO PORLAN JIMENEZ;FRANCISCO ALFONSOABELLANEDA MARTINEZ;JOSE LOPEZ ACOSTA;JULIAN GARCIA GARCIA;JUAN JOSE VERA GARCIA. Presidente: ANTONIOGABARRON QUESADA. Secretario: JUAN JOSE VERA GARCIA. Vicepresid.: DOMINGO PORLAN JIMENEZ;FRANCISCOALFONSO ABELLANEDA MARTINEZ. Cons.Del.Man: ANTONIO GABARRON QUESADA;JUAN JOSE VERA GARCIA;DOMINGOPORLAN JIMENEZ;FRANCISCO ALFONSO ABELLANEDA MARTINEZ. Nombramientos. Consejero: ANTONIO GABARRONQUESADA. Presidente: ANTONIO GABARRON QUESADA. Consejero: FERNANDO CUADRADO SOLER. Vicepresid.: FERNANDOCUADRADO SOLER. Vicepr.2: FRANCISCO ALFONSO ABELLANEDA MARTINEZ. Consejero: JOSE LOPEZ ACOSTA. Secretario:JOSE LOPEZ ACOSTA. Consejero: JUAN JOSE VERA GARCIA;JULIAN GARCIA GARCIA. Cons.Del.Man: FRANCISCO ALFONSOABELLANEDA MARTINEZ. Consejero: FRANCISCO ALFONSO ABELLANEDA MARTINEZ. Cons.Del.Man: ANTONIO GABARRONQUESADA;JULIAN GARCIA GARCIA. Datos registrales. T 2850 , F 29, S 8, H MU 39269, I/A 19 (23.12.13).

27 de Junio de 2013
Reelecciones. Auditor: JOAQUIN MARTINEZ ALFONSO. Aud.Supl.: JULIAN PE脩ARANDA GOMEZ. Datos registrales. T 2850 , F29, S 8, H MU 39269, I/A 18 (21.06.13).

02 de Diciembre de 2011
Ceses/Dimisiones. Consejero: FRANCISCO ALFONSO ABELLANEDA MARTINEZ. Presidente: FRANCISCO ALFONSOABELLANEDA MARTINEZ. Consejero: JUAN JOSE VERA GARCIA. Secretario: JUAN JOSE VERA GARCIA. Consejero: ANTONIOGABARRON QUESADA;JOSE JUAN PEREZ ORTEGA;ANTONIO CORTIJOS PERAN;JULIAN GARCIA GARCIA;FERNANDO FILLOLSENDRA. Cons.Del.Man: ANTONIO GABARRON QUESADA;FRANCISCO ALFONSO ABELLANEDA MARTINEZ;JUAN JOSE VERAGARCIA;FERNANDO FILLOL SENDRA. Nombramientos. Consejero: ANTONIO GABARRON QUESADA;ANTONIO CORTIJOSPERAN;FRANCISCO ALFONSO ABELLANEDA MARTINEZ;JUAN JOSE VERA GARCIA;FERNANDO FILLOL SENDRA;JULIANGARCIA GARCIA. Presidente: ANTONIO GABARRON QUESADA. Vicepresid.: ANTONIO CORTIJOS PERAN;FRANCISCOALFONSO ABELLANEDA MARTINEZ. Consejero: DOMINGO PORLAN JIMENEZ. Vicepresid.: DOMINGO PORLAN JIMENEZ.Secretario: JUAN JOSE VERA GARCIA. Cons.Del.Man: ANTONIO GABARRON QUESADA;FRANCISCO ALFONSO ABELLANEDAMARTINEZ;JUAN JOSE VERA GARCIA. Consejero: FERNANDO FILLOL SENDRA. Cons.Del.Man: FERNANDO FILLOL SENDRA.Datos registrales. T 2012 , F 108, S 8, H MU 39269, I/A 15 (21.11.11).

Ceses/Dimisiones. Cons.Del.Man: FERNANDO FILLOL SENDRA;JUAN JOSE VERA GARCIA;ANTONIO GABARRONQUESADA;FRANCISCO ALFONSO ABELLANEDA MARTINEZ. Revocaciones. Apo.Man.Soli: FERNANDO FILLOL SENDRA.Nombramientos. Cons.Del.Man: ANTONIO GABARRON QUESADA;FRANCISCO ALFONSO ABELLANEDA MARTINEZ;JUANJOSE VERA GARCIA;ANTONIO CORTIJOS PERAN. Datos registrales. T 2850 , F 29, S 8, H MU 39269, I/A 16 (22.11.11).

Ceses/Dimisiones. Cons.Del.Man: ANTONIO GABARRON QUESADA;FRANCISCO ALFONSO ABELLANEDA MARTINEZ;JUANJOSE VERA GARCIA;ANTONIO CORTIJOS PERAN. Consejero: ANTONIO GABARRON QUESADA;ANTONIO CORTIJOSPERAN;FRANCISCO ALFONSO ABELLANEDA MARTINEZ;JUAN JOSE VERA GARCIA;FERNANDO FILLOL SENDRA;JULIANGARCIA GARCIA. Presidente: ANTONIO GABARRON QUESADA. Vicepresid.: ANTONIO CORTIJOS PERAN;FRANCISCOALFONSO ABELLANEDA MARTINEZ. Consejero: DOMINGO PORLAN JIMENEZ. Vicepresid.: DOMINGO PORLAN JIMENEZ.Secretario: JUAN JOSE VERA GARCIA. Consejero: FERNANDO FILLOL SENDRA. Nombramientos. Consejero: ANTONIOGABARRON QUESADA;DOMINGO PORLAN JIMENEZ;FRANCISCO ALFONSO ABELLANEDA MARTINEZ;JOSE LOPEZACOSTA;JULIAN GARCIA GARCIA;JUAN JOSE VERA GARCIA. Presidente: ANTONIO GABARRON QUESADA. Secretario: JUANJOSE VERA GARCIA. Vicepresid.: DOMINGO PORLAN JIMENEZ;FRANCISCO ALFONSO ABELLANEDA MARTINEZ.Cons.Del.Man: ANTONIO GABARRON QUESADA;JUAN JOSE VERA GARCIA;DOMINGO PORLAN JIMENEZ;FRANCISCOALFONSO ABELLANEDA MARTINEZ. Datos registrales. T 2850 , F 29, S 8, H MU 39269, I/A 17 (22.11.11).

12 de Abril de 2011
Adaptaci贸n de sociedad. Otros conceptos: Modificaci贸n de los articulos 2, 7, 10, 16,, 24, 28 y 29 delos estatutos sociales paraadaptarlos a la normativa comunitaria sobre Organizaciones de Productores de Frutas y Hortalizas. Cambio de objeto social. a) Laproducci贸n, compra, venta, normalizaci贸n, distribuci贸n, acondicionamiento almacenaje, manipulaci贸n, empaquetado y comercializaci贸nde todo tipode productos hortofrut铆colas en estado fresco o refrigerado, as铆 como su exportaci贸n e importaci贸n. b) Establecer lasnormas de conocimiento de la pro. Datos registrales. T 2012 , F 107, S 8, H MU 39269, I/A 13 ( 1.04.11).

Nombramientos. Aud.Supl.: JULIAN PE脩ARANDA GOMEZ. Reelecciones. Auditor: JOAQUIN MARTINEZ ALFONSO. Datosregistrales. T 2012 , F 108, S 8, H MU 39269, I/A 14 ( 1.04.11).

Utilizamos cookies de terceros con finalidades anal铆ticas, de personalizaci贸n, y de publicidad comportamental. Puede configurar ahora el uso de esta tecnolog铆a. Si acepta o contin煤a navegando, consideramos que est谩 de acuerdo con su uso. Mas informaci贸n