Actos BORME de Naturaleza Y Turismo Sl
09 de Mayo de 2017Nombramientos. Apo.Manc.: BARRIO GARCIA DAMIAN;CID ARGILLES JUAN. Datos registrales. T 21811 , F 199, S 8, H M145613, I/A 32 (21.04.17).
21 de Junio de 2016Ceses/Dimisiones. Consejero: DIAZ MERINO FRANCISCO JAVIER. Presidente: DIAZ MERINO FRANCISCO JAVIER. Consejero:JUAN PARETS ANDREU. Secretario: JUAN PARETS ANDREU. Consejero: GOMEZ FRAILE LUIS MIGUEL. Con.Delegado: DIAZMERINO FRANCISCO JAVIER. Nombramientos. Adm. Unico: MAIN CONTROL CORP SL. Representan: DIAZ MERINOFRANCISCO JAVIER. Modificaciones estatutarias. Fecha de Cierre de Ejercicio: 31/10. Modificaci贸n de la retribuci贸n de losadministradores y REFUNDICION DE LA TOTALIDAD DE LOS ESTATUTOS SOCIALES.. Otros conceptos: Cambio del Organo deAdministraci贸n: Consejo de administraci贸n a Administrador 煤nico. Los cargos pasan a tener duraci贸n indefinida. Cambio de objetosocial. Las actividades propias de las Agencias de Viaje. Servicios de asesoramiento, gesti贸n y asistencia prestados a empresas.Elaboraci贸n de estudiosyprospecciones de mercado. Promoci贸n de servicios relacionados con el ocio, la cultura y la naturaleza de lasactividades propias de las agencias de viajes. Datos registrales. T 21811 , F 196, S 8, H M 145613, I/A 31 (13.06.16).
28 de Septiembre de 2015Nombramientos. Auditor: DELOITTE SL. Datos registrales. T 21811 , F 195, S 8, H M 145613, I/A 30 (21.09.15).
24 de Septiembre de 2015Otros conceptos: REVOCADA LA FIRMA AUDITORA "SANPE AUDITORES SLP", PARA EL EJERCICIO DE 2014 EN JUNTAUNIVERSAL DE FECHA 1 DE SEPTIEMBRE DE 2015. Datos registrales. T 21811 , F 195, S 8, H M 145613, I/A 29 (17.09.15).
22 de Octubre de 2014Nombramientos. Apoderado: BARRIO GARCIA DAMIAN. Datos registrales. T 21811 , F 195, S 8, H M 145613, I/A 28 (14.10.14).
21 de Octubre de 2014Declaraci贸n de unipersonalidad. Socio 煤nico: 123 CARIBBEAN TRAVEL SL. Nombramientos. Con.Delegado: DIAZ MERINOFRANCISCO JAVIER. Datos registrales. T 21811 , F 194, S 8, H M 145613, I/A 26 (13.10.14).
Nombramientos. Apoderado: BARRIO GARCIA DAMIAN;JUAN PARETS ANDRES JAVIER;SANZ SERRANO ALBERTO. Datosregistrales. T 21811 , F 194, S 8, H M 145613, I/A 27 (13.10.14).
20 de Junio de 2014Ceses/Dimisiones. Representan: LUMBY GEORGE PETER. Adm. Unico: PROMOMEGAN NEGOCIOS SA. Nombramientos.Consejero: DIAZ MERINO FRANCISCO JAVIER. Presidente: DIAZ MERINO FRANCISCO JAVIER. Consejero: JUAN PARETSANDREU. Secretario: JUAN PARETS ANDREU. Consejero: GOMEZ FRAILE LUIS MIGUEL. Modificaciones estatutarias. Cambiodel Organo de Administraci贸n: Administrador 煤nico a Consejo de administraci贸n. Datos registrales. T 21811 , F 193, S 8, H M145613, I/A 25 (11.06.14).
07 de Abril de 2014Revocaciones. Apoderado: PEDRAZ NAVAS ANTONIO;JIMENEZ HERRANZ ALBERTO. Nombramientos. Apo.Manc.: CANIEGOLEAL CECILIO;FERNANDEZ SANCHEZ CARMEN;PAULINO SABINO PEREZ FERNANDEZ;LUMBY GEORGE PETER. Datosregistrales. T 21811 , F 192, S 8, H M 145613, I/A 24 (28.03.14).
06 de Marzo de 2014Ceses/Dimisiones. Representan: MORA CAROU SUSANA. Nombramientos. Representan: LUMBY GEORGE PETER. Datosregistrales. T 21811 , F 192, S 8, H M 145613, I/A 23 (27.02.14).
31 de Octubre de 2013Ceses/Dimisiones. Adm.Judicial: JIMENEZ HERRANZ ALBERTO;PEDRAZ NAVAS OVIDIO-ANTONIO. Otros conceptos:DEJADA SIN EFECTO LA DESIGNACION DE LOS ADMINISTRADORES JUDICIALES POR RESOLUCION DE FECHA 14 DEOCTUBRE DE 2013. Datos registrales. T 21811 , F 192, S 8, H M 145613, I/A 22 (24.10.13).
22 de Octubre de 2013Fe de erratas: SE PUBLICO POR ERROR EL ACTO DE DECLARACION DE CONCURSO, DEBIENDO QUEDAR ANULADO. Datosregistrales. T 21811 , F 192, S 8, H M 145613, I/A 20 ( 3.10.13).
Otros conceptos: MEDIANTE MANDAMIENTO LIBRADO POR EL JUZGADO N潞 6 DE INSTRUCCION DE MADRID EL 24 DESEPTIEMBRE DE 2013, SE HACE CONSTAR QUE LA RESOLUCION DE 23 DE JULIO DE 2013 QUE MOTIVO LA ANOTACIONLETRA "A", ES FIRME. Datos registrales. T 21811 , F 192, S 8, H M 145613, I/A 20 ( 3.10.13).
18 de Octubre de 2013Nombramientos. Auditor: SANPE AUDITORES SLP. Datos registrales. T 21811 , F 192, S 8, H M 145613, I/A 21 (10.10.13).
11 de Octubre de 2013Situaci贸n concursal. Procedimiento concursal 19/2012. FIRME: Si, Fecha de resoluci贸n 24/09/2013. Auto de declaraci贸n deconcurso. Voluntario. Juzgado: num. 6 JUZGADO DE INSTRUCCION DE MADRID. Juez: DON ELOY VELASCO NU脩EZ.Resoluciones: MANDAMIENTO EXPEDIDO EL DIA 24/09/13 ORDENANDO LA CONVERSION DE LA ANOTACION PREVENTIVALETRA "A"EN INSCRIPCION. Datos registrales. T 21811 , F 192, S 8, H M 145613, I/A 20 ( 3.10.13).
11 de Septiembre de 2013Nombramientos. Adm.Judicial: JIMENEZ HERRANZ ALBERTO;PEDRAZ NAVAS OVIDIO-ANTONIO. Otros conceptos: ELNOMBRAMIENTO DE ADMINISTRADORES JUDICIALES SE REALIZA A LOS SOLOS Y UNICOS EFECTOS DE NOMBRARAUDITOR DE CUENTAS Y APROBAR Y PRESENTAR EN PLAZO LAS CUENTAS ANUALES DE 2012 DE LASOCIEDAD"NATURALEZA Y TURISMO SL". Datos registrales. T 21811 , F 191, S 8, H M 145613, I/A A ( 2.09.13).
11 de Diciembre de 2012Nombramientos. Apoderado: PEDRAZ NAVAS ANTONIO;JIMENEZ HERRANZ ALBERTO. Datos registrales. T 21811 , F 190, S 8,H M 145613, I/A 19 (30.11.12).
07 de Diciembre de 2012Sociedad unipersonal. Cambio de identidad del socio 煤nico: PROMOMEGAN NEGOCIOS SA. Ceses/Dimisiones. Adm. Unico:AUTOPULLMAN JUCAN SL. Representan: SEMPER BELENGUER JOSE VICENTE. Nombramientos. Adm. Unico: PROMOMEGANNEGOCIOS SA. Representan: SEMPER BELENGUER JOSE VICENTE. Datos registrales. T 21811 , F 189, S 8, H M 145613, I/A 17(27.11.12).
Ceses/Dimisiones. Representan: SEMPER BELENGUER JOSE VICENTE. Nombramientos. Representan: MORA CAROUSUSANA. Datos registrales. T 21811 , F 190, S 8, H M 145613, I/A 18 (27.11.12).
17 de Abril de 2012Nombramientos. Apo.Sol.: JIMENEZ HERRANZ ALBERTO. Fe de erratas: SE OMITIO POR ERROR EN LA INSCRIPCION 15& LAPUBLICACION DEL PODER OTORGADO A ALBERTO JIMENEZ HERRANZ. Datos registrales. T 21811 , F 187, S 8, H M 145613,I/A 15 (27.01.11).
10 de Febrero de 2011Sociedad unipersonal. Cambio de identidad del socio 煤nico: AUTOPULLMAN JUCAN SL. Ampliacion del objeto social.PRESTACION DE SERVICIOS PROPIOS DE UNA AGENCIA DE VIAJES MAYORISTA-MINORISTA... Datos registrales. T 21811 , F189, S 8, H M 145613, I/A 16 (28.01.11).
07 de Febrero de 2011Nombramientos. Apoderado: PEDRAZ NAVAS ANTONIO. Datos registrales. T 21811 , F 187, S 8, H M 145613, I/A 15 (27.01.11).
02 de Febrero de 2011Ceses/Dimisiones. Consejero: INVERSIONES GRUDISAN SL;PASCUAL ARIAS GONZALO;PEDRAZ NAVAS ANTONIO.Presidente: INVERSIONES GRUDISAN SL. Cons.Del.Sol: PASCUAL ARIAS GONZALO;INVERSIONES GRUDISAN SL. Vicepresid.:PASCUAL ARIAS GONZALO. Secretario: PEDRAZ NAVAS ANTONIO. Nombramientos. Adm. Unico: AUTOPULLMAN JUCAN SL.Representan: SEMPER BELENGUER JOSE VICENTE. Modificaciones estatutarias. Cambio del Organo de Administraci贸n:Consejo de administraci贸n a Administrador 煤nico. Datos registrales. T 21811 , F 187, S 8, H M 145613, I/A 14 (21.01.11).
15 de Diciembre de 2009Ceses/Dimisiones. Secretario: CHACON GUTIERREZ JOSE LORENZO. Consejero: CHACON GUTIERREZ JOSELORENZO;INVERSIONES GRUDISAN SL. Presidente: INVERSIONES GRUDISAN SL. Con.Delegado: INVERSIONES GRUDISANSL. Consejero: PASCUAL ARIAS GONZALO. Cons.Del.Sol: PASCUAL ARIAS GONZALO. Nombramientos. Consejero:INVERSIONES GRUDISAN SL;PASCUAL ARIAS GONZALO;PEDRAZ NAVAS ANTONIO. Presidente: INVERSIONES GRUDISAN SL.Cons.Del.Sol: PASCUAL ARIAS GONZALO;INVERSIONES GRUDISAN SL. Vicepresid.: PASCUAL ARIAS GONZALO. Secretario: