Buscador CIF Logo

Actos BORME Naturgy Generacion Termica Sl

驴Quieres acceder a la API de EMPRESAS CIF? Obten la informaci贸n de todas las empresas en tiempo real desde tu plataforma.
Ahora con un 25% de DESCUENTO el primer MES. Quiero la API de EMPRESAS

Logo cabecera Naturgy Generacion Termica Sl

Actos BORME Naturgy Generacion Termica Sl - B05324538

Tenemos registrados 19 Actos BORME del Registro Mercantil de Madrid para Naturgy Generacion Termica Sl con CIF B05324538

馃敊 Perfil de Naturgy Generacion Termica Sl
馃洅 Comprar listado completo de Empresas de Madrid

Actos BORME de Naturgy Generacion Termica Sl

20 de Octubre de 2023
Nombramientos. Apo.Sol.: MARTINEZ FERNANDEZ-CASADO CELESTINO;MIJARES COTO LUIS FERNANDO;VICENTERODRIGUEZ ANGEL;MARTINEZ VICTORIA MARIA GEMA;CALLEJA MARTIN MARIA ELENA. Datos registrales. T 42568 , F 13, S8, H M 740012, I/A 20 (13.10.23).

22 de Febrero de 2023
Nombramientos. Apoderado: PALOMAR RUIZ JAVIER. Datos registrales. T 42568 , F 8, S 8, H M 740012, I/A 17 (15.02.23).

Nombramientos. Apoderado: REDONDO GARCIA DE BAQUEDANO ANDONI. Datos registrales. T 42568 , F 12, S 8, H M 740012,I/A 19 (15.02.23).

Nombramientos. Apoderado: UGEDO ALVAREZ-OSSORIO JAVIER;ROSELL HERRERA BORJA;CAMPOS REMIRORAFAEL;VALLEJO HERRADOR FRANCISCO JAVIER;PEREZ FERNANDEZ EDUARDO IGNACIO;MAYORAL BERMEJOANTONIO;FERNANDEZ VILLAR RAUL;MORENO HERNANDEZ SANTIAGO;SAENZ DE SANTAMARIA VALIN JAVIER. Datosregistrales. T 42568 , F 10, S 8, H M 740012, I/A 18 (15.02.23).

28 de Septiembre de 2022
Nombramientos. Apo.Sol.: GAETA GOMEZ ANA ROSA;REIG GALMES MONTSERRAT;RAMON CASAS SARA. Datos registrales.T 42568 , F 8, S 8, H M 740012, I/A 16 (21.09.22).

11 de Abril de 2022
Revocaciones. Apoderado: LOPEZ FERNANDEZ MARCO. Nombramientos. Apoderado: MORALES SCHMIDGREGORIO;MATUTE ALBORECA LAURA;GONZALEZ GARCIA PAZ. Datos registrales. T 42568 , F 7, S 8, H M 740012, I/A 15 (4.04.22).

22 de Diciembre de 2021
Revocaciones. Apoderado: SANCHEZ FERNANDEZ MARIA-JOSE;CORTES TEMPRANO SUSANA;MIJARES COTO LUISFERNANDO. Datos registrales. T 42568 , F 6, S 8, H M 740012, I/A 14 (15.12.21).

21 de Diciembre de 2021
Nombramientos. Apo.Manc.: LASSO DE LA VEGA MARTINEZ EDUARDO;ROSELL HERRERA BORJA;CAMPOS REMIRORAFAEL;BERNALDO DE QUIROS ZUBIZARRETA JOSE MARIA VALNETIN;VALLEJO HERRADOR FRANCISCO JAVIER;MURGATOME JOSE FERNANDO;PRIETO IBA脩EZ JOSE ANTONIO;PEREZ FERNANDEZ EDUARDO IGNACIO. Apo.Sol.: LASSO DE LAVEGA MARTINEZ EDUARDO;ROSELL HERRERA BORJA;CAMPOS REMIRO RAFAEL;BERNALDO DE QUIROS ZUBIZARRETAJOSE MARIA VALENTIN;VALLEJO HERRADOR FRANCISCO JAVIER;MURGA TOME JOSE FERNANDO;PEREZ FERNANDEZEDUARDO IGNACIO;GARROTE MAYORGA JOSE IGNACIO;PRIETO IBA脩EZ JOSE ANTONIO;MORENO HERNANDEZSANTIAGO;MAYORAL BERMEJO ANTONIO;MARTIN LOPEZ-SUEVOS CARLOS. Datos registrales. T 42568 , F 4, S 8, H M740012, I/A 13 (14.12.21).

07 de Diciembre de 2021
Cambio de domicilio social. AVDA DE AMERICA 38 (MADRID). Datos registrales. T 42568 , F 4, S 8, H M 740012, I/A 12(29.11.21).

03 de Diciembre de 2021
Revocaciones. Apoderado: CORTES RODRIGUEZ ANA MARIA;MORALES BAEZA NOHEMI;YLIOPOLO QUIROGA ANALIA. Datosregistrales. T 42568 , F 4, S 8, H M 740012, I/A 11 (26.11.21).

02 de Diciembre de 2021
Nombramientos. Auditor: KPMG AUDITORES SL. Datos registrales. T 42568 , F 4, S 8, H M 740012, I/A 10 (25.11.21).

02 de Noviembre de 2021
Nombramientos. Apoderado: MERINO GARCIA VICENTE. Datos registrales. T 42568 , F 3, S 8, H M 740012, I/A 9 (25.10.21).

15 de Octubre de 2021
Nombramientos. Apo.Sol.: CALLEJA MARTIN MARIA ELENA. Datos registrales. T 41775 , F 138, S 8, H M 740012, I/A 7 (7.10.21).

22 de Septiembre de 2021
Nombramientos. Apo.Sol.: JIMENEZ SOLER GUILLERMO;TAPIA LOPEZ ENRIQUE. Datos registrales. T 41775 , F 133, S 8, H M740012, I/A 2 (15.09.21).

Nombramientos. Apoderado: BOADA PORTILLO MARTA;PALOMAR RUIZ JAVIER;GONZALEZ GARCIA PAZ. Datos registrales. T41775 , F 134, S 8, H M 740012, I/A 3 (15.09.21).

Nombramientos. Apoderado: GOMEZ FEBREL BALTASAR;BOADA PORTILLO MARTA;GARCIA OSMA SILVIA. Datos registrales.T 41775 , F 135, S 8, H M 740012, I/A 4 (15.09.21).

Nombramientos. Apo.Sol.: ORTIZ PERDICES IGNACIO;DIAZ DE TERAN LOPEZ MARIA. Datos registrales. T 41775 , F 136, S 8,H M 740012, I/A 5 (15.09.21).

Nombramientos. Apoderado: CORTES RODRIGUEZ ANA MARIA;MORALES BAEZA NOHEMI;BOADA PORTILLOMARTA;SANCHEZ FERNANDEZ MARIA-JOSE;CORTES TEMPRANO SUSANA;MIJARES COTO LUIS FERNANDO;LOPEZFERNANDEZ MARCO;YLIOPOLO QUIROGA ANALIA;CABALLERO DEL AVELLANAL ANGEL;PUENTE FERNANDEZ ALFREDO.Datos registrales. T 41775 , F 136, S 8, H M 740012, I/A 6 (15.09.21).

07 de Mayo de 2021
Constituci贸n. Comienzo de operaciones: 7.04.21. Objeto social: A).- La generaci贸n de energ铆a el茅ctrica, as铆 como la construcci贸n,operaci贸n, explotaci贸n, mantenimiento y cierre de instalaciones de producci贸n de energ铆a el茅ctrica, t茅rmica, incluy茅ndose entre ellas, amodo enunciativo y no exhaustivo. Domicilio: AVDA DE SAN LUIS 77 (MADRID). Capital: 3.000,00 Euros. Declaraci贸n deunipersonalidad. Socio 煤nico: NATURGY ENERGY GROUP SA. Nombramientos. Adm. Solid.: LARREA PAGUAGAPEDRO;ZARAUZA QUIROS LUIS. Datos registrales. T 41775 , F 130, S 8, H M 740012, I/A 1 (29.04.21).

Utilizamos cookies de terceros con finalidades anal铆ticas, de personalizaci贸n, y de publicidad comportamental. Puede configurar ahora el uso de esta tecnolog铆a. Si acepta o contin煤a navegando, consideramos que est谩 de acuerdo con su uso. Mas informaci贸n