Actos BORME de Navanatura Sl
05 de Marzo de 2020Ceses/Dimisiones. Adm. Unico: NAVARRETE GONZALEZ BUENO CARLOS. Nombramientos. Adm. Unico: NAVARRETERODRIGUEZ CARLOS. Datos registrales. T 163, L 121, F 37, S 8, H AV 2575, I/A 11 (26.02.20).
Nombramientos. Apoderado: CARLOS NAVARRETE GONZALEZ-BUENO. Datos registrales. T 163, L 121, F 37, S 8, H AV 2575,I/A 12 (27.02.20).
20 de Diciembre de 2017Nombramientos. Apo.Sol.: NAVARRETE RODRIGUEZ CARLOS. Datos registrales. T 91, L 49, F 73, S 8, H AV 2575, I/A 10(28.11.17).
08 de Enero de 2016Nombramientos. Apoderado: RODRIGUEZ CARRASCO ALICIA. Datos registrales. T 91, L 49, F 73, S 8, H AV 2575, I/A 9(23.12.15).
07 de Abril de 2015Reducci贸n de capital. Importe reducci贸n: 45.000,00 Euros. Resultante Suscrito: 135.000,00 Euros. Datos registrales. T 91, L 49, F73, S 8, H AV 2575, I/A 8 (25.03.15).
23 de Enero de 2015Nombramientos. Apoderado: NAVARRETE RODRIGUEZ CARLOS. Datos registrales. T 91, L 49, F 72, S 8, H AV 2575, I/A 5 (5.01.15).
Nombramientos. Apoderado: SANZ ESTEBAN EDUARDO. Datos registrales. T 91, L 49, F 73, S 8, H AV 2575, I/A 6 ( 5.01.15).
Nombramientos. Apoderado: HERRANZ TEJEDOR EVA. Datos registrales. T 91, L 49, F 73, S 8, H AV 2575, I/A 7 ( 5.01.15).
05 de Septiembre de 2011Nombramientos. Apoderado: HERRANZ TEJEDOR MARIA DALIA. Datos registrales. T 91, L 49, F 72, S 8, H AV 2575, I/A 4(10.08.11).