Actos BORME de Navento Technologies Sl
20 de Diciembre de 2023Revocaciones. Apoderado: MAROTO BOHOYO JESUS. Datos registrales. T 38998 , F 147, S 8, H M 404632, I/A 57 (13.12.23).
23 de Noviembre de 2023Nombramientos. Apoderado: BELLSOLELL GOMIS JORDI. Datos registrales. T 38998 , F 145, S 8, H M 404632, I/A 56 (16.11.23).
22 de Noviembre de 2023Ceses/Dimisiones. Representan: BELLSOLELL GOMIS JORDI. Nombramientos. Representan: REVENGA BUIGUES CESAR.Datos registrales. T 38998 , F 145, S 8, H M 404632, I/A 55 (15.11.23).
02 de Noviembre de 2023Nombramientos. Apo.Sol.: HERRANZ CID JOSE ANTONIO. Datos registrales. T 38998 , F 144, S 8, H M 404632, I/A 54(25.10.23).
17 de Octubre de 2023Sociedad unipersonal. Cambio de identidad del socio 煤nico: EZENTIS SOLUCIONES TECNOLOGICAS E INGENIERIA SL.Datos registrales. T 38998 , F 144, S 8, H M 404632, I/A 53 ( 9.10.23).
11 de Octubre de 2023Revocaciones. Apo.Man.Soli: GARCIA MERCHAN LUIS. Datos registrales. T 38998 , F 144, S 8, H M 404632, I/A 52 ( 4.10.23).
25 de Abril de 2023Ampliaci贸n de capital. Capital: 200,00 Euros. Resultante Suscrito: 14.866,00 Euros. Datos registrales. T 38998 , F 143, S 8, H M404632, I/A 51 (18.04.23).
30 de Marzo de 2023Revocaciones. Apo.Manc.: LOPEZ GARCIA ANGEL LUIS. Datos registrales. T 38998 , F 143, S 8, H M 404632, I/A 50 (23.03.23).
15 de Febrero de 2023Revocaciones. Apoderado: ROBLES ALVAREZ OSCAR. Datos registrales. T 38998 , F 143, S 8, H M 404632, I/A 49 ( 8.02.23).
30 de Enero de 2023Nombramientos. Apo.Man.Soli: ARANGUREN ORIOL LUIS MARIA. Datos registrales. T 38998 , F 142, S 8, H M 404632, I/A 48(23.01.23).
05 de Enero de 2023Revocaciones. Apoderado: MARTINEZ MARTIN TAMARA. Datos registrales. T 38998 , F 141, S 8, H M 404632, I/A 47 (29.12.22).
30 de Junio de 2022Revocaciones. Apo.Man.Soli: MARI脩AS LAGE CARLOS. Datos registrales. T 38998 , F 141, S 8, H M 404632, I/A 45 (23.06.22).
20 de Junio de 2022Ceses/Dimisiones. Representan: MARI脩AS LAGE CARLOS. Nombramientos. Representan: BELLSOLELL GOMIS JORDI. Datosregistrales. T 38998 , F 141, S 8, H M 404632, I/A 44 (13.06.22).
12 de Abril de 2022Revocaciones. Apoderado: GONZALEZ SANCHEZ FERNANDO;DE CASSO PEREZ JORGE. Apo.Man.Soli: BARON LOPEZIGNACIO;BETANCOR SANTANA PEDRO. Datos registrales. T 38998 , F 141, S 8, H M 404632, I/A 43 ( 5.04.22).
04 de Abril de 2022Ceses/Dimisiones. Representan: GOMEZ FERNANDEZ JOSE LUIS. Nombramientos. Representan: MARI脩AS LAGE CARLOS.Datos registrales. T 38998 , F 140, S 8, H M 404632, I/A 42 (28.03.22).
04 de Febrero de 2022Ceses/Dimisiones. Representan: GONZALEZ SANCHEZ FERNANDO. Nombramientos. Representan: GOMEZ FERNANDEZ
24 de Noviembre de 2021Revocaciones. Apoderado: BARRIO GARCIA DAMIAN. Datos registrales. T 38998 , F 140, S 8, H M 404632, I/A 40 (17.11.21).
05 de Octubre de 2021Sociedad unipersonal. Cambio de identidad del socio 煤nico: EZENTIS FIELD FACTORY SOCIEDAD LIMITADA. Datosregistrales. T 38998 , F 140, S 8, H M 404632, I/A 39 (28.09.21).
22 de Julio de 2021Nombramientos. Apoderado: ROBLES ALVAREZ OSCAR. Datos registrales. T 38998 , F 137, S 8, H M 404632, I/A 37 (15.07.21).
Nombramientos. Apoderado: MARTINEZ MARTIN TAMARA. Datos registrales. T 38998 , F 138, S 8, H M 404632, I/A 38(15.07.21).
24 de Septiembre de 2020Nombramientos. Apo.Man.Soli: BETANCOR SANTANA PEDRO. Datos registrales. T 38998 , F 135, S 8, H M 404632, I/A 36(17.09.20).
31 de Mayo de 2019Nombramientos. Apoderado: BARRIO GARCIA DAMIAN. Datos registrales. T 28644 , F 19, S 8, H M 404632, I/A 35 (24.05.19).
26 de Octubre de 2018Revocaciones. Apoderado: MERINO LANZA MANUEL JOSE. Nombramientos. Apo.Man.Soli: BARON LOPEZ IGNACIO. Datosregistrales. T 28644 , F 17, S 8, H M 404632, I/A 34 (18.10.18).
09 de Marzo de 2018Nombramientos. Apoderado: MAROTO BOHOYO JESUS. Datos registrales. T 28644 , F 17, S 8, H M 404632, I/A 33 ( 2.03.18).
27 de Febrero de 2017Nombramientos. Apo.Manc.: LOPEZ GARCIA ANGEL LUIS. Datos registrales. T 28644 , F 14, S 8, H M 404632, I/A 31 (17.02.17).
Nombramientos. Apo.Man.Soli: GARCIA MERCHAN LUIS. Datos registrales. T 28644 , F 15, S 8, H M 404632, I/A 32 (17.02.17).
31 de Octubre de 2016Nombramientos. Apoderado: MERINO LANZA MANUEL JOSE. Datos registrales. T 28644 , F 13, S 8, H M 404632, I/A 30(21.10.16).
15 de Marzo de 2016Ampliaci贸n de capital. Capital: 1.000,00 Euros. Resultante Suscrito: 14.666,00 Euros. Datos registrales. T 28644 , F 12, S 8, H M404632, I/A 29 ( 8.03.16).
25 de Febrero de 2016Cambio de domicilio social. C/ SANTA LEONOR 65 - EDIFICIO B (MADRID). Datos registrales. T 28644 , F 12, S 8, H M 404632,I/A 28 (18.02.16).
18 de Diciembre de 2015Ceses/Dimisiones. Representan: GARCIA-DURAN DE BAYO MANUEL. Nombramientos. Representan: GONZALEZ SANCHEZFERNANDO. Datos registrales. T 28644 , F 11, S 8, H M 404632, I/A 27 (10.12.15).
16 de Octubre de 2015Revocaciones. Apoderado: PASCUAL HORAS CRISTINA;GARRIDO RAMOS FERNANDO. Apo.Man.Soli: ALVAREZ DIAZ DECERIO CARLOS. Datos registrales. T 28644 , F 11, S 8, H M 404632, I/A 26 ( 8.10.15).
25 de Septiembre de 2015Modificaciones estatutarias. SE MODIFICA EL ARTICULO 9 DE LOS ESTATUTOS SOCIALES. Datos registrales. T 28644 , F 11,S 8, H M 404632, I/A 25 (17.09.15).
24 de Julio de 2015Declaraci贸n de unipersonalidad. Socio 煤nico: NAVERGGI SA. Datos registrales. T 28644 , F 11, S 8, H M 404632, I/A 24(15.07.15).
20 de Noviembre de 2012Nombramientos. Apo.Man.Soli: MARI脩AS LAGE CARLOS;ALVAREZ DIAZ DE CERIO CARLOS. Datos registrales. T 28644 , F 9,S 8, H M 404632, I/A 23 ( 6.11.12).
13 de Agosto de 2012Modificaciones estatutarias. Art铆culo de los estatutos: 2. Objeto.-. Ampliacion del objeto social. Ingenier铆a, dise帽o, proyectos,desarrollo, instalaci贸n suministro, mantenimiento, consultor铆a,formaci贸n, marketing relativa sistemas de seguridad, sistemas detransporte) controlde transporte, sistemasinlarm谩ticosy aplicaciones inform谩ticas. Datos registrales. T 28644 , F 9, S 8, H M 404632,I/A 22 ( 1.08.12).
07 de Agosto de 2012Ceses/Dimisiones. Secretario: MARTINEZ GONZALEZ LAURA. Consejero: PASCUAL HORAS CRISTINA;ARMERO MONTESMARIO;GARRIDO RAMOS FERNANDO. Con.Delegado: ARMERO MONTES MARIO. Presidente: ARMERO MONTES MARIO.Revocaciones. Apo.Manc.: MARCOS GALLEGO DAVID. Apo.Man.Soli: MALDONADO CARRASCO JOSE MARIA. Apoderado:GONZALEZ SANCHEZ FERNANDO;GARRIDO RAMOS FERNANDO. Apo.Man.Soli: PASCUAL HORAS CRISTINA;GOMEZ CUESTAIGNACIO MARIA. Nombramientos. Adm. Unico: GRUPO EZENTIS SA. Representan: GARCIA-DURAN DE BAYO MANUEL.Apoderado: GONZALEZ SANCHEZ FERNANDO;MALDONADO CARRASCO JOSE MARIA;DE CASSO PEREZ JORGE;PASCUALHORAS CRISTINA;GARRIDO RAMOS FERNANDO. Modificaciones estatutarias. Cambio del Organo de Administraci贸n: Consejode administraci贸n a Administrador 煤nico. Datos registrales. T 28644 , F 7, S 8, H M 404632, I/A 21 (26.07.12).
02 de Septiembre de 2011Revocaciones. Apoderado: SANCHEZ SANTODOMINGO IGNACIO;PASCUAL HORAS CRISTINA. Nombramientos. Apo.Man.Soli:PASCUAL HORAS CRISTINA;GOMEZ CUESTA IGNACIO MARIA. Datos registrales. T 28644 , F 4, S 8, H M 404632, I/A 20(23.08.11).
05 de Agosto de 2011Nombramientos. Apoderado: GARRIDO RAMOS FERNANDO. Datos registrales. T 28644 , F 1, S 8, H M 404632, I/A 19(26.07.11).
25 de Marzo de 2011Nombramientos. Apoderado: GONZALEZ SANCHEZ FERNANDO. Datos registrales. T 25547 , F 89, S 8, H M 404632, I/A 18(15.03.11).
07 de Marzo de 2011Ceses/Dimisiones. Representan: BENEDIT GOMEZ SANTIAGO. Adm. Unico: GRUPO EZENTIS SA. Nombramientos. Consejero:PASCUAL HORAS CRISTINA;ARMERO MONTES MARIO;GARRIDO RAMOS FERNANDO. Secretario: MARTINEZ GONZALEZLAURA. Con.Delegado: ARMERO MONTES MARIO. Presidente: ARMERO MONTES MARIO. Modificaciones estatutarias. Cambiodel Organo de Administraci贸n: Administrador 煤nico a Consejo de administraci贸n. Datos registrales. T 25547 , F 89, S 8, H M 404632,I/A 17 (24.02.11).
01 de Marzo de 2011Ampliaci贸n de capital. Capital: 1.000,00 Euros. Resultante Suscrito: 13.666,00 Euros. Datos registrales. T 25547 , F 89, S 8, H M404632, I/A 16 (17.02.11).
22 de Febrero de 2011Revocaciones. Apoderado: SANCHEZ SANTODOMINGO IGNACIO. Otros conceptos: MODIFICADO el poder conferido a DONIGNACIO SANCHEZ SANTODOMINGO con fecha 03/09/2009. Datos registrales. T 25547 , F 86, S 8, H M 404632, I/A 15 (10.02.11).
30 de Diciembre de 2010Ceses/Dimisiones. Auditor: PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES SL. Datos registrales. T 25547 , F 86, S 8, H M404632, I/A 14 (21.12.10).
15 de Noviembre de 2010Nombramientos. Apoderado: SANCHEZ SANTODOMINGO IGNACIO. Datos registrales. T 25547 , F 84, S 8, H M 404632, I/A 13 (2.11.10).
08 de Abril de 2010Cambio de domicilio social. C/ FEDERICO MOMPOU - N潞5, EDIFICIO 2 DEL PARQUE (MADRID). Datos registrales. T 25547 , F84, S 8, H M 404632, I/A 12 (25.03.10).
16 de Marzo de 2010Revocaciones. Apo.Man.Soli: PRIMO GONZALEZ FELIX;GARCIA GARCIA ENRIQUE;FERNANDEZ MORALES RAMON;PELAEZCOMAS EDUARDO LUIS. Apo.Manc.: CARMONA GONZALEZ AUGUSTO CARLOS. Apoderado: VELASCO ARRIBAS JESUS.Datos registrales. T 25547 , F 84, S 8, H M 404632, I/A 11 ( 4.03.10).
10 de Septiembre de 2009Nombramientos. Apoderado: SANCHEZ SANTODOMINGO IGNACIO;PASCUAL HORAS CRISTINA. Datos registrales. T 25547 , F81, S 8, H M 404632, I/A 10 (31.08.09).
31 de Marzo de 2009Otros conceptos: MODIFICADO EL PODER OTORGADO A FAVOR DE DON JOSE MARIA MALDONADO CARRASCO EN LAINSCRIPCION 6&. Datos registrales. T 25547 , F 81, S 8, H M 404632, I/A 9 (18.03.09).
16 de Febrero de 2009Ceses/Dimisiones. Representan: LOPEZ CASTA脩O JULIO. Nombramientos. Representan: BENEDIT GOMEZ SANTIAGO. Datosregistrales. T 25547 , F 81, S 8, H M 404632, I/A 8 ( 4.02.09).