Buscador CIF Logo

Actos BORME Naviera Direct Africa Line Sa

¿Quieres acceder a la API de EMPRESAS CIF? Obten la información de todas las empresas en tiempo real desde tu plataforma.
Ahora con un 25% de DESCUENTO el primer MES. Quiero la API de EMPRESAS

Logo cabecera Naviera Direct Africa Line Sa

Actos BORME Naviera Direct Africa Line Sa - A86586286

Tenemos registrados 29 Actos BORME del Registro Mercantil de Madrid para Naviera Direct Africa Line Sa con CIF A86586286

🔙 Perfil de Naviera Direct Africa Line Sa
🛒 Comprar listado completo de Empresas de Madrid

Actos BORME de Naviera Direct Africa Line Sa

14 de Diciembre de 2023
Reelecciones. Auditor: PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES SL. Datos registrales. T 32787 , F 203, S 8, H M 535716,I/A 29 ( 5.12.23).

30 de Junio de 2022
Declaración de unipersonalidad. Socio único: GRUPO MARTINEZ ABOLAFIO 1970 SL. Datos registrales. T 32787 , F 202, S 8,H M 535716, I/A 27 (23.06.22).

Revocaciones. Apo.Manc.: RODRIGUEZ SANCHEZ GUSTAVO;MELERO FERNANDEZ GEMA;HERNANDEZ DE ANDRADECARLOS. Nombramientos. Apo.Manc.: RODRIGUEZ SANCHEZ GUSTAVO;MELERO FERNANDEZ GEMA;MEDINA DELGADOANTONO JESUS;BONET MANRIQUE DE LARA FERNANDO;HERNANDEZ DE ANDRADE CARLOS. Datos registrales. T 32787 , F202, S 8, H M 535716, I/A 28 (23.06.22).

19 de Abril de 2022
Ceses/Dimisiones. Consejero: RODRIGUEZ SANCHEZ GUSTAVO. Datos registrales. T 32787 , F 202, S 8, H M 535716, I/A 26 (8.04.22).

26 de Noviembre de 2021
Ceses/Dimisiones. Consejero: MONTESDEOCA CASADO ANTONIO. Revocaciones. Apo.Manc.: MARTIN-SIERRA BALIBREAFRANCISCO;MBOMIO AVANG FRANCISCA;OLVEIRA BOO MANUEL;MONTESDEOCA CASADO ANTONIO;MELERO FERNANDEZGEMA;HERNANDEZ DE ANDRADE CARLOS. Nombramientos. Consejero: MARTINEZ GOMEZ BERTA. Apo.Manc.: RODRIGUEZSANCHEZ GUSTAVO;MELERO FERNANDEZ GEMA;HERNANDEZ DE ANDRADE CARLOS. Datos registrales. T 32787 , F 201, S8, H M 535716, I/A 25 (19.11.21).

20 de Julio de 2021
Reelecciones. Consejero: MARTINEZ MPANGA JOSE ANTONIO. Presidente: MARTINEZ MPANGA JOSE ANTONIO. Cambio dedomicilio social. C/ ANTONIO GONZALEZ ECHARTE 1 1º (MADRID). Datos registrales. T 32787 , F 201, S 8, H M 535716, I/A 24(13.07.21).

17 de Marzo de 2021
Reelecciones. Auditor: PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES SL. Datos registrales. T 32787 , F 200, S 8, H M 535716,I/A 23 (10.03.21).

15 de Febrero de 2021
Ceses/Dimisiones. Consejero: OLVEIRA BOO MANUEL. Revocaciones. Apo.Manc.: OLVEIRA BOO MANUEL;MELEROFERNANDEZ GEMA;HERNANDEZ DE ANDRADE CARLOS. Nombramientos. Consejero: MONTESDEOCA CASADO ANTONIO.Apo.Manc.: MONTESDEOCA CASADO ANTONIO;MELERO FERNANDEZ GEMA;HERNANDEZ DE ANDRADE CARLOS. Datosregistrales. T 32787 , F 200, S 8, H M 535716, I/A 22 ( 8.02.21).

15 de Enero de 2020
Ceses/Dimisiones. Consejero: DE SANTIAGO MARTINEZ JOSE MARIA. Revocaciones. Apo.Manc.: DE SANTIAGO MARTINEZJOSE MARIA;OLVEIRA BOO MANUEL;HERNANDEZ DE ANDRADE CARLOS. Nombramientos. Consejero: RODRIGUEZSANCHEZ GUSTAVO;MELERO FERNANDEZ GEMA. Apo.Manc.: OLVEIRA BOO MANUEL;MELERO FERNANDEZGEMA;HERNANDEZ DE ANDRADE CARLOS. Datos registrales. T 32787 , F 199, S 8, H M 535716, I/A 21 ( 8.01.20).

24 de Octubre de 2019
Nombramientos. Apoderado: RODRIGUEZ SANCHEZ GUSTAVO;DIAZ SOSA JOSE MIGUEL;FELIPE SANTOS RAQUEL. Datosregistrales. T 32787 , F 198, S 8, H M 535716, I/A 20 (17.10.19).

02 de Marzo de 2018
Nombramientos. Auditor: PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES SL. Datos registrales. T 32787 , F 198, S 8, H M 535716,I/A 19 (22.02.18).

28 de Agosto de 2017
Cambio de domicilio social. C/ ANTONIO GONZALEZ ECHARTE 1 3ª (MADRID). Datos registrales. T 32787 , F 198, S 8, H M535716, I/A 18 (21.08.17).

29 de Agosto de 2016
Ceses/Dimisiones. Consejero: MBOMIO AVANG FRANCISCA. Revocaciones. Apo.Manc.: MBOMIO AVANGFRANCISCA;OLVEIRA BOO MANUEL. Apo.Man.Soli: HERNANDEZ DE ANDRADE CARLOS. Nombramientos. Consejero: DESANTIAGO MARTINEZ JOSE MARIA. Apo.Manc.: DE SANTIAGO MARTINEZ JOSE MARIA;OLVEIRA BOO MANUEL;HERNANDEZDE ANDRADE CARLOS. Apo.Sol.: HERNANDEZ DE ANDRADE CARLOS. Datos registrales. T 32787 , F 196, S 8, H M 535716, I/A17 (19.08.16).

01 de Abril de 2015
Ceses/Dimisiones. Consejero: MASIE MEBUY PEDRO DAMIAN. Presidente: MBOMIO AVANG FRANCISCA. Consejero: GARCIASANSIGRE EDUARDO. Nombramientos. Consejero: MARTINEZ MPANGA JOSE ANTONIO;OLVEIRA BOO MANUEL. Presidente:MARTINEZ MPANGA JOSE ANTONIO. Modificaciones estatutarias. 5. Acciones/Participaciones.-. Datos registrales. T 32787 , F196, S 8, H M 535716, I/A 16 (23.03.15).

19 de Febrero de 2015
Nombramientos. Auditor: GARCIA BELLO RICARDO. Aud.Supl.: FERNANDEZ SANCHEZ JOAQUIN JACINTO. Datos registrales.T 32787 , F 195, S 8, H M 535716, I/A 15 (12.02.15).

06 de Febrero de 2015
Revocaciones. Apo.Manc.: OLVEIRA BOO MANUEL;CARBALLAL LOPEZ EDUARDO. Datos registrales. T 32787 , F 195, S 8, H M535716, I/A 14 (29.01.15).

13 de Enero de 2015
Modificaciones estatutarias. 12. Administración y Representacion.-. Datos registrales. T 32787 , F 195, S 8, H M 535716, I/A 13(30.12.14).

21 de Noviembre de 2014
Nombramientos. Apo.Man.Soli: HERNANDEZ DE ANDRADE CARLOS. Apo.Manc.: MBOMIO AVANG FRANCISCA;OLVEIRA BOOMANUEL. Datos registrales. T 29774 , F 182, S 8, H M 535716, I/A 12 (14.11.14).

04 de Julio de 2014
Ceses/Dimisiones. Consejero: MARTIN-SIERRA BALIBREA FRANCISCO. Nombramientos. Consejero: GARCIA SANSIGREEDUARDO. Modificaciones estatutarias. Artículo de los estatutos: 2. Domicilio.-. MODIFICACION DEL ARTICULO 5º DE LOSESTATUTOS.- CAPITAL. SE MODIFICA EL ARTICULO 9º DE LOS ESTATUTOS.- CONVOCATORIA.- . Cambio de domiciliosocial. C/ ORENSE 25 - 2º-B (MADRID). Datos registrales. T 29774 , F 181, S 8, H M 535716, I/A 11 (27.06.14).

21 de Mayo de 2014
Ceses/Dimisiones. Con.Delegado: MARTIN-SIERRA BALIBREA FRANCISCO. Secretario: ORTIZ GOMEZ REINOLFO.Nombramientos. SecreNoConsj: HERNANDEZ DE ANDRADE CARLOS TOMAS. Datos registrales. T 29774 , F 180, S 8, H M535716, I/A 9 (12.05.14).

Nombramientos. Apo.Manc.: MBOMIO AVANG FRANCISCA;OLVEIRA BOO MANUEL. Datos registrales. T 29774 , F 180, S 8, H

06 de Mayo de 2014
Nombramientos. Apo.Manc.: OLVEIRA BOO MANUEL;CARBALLAL LOPEZ EDUARDO. Datos registrales. T 29774 , F 179, S 8, HM 535716, I/A 8 (25.04.14).

18 de Octubre de 2013
Cancelaciones de oficio de nombramientos. Con.Delegado: MARTIN-SIERRA BALIBREA FRANCISCO. Nombramientos.Con.Delegado: MARTIN-SIERRA BALIBREA FRANCISCO. Datos registrales. T 29774 , F 179, S 8, H M 535716, I/A 7 ( 9.10.13).

02 de Septiembre de 2013
Reelecciones. Con.Delegado: MARTIN-SIERRA BALIBREA FRANCISCO. Datos registrales. T 29774 , F 179, S 8, H M 535716, I/A6 (21.08.13).

30 de Agosto de 2013
Ceses/Dimisiones. Consejero: MURILLO SAN MIGUEL RAFAEL. Revocaciones. Apo.Manc.: MURILLO SAN MIGUEL RAFAEL.Datos registrales. T 29774 , F 178, S 8, H M 535716, I/A 5 (21.08.13).

05 de Junio de 2013
Nombramientos. Con.Delegado: MARTIN-SIERRA BALIBREA FRANCISCO. Datos registrales. T 29774 , F 178, S 8, H M 535716,I/A 4 (28.05.13).

13 de Marzo de 2013
Revocaciones. Apoderado: MURILLO SAN MIGUEL RAFAEL. Nombramientos. Apo.Manc.: MURILLO SAN MIGUELRAFAEL;MARTIN-SIERRA BALIBREA FRANCISCO. Datos registrales. T 29774 , F 177, S 8, H M 535716, I/A 3 ( 5.03.13).

11 de Diciembre de 2012
Constitución. Comienzo de operaciones: 8.11.12. Objeto social: FOMENTO DE BUQUES EN TODAS SUS MODALIDADES.CONTRATACION DE TODO TIPO DE SERVICIOS PORTUARIOS SUMINISTRO DE BUQUES. Domicilio: C/ ORENSE 9 3º B(MADRID). Capital: 60.000,00 Euros. Nombramientos. Consejero: MBOMIO AVANG FRANCISCA;MASIE MEBUY PEDRODAMIAN;MARTIN-SIERRA BALIBREA FRANCISCO;MURILLO SAN MIGUEL RAFAEL. Presidente: MBOMIO AVANG FRANCISCA.Secretario: ORTIZ GOMEZ REINOLFO. Datos registrales. T 29774 , F 176, S 8, H M 535716, I/A 1 (28.11.12).

Nombramientos. Apoderado: MURILLO SAN MIGUEL RAFAEL. Datos registrales. T 29774 , F 177, S 8, H M 535716, I/A 2(30.11.12).

Utilizamos cookies de terceros con finalidades analíticas, de personalización, y de publicidad comportamental. Puede configurar ahora el uso de esta tecnología. Si acepta o continúa navegando, consideramos que está de acuerdo con su uso. Mas información