Buscador CIF Logo

Actos BORME Negocios De La Automocion Sa

驴Quieres acceder a la API de EMPRESAS CIF? Obten la informaci贸n de todas las empresas en tiempo real desde tu plataforma.
Ahora con un 25% de DESCUENTO el primer MES. Quiero la API de EMPRESAS

Logo cabecera Negocios De La Automocion Sa

Actos BORME Negocios De La Automocion Sa - A28009504

Tenemos registrados 15 Actos BORME del Registro Mercantil de Madrid para Negocios De La Automocion Sa con CIF A28009504

馃敊 Perfil de Negocios De La Automocion Sa
馃洅 Comprar listado completo de Empresas de Madrid

Actos BORME de Negocios De La Automocion Sa

24 de Enero de 2017
Extinci贸n. Fe de erratas: SE OMITIO POR ERROR EN LA NOTA AL MARGEN DE LA INSCRIPCION 201 DE FECHA 05/01/2016 LAPUBLICACION DEL ACTO DE EXTINCION DE LA SOCIEDAD. Datos registrales. T 2629 , F 171, S 8, H M 45676, I/A201-M (5.01.17).

13 de Enero de 2017
Otros conceptos: A LOS EFECTOS DE LO DISPUESTO EN EL ARTICULO 233.2 DEL RRM HA SIDO COMUNICADA A ESTEREGISTRO LA EXTINCION SIN LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD QUE ES OBJETO DE LA PRESENTE HOJA QUE HA SIDOABSORBIDA POR "RENAULT ESPA脩A SA" INSCRITA EN EL RM DE VALLADOLID, SEGUN INS 877陋, FOLIO 88, TOMO 1005,HOJA VA-240. Datos registrales. T 2629 , F 171, S 8, H M 45676, I/A201-M ( 5.01.17).

16 de Diciembre de 2016
Otros conceptos: Nota marginal de cierre provisional de la hoja registral por plazo de seis meses de conformidad con lo preceptuadoen el art铆culo 231 del RRM. Datos registrales. T 2629 , F 170, S 8, H M 45676, I/A 201M ( 9.12.16).

06 de Julio de 2016
Reelecciones. Consejero: MORALES ORTA ANTONIO. Datos registrales. T 2629 , F 170, S 8, H M 45676, I/A 201 (28.06.16).

12 de Enero de 2016
Sociedad unipersonal. Cambio de identidad del socio 煤nico: RENAULT ESPA脩A SA. Datos registrales. T 2629 , F 169, S 8, HM 45676, I/A 199 ( 4.01.16).

Reducci贸n de capital. Importe reducci贸n: 34.318,80 Euros. Resultante Suscrito: 3.577.081,20 Euros. Otros conceptos:RENUNERACION Y READJUDICACION DE ACCIONES.- Datos registrales. T 2629 , F 169, S 8, H M 45676, I/A 200 ( 4.01.16).

05 de Agosto de 2014
Reelecciones. Consejero: RODRIGUEZ GALAN DE CONTES D'ESGRANGES MARIA LUISA. Secretario: RODRIGUEZ GALAN DECONTES D'ESGRANGES MARIA LUISA. Datos registrales. T 2629 , F 169, S 8, H M 45676, I/A 198 (28.07.14).

24 de Abril de 2014
Ceses/Dimisiones. Consejero: DE LOS MOZOS OBISPO JOSE VICENTE. Presidente: DE LOS MOZOS OBISPO JOSE VICENTE.Nombramientos. Consejero: LOPEZ RAMON Y CAJAL JOSE ANTONIO. Presidente: LOPEZ RAMON Y CAJAL JOSE ANTONIO.Con.Delegado: LOPEZ RAMON Y CAJAL JOSE ANTONIO. Datos registrales. T 2629 , F 168, S 8, H M 45676, I/A 197 (15.04.14).

27 de Septiembre de 2012
Ceses/Dimisiones. Consejero: JOURNOIS PHILIPPE PIERRE. Nombramientos. Consejero: MORALES ORTA ANTONIO. Datosregistrales. T 2629 , F 168, S 8, H M 45676, I/A 196 (18.09.12).

20 de Marzo de 2012
Ceses/Dimisiones. Consejero: LAURENT JEAN PIERRE. Con.Delegado: LAURENT JEAN PIERRE. Presidente: LAURENT JEANPIERRE. Nombramientos. Consejero: DE LOS MOZOS OBISPO JOSE VICENTE. Presidente: DE LOS MOZOS OBISPO JOSEVICENTE. Datos registrales. T 2629 , F 167, S 8, H M 45676, I/A 195 ( 7.03.12).

29 de Junio de 2011
Reelecciones. Consejero: RODRIGUEZ GALAN DE CONTES D'ESGRANGES MARIA LUISA. Secretario: RODRIGUEZ GALAN DECONTES D'ESGRANGES MARIA LUISA. Consejero: JOURNOIS PHILIPPE PIERRE. Datos registrales. T 2629 , F 166, S 8, H M45676, I/A 194 (16.06.11).

14 de Junio de 2011
Revocaciones. Apo.Man.Soli: PINTADO SUAREZ JUAN ANTONIO. Nombramientos. Apoderado: BORREGO ROMO LOURDES.Datos registrales. T 2629 , F 166, S 8, H M 45676, I/A 193 ( 2.06.11).

14 de Mayo de 2009
Nombramientos. Apo.Sol.: CLAVERO FERNANDEZ DE CORDOVA ISABEL;FERNANDEZ MIGUELEZ MARIA ALMUDENA. Datosregistrales. T 2629 , F 166, S 8, H M 45676, I/A 192 ( 5.05.09).

03 de Marzo de 2009
Ceses/Dimisiones. Consejero: FERNANDEZ DE SEVILLA RIBOSA JUAN ANTONIO. Presidente: FERNANDEZ DE SEVILLARIBOSA JUAN ANTONIO. Con.Delegado: FERNANDEZ DE SEVILLA RIBOSA JUAN ANTONIO. Nombramientos. Consejero:LAURENT JEAN PIERRE. Con.Delegado: LAURENT JEAN PIERRE. Presidente: LAURENT JEAN PIERRE. Otros conceptos:REVOCADAS LAS FACULTADES CONFERIDAS A FAVOR DE DON JOSE ANTONIO FERNANDEZ DE SEVILLA Y RIBOSA,SEGUN ESCRITURAS QUE ORIGINARON LAS INSCRIPCIONES 173&, 180& Y 185&. Datos registrales. T 2629 , F 165, S 8, H M45676, I/A 191 (19.02.09).

05 de Febrero de 2009
Revocaciones. Apoderado: GUERRA MERCHAN FRANCISCO. Datos registrales. T 2629 , F 165, S 8, H M 45676, I/A 190(26.01.09).

Utilizamos cookies de terceros con finalidades anal铆ticas, de personalizaci贸n, y de publicidad comportamental. Puede configurar ahora el uso de esta tecnolog铆a. Si acepta o contin煤a navegando, consideramos que est谩 de acuerdo con su uso. Mas informaci贸n