Actos BORME de Nemba Rch Sl
19 de Julio de 2023Nombramientos. AUDIT.CUENT.: AVRP AUDITORES SL. Datos registrales. T 46511 , F 14, S 8, H B 181501, I/A 25 (10.07.23).
27 de Julio de 2022Ampliaci贸n de capital. Capital: 6.160,00 Euros. Resultante Suscrito: 12.320,00 Euros. Datos registrales. T 46511 , F 13, S 8, H B181501, I/A 24 (19.07.22).
18 de Enero de 2022Cambio de domicilio social. AV DIAGONAL Num.602 P.1 PTA.1 (BARCELONA). Datos registrales. T 46511 , F 13, S 8, H B181501, I/A 23 ( 5.01.22).
20 de Noviembre de 2020Ampliaci贸n de capital. Capital: 2.660,00 Euros. Resultante Suscrito: 6.160,00 Euros. Modificaciones estatutarias. ARTICULO 7-.-CREACION DE CLASES DE PARTICIPACIONES SOCIALES;ARTICULO 19.-RETRIBUCION DEL ORGANO DE ADMINISTRACION.Datos registrales. T 46511 , F 12, S 8, H B 181501, I/A 22 (12.11.20).
10 de Noviembre de 2020Revocaciones. ADM.UNICO: GIMENEZ MARTINEZ ALEJANDRO. Nombramientos. CONSEJERO: COMAGFER SA.PRESIDENTE: COMAGFER SA. REPR.143 RRM: GIMENEZ FLORENCIO ANTONIO. CONSEJERO: CLOWN LOACH SL.SECRETARIO: CLOWN LOACH SL. CONS.DEL.SOL: CLOWN LOACH SL. REPR.143 RRM: GIMENEZ MARTINEZ ALEJANDRO.CONSEJERO: MARAINA KOA SL. REPR.143 RRM: GIMENEZ MARTINEZ ANA. Datos registrales. T 46511 , F 11, S 8, H B 181501,I/A 21 (29.10.20).
17 de Enero de 2020Nombramientos. AUDIT.CUENT.: AVRP AUDITORES SL. Datos registrales. T 46511 , F 11, S 8, H B 181501, I/A 20 ( 9.01.20).
13 de Mayo de 2019Revocaciones. ADM.UNICO: PROMARCO SL. REPR.143 RRM: GIMENEZ FLORENCIO ANTONIO. Nombramientos.ADM.UNICO: GIMENEZ MARTINEZ ALEJANDRO. Datos registrales. T 46511 , F 11, S 8, H B 181501, I/A 18 ( 3.05.19).
Nombramientos. APODERAD.SOL: GIMENEZ FLORENCIO ANTONIO. Datos registrales. T 46511 , F 11, S 8, H B 181501, I/A 19 (3.05.19).
09 de Agosto de 2018Nombramientos. APODERAD.SOL: GIMENEZ MARTINEZ ALEJANDRO. Datos registrales. T 30777 , F 68, S 8, H B 181501, I/A 17( 1.08.18).
13 de Enero de 2017Nombramientos. AUDIT.CUENT.: AVRP AUDITORES SL. Datos registrales. T 30777 , F 68, S 8, H B 181501, I/A 16 ( 4.01.17).
03 de Enero de 2017Revocaciones. ADM.UNICO: GIMENEZ FLORENCIO ANTONIO. Nombramientos. ADM.UNICO: PROMARCO SL. REPR.143RRM: GIMENEZ FLORENCIO ANTONIO. Datos registrales. T 30777 , F 67, S 8, H B 181501, I/A 15 (23.12.16).
10 de Noviembre de 2016Revocaciones. ADM.UNICO: PROMARCO SA. REPR.143 RRM: GIMENEZ FLORENCIO ANTONIO. Nombramientos.ADM.UNICO: GIMENEZ FLORENCIO ANTONIO. Datos registrales. T 30777 , F 67, S 8, H B 181501, I/A 14 ( 2.11.16).
09 de Diciembre de 2014Revocaciones. ADM.UNICO: PROMARCO SA. REPR.143 RRM: GIMENEZ FLORENCIO ANTONIO. Nombramientos.ADM.UNICO: PROMARCO SA. REPR.143 RRM: GIMENEZ FLORENCIO ANTONIO. Datos registrales. T 30777 , F 67, S 8, H B181501, I/A 13 (28.11.14).
21 de Mayo de 2014Cambio de objeto social. AMPLIAR A: LA EXPLOTACION DE FINCAS AGRICOLAS. Datos registrales. T 30777 , F 67, S 8, H B181501, I/A 12 (13.05.14).
05 de Noviembre de 2013Nombramientos. AUDIT.CUENT.: AVRP AUDITORES SL. Datos registrales. T 30777 , F 66, S 8, H B 181501, I/A 11 (28.10.13).
03 de Julio de 2013Cambio de domicilio social. AV DIAGONAL,NUMERO 601, 6-B (BARCELONA). Datos registrales. T 30777 , F 66, S 8, H B181501, I/A 10 (26.06.13).
18 de Febrero de 2011Nombramientos. AUDIT.CUENT.: AVRP AUDITORES SL. Datos registrales. T 30777 , F 66, S 8, H B 181501, I/A 9 ( 7.02.11).
15 de Febrero de 2010Nombramientos. ADM.UNICO: PROMARCO SA. REPR.143 RRM: GIMENEZ FLORENCIO ANTONIO. Datos registrales. T 30777 ,F 65, S 8, H B 181501, I/A 8 ( 2.02.10).
28 de Julio de 2009Cambio de objeto social. AMPLIAR A:LA INTERMEDIACION Y PRESTACION DE SERVICIOS DE HOSPEDAJE ENCAMPAMENTOS TURISTICOS Y OTROS ALOJAMIENTOS EXTRA HOTELEROS,YA SEA EN INSTALACIONES DE SUPROPIEDAD O ARRENDADA A TERCEROS CON DICHA FINALIDAD. Datos registrales. T 30777 , F 65, S 8, H B 181501, I/A 7(16.07.09).