Buscador CIF Logo

Actos BORME Neopas Cogeneracion Sl

驴Quieres acceder a la API de EMPRESAS CIF? Obten la informaci贸n de todas las empresas en tiempo real desde tu plataforma.
Ahora con un 25% de DESCUENTO el primer MES. Quiero la API de EMPRESAS

Logo cabecera Neopas Cogeneracion Sl

Actos BORME Neopas Cogeneracion Sl - B64614159

Tenemos registrados 10 Actos BORME del Registro Mercantil de Barcelona para Neopas Cogeneracion Sl con CIF B64614159

馃敊 Perfil de Neopas Cogeneracion Sl
馃洅 Comprar listado completo de Empresas de Barcelona

Actos BORME de Neopas Cogeneracion Sl

21 de Octubre de 2015
Otros conceptos: JUZGADO MERCANTIL 4 DE BARCELONA, PROCEDIMIENTO CONCURSO VOLUNTARIO652/2014,RESOLUCIONES FIRMES DE FECHAS 17/12/2014 Y 27/07/2015, APROBACION DEL PLAN DE LIQUIDACION YCONCLUSION DE LA FASE COMUN DEL PROCEDIMIENTO CONCURSAL. Datos registrales. T 42045 , F 207, S 8, H B 353018,I/A 13 (13.10.15).

13 de Enero de 2015
Revocaciones. ADM.UNICO: CORTES RUIZ ANTONIO JUAN. Otros conceptos: JUZGADO MERCANTIL 4 DE BARCELONA,PROCEDIMIENTO CONCURSO VOLUNTARIO 652/2014, AUTO FIRME DE FECHA 16/10/2014, APERTURA DE LA FASE DELIQUIDACION. Disoluci贸n. Judicial. Datos registrales. T 39831 , F 172, S 8, H B 353018, I/A 12 ( 5.01.15).

03 de Noviembre de 2014
Nombramientos. ADM.CONCURS.: KPMG ABOGADOS SL. REP.ADM.CONC: COCO FERNANDEZ MARIA JESUS. Otrosconceptos: JUZGADO MERCANTIL 4 DE BARCELONA, PROCEDIMIENTO ORDINARIO DE CONCURSO VOLUNTARIO 652/2014,AUTO FIRME DE FECHA 08/09/2014, DECLARACION DE CONCURSO VOLUNTARIO DE LA SOCIEDAD. Datos registrales. T39831 , F 171, S 8, H B 353018, I/A 11 (27.10.14).

27 de Febrero de 2014
Nombramientos. AUDIT.CUENT.: GRANT THORNTON SLP. Datos registrales. T 39831 , F 171, S 8, H B 353018, I/A 10(19.02.14).

24 de Julio de 2013
Revocaciones. CONSEJERO: SERRET HUARTE JUAN. SECRETARIO: SERRET HUARTE JUAN. CONSEJERO: CASTA脩EDACAMARERO ANTONIO;CORTES RUIZ ANTONIO JUAN. PRESIDENTE: CORTES RUIZ ANTONIO JUAN. CONS. DELEG.: CORTESRUIZ ANTONIO JUAN. Nombramientos. ADM.UNICO: CORTES RUIZ ANTONIO JUAN. Modificaciones estatutarias.MODIFICACION ARTS.10,11,12,13,14,15,16,17,18,19, DEJANDO SIN CONTENIDO LOS ARTS.20,21 Y 22:CAMBIO DE REGIMENADMINISTRATIVO. Otros conceptos: SOCIEDAD UNIPERSONAL.SOCIO UNICO:NEOELECTRA WHITE SL. Datos registrales. T39831 , F 169, S 8, H B 353018, I/A 9 (15.07.13).

11 de Febrero de 2013
Nombramientos. AUDIT.CUENT.: GRANT THORNTON SLP. Datos registrales. T 39831 , F 169, S 8, H B 353018, I/A 8 ( 1.02.13).

21 de Febrero de 2011
Modificaciones estatutarias. ART.6:TRANSMISION PARTICIPACIONES SOCIALES. Datos registrales. T 39831 , F 169, S 8, H B353018, I/A 7 ( 9.02.11).

05 de Octubre de 2010
Revocaciones. AUDIT.CUENT.: DELOITTE SL. Nombramientos. AUDIT.CUENT.: AUDIHISPANA GRANT THORNTON SLP.Modificaciones estatutarias. ART.23.- FIJACION DEL INICIO Y CIERRE DEL EJERCICIO SOCIAL,INICIANDOSE EL DIA 1 DEENERO Y FINALIZANDO EL 31 DE DICIEMBRE DE CADA A脩O. Datos registrales. T 39831 , F 168, S 8, H B 353018, I/A 6(22.09.10).

18 de Noviembre de 2009
Nombramientos. APODERADO: DE SOLA MORALES FELIU MARIA. Datos registrales. T 39831 , F 167, S 8, H B 353018, I/A 5 (6.11.09).

09 de Marzo de 2009
Revocaciones. CONSEJERO: OLIVIER ANTOINE MARIE FUENTES. PRESIDENTE: OLIVIER ANTOINE MARIE FUENTES. CONS.DELEG.: OLIVIER ANTOINE MARIE FUENTES. Nombramientos. CONSEJERO: CORTES RUIZ ANTONIO JUAN. PRESIDENTE:CORTES RUIZ ANTONIO JUAN. CONS. DELEG.: CORTES RUIZ ANTONIO JUAN. Datos registrales. T 39831 , F 167, S 8, H B353018, I/A 4 (25.02.09).

Utilizamos cookies de terceros con finalidades anal铆ticas, de personalizaci贸n, y de publicidad comportamental. Puede configurar ahora el uso de esta tecnolog铆a. Si acepta o contin煤a navegando, consideramos que est谩 de acuerdo con su uso. Mas informaci贸n