Buscador CIF Logo

Actos BORME Nesspro Spain Sa

驴Quieres acceder a la API de EMPRESAS CIF? Obten la informaci贸n de todas las empresas en tiempo real desde tu plataforma.
Ahora con un 25% de DESCUENTO el primer MES. Quiero la API de EMPRESAS

Logo cabecera Nesspro Spain Sa

Actos BORME Nesspro Spain Sa - A78473402

Tenemos registrados 24 Actos BORME del Registro Mercantil de Madrid para Nesspro Spain Sa con CIF A78473402

馃敊 Perfil de Nesspro Spain Sa
馃洅 Comprar listado completo de Empresas de Madrid

Actos BORME de Nesspro Spain Sa

06 de Octubre de 2021
Ceses/Dimisiones. Secretario: URBANO JIMENEZ JAVIER. VsecrNoConsj: PAREJO BALLESTEROS DANIEL. Consejero: GURELEITAN;YANAI ZEEV;LAPID AARON. Con.Delegado: LAPID AARON. Presidente: YANAI ZEEV. Vicepresid.: LAPID AARON.Situaci贸n concursal. Procedimiento concursal 525/2014. FIRME: Si, Fecha de resoluci贸n 4/09/2020. Auto de conclusi贸n delconcurso. Insuficiencia de la masa activa. Juzgado: num. 0 JUZGADO DE LO MERCANTIL NUMERO 8 DE MADRID. Juez: MARTAGARCIA FERNANDEZ. Resoluciones: En auto de fecha 4 de septiembre de 2020, se declara la conclusi贸n del concurso.voluntario yabreviado de la sociedad "NESSPRO SPAIN SA EN LIQUIDACION", quedando extinguida la sociedad y canceladas todas susinscripciones. Situaci贸n concursal. Procedimiento concursal 525/2014. FIRME: Si, Fecha de resoluci贸n 4/09/2020. Cese de laslimitaciones de las facultades de administraci贸n. Juzgado: num. 0 JUZGADO DE LO MERCANTIL NUMERO 8 DE MADRID. Juez:MARTA GARCIA FERNANDEZ. Resoluciones: Cese de las limitaciones a las facultades de administraci贸n y disposici贸n del deudorque estuvieran subsistente. Situaci贸n concursal. Procedimiento concursal 525/2014. Fecha de resoluci贸n 11/11/2014. Revocaci贸nde administradores concursales. Juzgado: num. 8 JUZGADO DE LO MERCANTIL DE MADRID. Juez: FRANCISCO DE BORJAVILLENA CORTES. Administrador Concursal. Fecha 4/09/2020, NIF/CIF 5416805Y. ENCINAR TELLES JOSE LUIS. Extinci贸n.Datos registrales. T 28448 , F 188, S 8, H M 4959, I/A 76 (29.09.21).

30 de Diciembre de 2014
Situaci贸n concursal. Procedimiento concursal 525/2014. FIRME: No, Fecha de resoluci贸n 11/11/2014. Auto de declaraci贸n deconcurso. Voluntario. Juzgado: num. 8 JUZGADO DE LO MERCANTIL DE MADRID. Juez: FRANCISCO DE BORJA VILLENACORTES. Resoluciones: INTERVENCION por parte de la Administraci贸n Concursal de las facultades de administraci贸n y disposici贸nsobre todos los bienes y derechos de la entidad concursada que hayan de integrarse en la masa del concurso. Situaci贸n concursal.Procedimiento concursal 525/2014. Fecha de resoluci贸n 11/11/2014. Nombramiento de administradores. Juzgado: num. 8 JUZGADODE LO MERCANTIL DE MADRID. Juez: FRANCISCO DE BORJA VILLENA CORTES. Administrador Concursal. Fecha 11/11/2014,NIF/CIF 5416805Y. ENCINAR TELLES JOSE LUIS. Datos registrales. T 28448 , F 186, S 8, H M 4959, I/A A (22.12.14).

18 de Junio de 2013
Revocaciones. Apo.Manc.: YANAI ZEEV;GUREL EITAN;MARTINEZ MARTINEZ MAURICIO;VILLALON GONZALEZ ESTHER;LAPIDAARON;ZOREA MEIR. Nombramientos. Apoderado: YANAI ZEEV;GUREL EITAN;VILLALON GONZALEZ ESTHER;LAPID AARON.Datos registrales. T 28448 , F 184, S 8, H M 4959, I/A 71 (11.06.13).

29 de Noviembre de 2012
Ceses/Dimisiones. Consejero: ZOREA MEIR. Presidente: ZOREA MEIR. Vicepresid.: YANAI ZEEV. Nombramientos. Presidente:YANAI ZEEV. Vicepresid.: LAPID AARON. Datos registrales. T 28448 , F 184, S 8, H M 4959, I/A 70 (19.11.12).

16 de Octubre de 2012
Nombramientos. Consejero: LAPID AARON. Con.Delegado: LAPID AARON. Datos registrales. T 28448 , F 184, S 8, H M 4959, I/A69 ( 3.10.12).

06 de Septiembre de 2012
Revocaciones. Apoderado: YANAI ZEEV;GOREL EITAN;MARTINEZ MARTINEZ MAURICIO;SIERRA SAN MIGUELALBERTO;ZOREA MEIR. Nombramientos. Apo.Manc.: YANAI ZEEV;GUREL EITAN;MARTINEZ MARTINEZ MAURICIO;VILLALONGONZALEZ ESTHER;LAPID AARON;ZOREA MEIR. Vicepresid.: YANAI ZEEV. Datos registrales. T 28448 , F 182, S 8, H M 4959,I/A 68 (27.08.12).

24 de Agosto de 2012
Ceses/Dimisiones. Consejero: MARTINEZ MARTINEZ MAURICIO. Vicepresid.: MARTINEZ MARTINEZ MAURICIO. Datosregistrales. T 28448 , F 182, S 8, H M 4959, I/A 67 (13.08.12).

23 de Agosto de 2012
Fe de erratas: SE PUBLICO POR ERROR EN LA INSCRIPCION 47& EN EL DOMICILIO SOCIAL, EL MUNICIPIO DE LAS ROZASDE MADRID, SIENDO EL CORRECTO MADRID. Datos registrales. T 18820 , F 183, S 8, H M 4959, I/A 47 ( 7.08.07).

29 de Mayo de 2012
Revocaciones. Apoderado: DASKAL SHALOM;DASKAL SHALOM;ROTEM ILAN;MARTINEZ MARTINEZ MAURICIO;DASKALSHALOM;ROTEM ILAN;SIERRA SAN MIGUEL ALBERTO;VILLALON GONZALEZ ESTHER;MARTIN SERRANO MANUEL.Nombramientos. Apoderado: YANAI ZEEV;GOREL EITAN;MARTINEZ MARTINEZ MAURICIO;SIERRA SAN MIGUELALBERTO;ZOREA MEIR. Datos registrales. T 28448 , F 180, S 8, H M 4959, I/A 66 (17.05.12).

09 de Enero de 2012
Nombramientos. Consejero: ZOREA MEIR. Datos registrales. T 28448 , F 180, S 8, H M 4959, I/A 64 (27.12.11).

Ceses/Dimisiones. Presidente: MARTINEZ MARTINEZ MAURICIO. Nombramientos. Presidente: ZOREA MEIR. Vicepresid.:MARTINEZ MARTINEZ MAURICIO. Datos registrales. T 28448 , F 180, S 8, H M 4959, I/A 65 (27.12.11).

31 de Agosto de 2011
Nombramientos. Auditor: GRANT THORNTON SL. Datos registrales. T 28448 , F 180, S 8, H M 4959, I/A 63 (22.08.11).

01 de Julio de 2011
Ceses/Dimisiones. Consejero: ROTEM ILAN;SEGEV OFER. Nombramientos. Consejero: GUREL EITAN;YANAI ZEEV. Datosregistrales. T 18820 , F 191, S 8, H M 4959, I/A 62 (20.06.11).

30 de Junio de 2011
Ceses/Dimisiones. Consejero: DASKAL SHALOM. Nombramientos. Consejero: SEGEV OFER. Datos registrales. T 18820 , F191, S 8, H M 4959, I/A 60 (17.06.11).

Sociedad unipersonal. Cambio de identidad del socio 煤nico: ADVANTECH PRO (IT). Datos registrales. T 18820 , F 191, S 8, HM 4959, I/A 61 (17.06.11).

18 de Mayo de 2011
Revocaciones. Apoderado: CREMONESI EMILIO. Datos registrales. T 18820 , F 191, S 8, H M 4959, I/A 59 ( 6.05.11).

20 de Agosto de 2010
Reelecciones. Auditor: ERNST & YOUNG SL. Datos registrales. T 18820 , F 191, S 8, H M 4959, I/A 58 (10.08.10).

07 de Julio de 2010
Nombramientos. Apoderado: SIERRA SAN MIGUEL ALBERTO;MARTINEZ MARTINEZ MAURICIO;VILLALON GONZALEZESTHER. Datos registrales. T 18820 , F 191, S 8, H M 4959, I/A 57 (25.06.10).

25 de Marzo de 2010
Ceses/Dimisiones. Consejero: EFAAL SHACHAR ITSHAK. Nombramientos. Consejero: DASKAL SHALOM. Datos registrales. T18820 , F 189, S 8, H M 4959, I/A 55 (10.03.10).

Revocaciones. Apoderado: EFAAL SHACHAR ITSHAK;EFAAL SHACHAR ITSHAK;ROTEM ILAN;MARTINEZ MARTINEZMAURICIO;EFAAL SHACHAR ITSHAK;ROTEM ILAN;CREMONESI EMILIO;SIERRA SAN MIGUEL ALBERTO;VILLALON GONZALEZESTHER;MARTIN SERRANO MANUEL. Nombramientos. Apoderado: DASKAL SHALOM;DASKAL SHALOM;ROTEMILAN;MARTINEZ MARTINEZ MAURICIO;DASKAL SHALOM;ROTEM ILAN;CREMONESI EMILIO;SIERRA SAN MIGUELALBERTO;VILLALON GONZALEZ ESTHER;MARTIN SERRANO MANUEL. Datos registrales. T 18820 , F 190, S 8, H M 4959, I/A 56(10.03.10).

30 de Diciembre de 2009
Nombramientos. Apoderado: SEGEV OFER;GUR IZHAK. Datos registrales. T 18820 , F 189, S 8, H M 4959, I/A 54 (17.12.09).

09 de Octubre de 2009
Reelecciones. Auditor: ERNST & YOUNG SL. Datos registrales. T 18820 , F 189, S 8, H M 4959, I/A 53 (30.09.09).

31 de Agosto de 2009
Ceses/Dimisiones. Consejero: MICHAELIS YORAM. Nombramientos. Consejero: EFAAL SHACHAR ITSHAK. Datos registrales.T 18820 , F 188, S 8, H M 4959, I/A 51 (18.08.09).

Revocaciones. Apoderado: MICHAELIS YORAM;ROTEM ILAN;MARTINEZ MARTINEZ MAURICIO;CREMONESI EMILIO;SIERRASAN MIGUEL ALBERTO;VILLALON GONZALEZ ESTHER;MARTIN SERRANO MANUEL. Nombramientos. Apoderado: EFAALSHACHAR ITSHAK;EFAAL SHACHAR ITSHAK;ROTEM ILAN;MARTINEZ MARTINEZ MAURICIO;EFAAL SHACHAR ITSHAK;ROTEMILAN;CREMONESI EMILIO;SIERRA SAN MIGUEL ALBERTO;VILLALON GONZALEZ ESTHER;MARTIN SERRANO MANUEL. Datosregistrales. T 18820 , F 188, S 8, H M 4959, I/A 52 (18.08.09).

Utilizamos cookies de terceros con finalidades anal铆ticas, de personalizaci贸n, y de publicidad comportamental. Puede configurar ahora el uso de esta tecnolog铆a. Si acepta o contin煤a navegando, consideramos que est谩 de acuerdo con su uso. Mas informaci贸n