Actos BORME de Nesspro Spain Sa
06 de Octubre de 2021Ceses/Dimisiones. Secretario: URBANO JIMENEZ JAVIER. VsecrNoConsj: PAREJO BALLESTEROS DANIEL. Consejero: GURELEITAN;YANAI ZEEV;LAPID AARON. Con.Delegado: LAPID AARON. Presidente: YANAI ZEEV. Vicepresid.: LAPID AARON.Situaci贸n concursal. Procedimiento concursal 525/2014. FIRME: Si, Fecha de resoluci贸n 4/09/2020. Auto de conclusi贸n delconcurso. Insuficiencia de la masa activa. Juzgado: num. 0 JUZGADO DE LO MERCANTIL NUMERO 8 DE MADRID. Juez: MARTAGARCIA FERNANDEZ. Resoluciones: En auto de fecha 4 de septiembre de 2020, se declara la conclusi贸n del concurso.voluntario yabreviado de la sociedad "NESSPRO SPAIN SA EN LIQUIDACION", quedando extinguida la sociedad y canceladas todas susinscripciones. Situaci贸n concursal. Procedimiento concursal 525/2014. FIRME: Si, Fecha de resoluci贸n 4/09/2020. Cese de laslimitaciones de las facultades de administraci贸n. Juzgado: num. 0 JUZGADO DE LO MERCANTIL NUMERO 8 DE MADRID. Juez:MARTA GARCIA FERNANDEZ. Resoluciones: Cese de las limitaciones a las facultades de administraci贸n y disposici贸n del deudorque estuvieran subsistente. Situaci贸n concursal. Procedimiento concursal 525/2014. Fecha de resoluci贸n 11/11/2014. Revocaci贸nde administradores concursales. Juzgado: num. 8 JUZGADO DE LO MERCANTIL DE MADRID. Juez: FRANCISCO DE BORJAVILLENA CORTES. Administrador Concursal. Fecha 4/09/2020, NIF/CIF 5416805Y. ENCINAR TELLES JOSE LUIS. Extinci贸n.Datos registrales. T 28448 , F 188, S 8, H M 4959, I/A 76 (29.09.21).
30 de Diciembre de 2014Situaci贸n concursal. Procedimiento concursal 525/2014. FIRME: No, Fecha de resoluci贸n 11/11/2014. Auto de declaraci贸n deconcurso. Voluntario. Juzgado: num. 8 JUZGADO DE LO MERCANTIL DE MADRID. Juez: FRANCISCO DE BORJA VILLENACORTES. Resoluciones: INTERVENCION por parte de la Administraci贸n Concursal de las facultades de administraci贸n y disposici贸nsobre todos los bienes y derechos de la entidad concursada que hayan de integrarse en la masa del concurso. Situaci贸n concursal.Procedimiento concursal 525/2014. Fecha de resoluci贸n 11/11/2014. Nombramiento de administradores. Juzgado: num. 8 JUZGADODE LO MERCANTIL DE MADRID. Juez: FRANCISCO DE BORJA VILLENA CORTES. Administrador Concursal. Fecha 11/11/2014,NIF/CIF 5416805Y. ENCINAR TELLES JOSE LUIS. Datos registrales. T 28448 , F 186, S 8, H M 4959, I/A A (22.12.14).
18 de Junio de 2013Revocaciones. Apo.Manc.: YANAI ZEEV;GUREL EITAN;MARTINEZ MARTINEZ MAURICIO;VILLALON GONZALEZ ESTHER;LAPIDAARON;ZOREA MEIR. Nombramientos. Apoderado: YANAI ZEEV;GUREL EITAN;VILLALON GONZALEZ ESTHER;LAPID AARON.Datos registrales. T 28448 , F 184, S 8, H M 4959, I/A 71 (11.06.13).
29 de Noviembre de 2012Ceses/Dimisiones. Consejero: ZOREA MEIR. Presidente: ZOREA MEIR. Vicepresid.: YANAI ZEEV. Nombramientos. Presidente:YANAI ZEEV. Vicepresid.: LAPID AARON. Datos registrales. T 28448 , F 184, S 8, H M 4959, I/A 70 (19.11.12).
16 de Octubre de 2012Nombramientos. Consejero: LAPID AARON. Con.Delegado: LAPID AARON. Datos registrales. T 28448 , F 184, S 8, H M 4959, I/A69 ( 3.10.12).
06 de Septiembre de 2012Revocaciones. Apoderado: YANAI ZEEV;GOREL EITAN;MARTINEZ MARTINEZ MAURICIO;SIERRA SAN MIGUELALBERTO;ZOREA MEIR. Nombramientos. Apo.Manc.: YANAI ZEEV;GUREL EITAN;MARTINEZ MARTINEZ MAURICIO;VILLALONGONZALEZ ESTHER;LAPID AARON;ZOREA MEIR. Vicepresid.: YANAI ZEEV. Datos registrales. T 28448 , F 182, S 8, H M 4959,I/A 68 (27.08.12).
24 de Agosto de 2012Ceses/Dimisiones. Consejero: MARTINEZ MARTINEZ MAURICIO. Vicepresid.: MARTINEZ MARTINEZ MAURICIO. Datosregistrales. T 28448 , F 182, S 8, H M 4959, I/A 67 (13.08.12).
23 de Agosto de 2012Fe de erratas: SE PUBLICO POR ERROR EN LA INSCRIPCION 47& EN EL DOMICILIO SOCIAL, EL MUNICIPIO DE LAS ROZASDE MADRID, SIENDO EL CORRECTO MADRID. Datos registrales. T 18820 , F 183, S 8, H M 4959, I/A 47 ( 7.08.07).
29 de Mayo de 2012Revocaciones. Apoderado: DASKAL SHALOM;DASKAL SHALOM;ROTEM ILAN;MARTINEZ MARTINEZ MAURICIO;DASKALSHALOM;ROTEM ILAN;SIERRA SAN MIGUEL ALBERTO;VILLALON GONZALEZ ESTHER;MARTIN SERRANO MANUEL.Nombramientos. Apoderado: YANAI ZEEV;GOREL EITAN;MARTINEZ MARTINEZ MAURICIO;SIERRA SAN MIGUELALBERTO;ZOREA MEIR. Datos registrales. T 28448 , F 180, S 8, H M 4959, I/A 66 (17.05.12).
09 de Enero de 2012Nombramientos. Consejero: ZOREA MEIR. Datos registrales. T 28448 , F 180, S 8, H M 4959, I/A 64 (27.12.11).
Ceses/Dimisiones. Presidente: MARTINEZ MARTINEZ MAURICIO. Nombramientos. Presidente: ZOREA MEIR. Vicepresid.:MARTINEZ MARTINEZ MAURICIO. Datos registrales. T 28448 , F 180, S 8, H M 4959, I/A 65 (27.12.11).
31 de Agosto de 2011Nombramientos. Auditor: GRANT THORNTON SL. Datos registrales. T 28448 , F 180, S 8, H M 4959, I/A 63 (22.08.11).
01 de Julio de 2011Ceses/Dimisiones. Consejero: ROTEM ILAN;SEGEV OFER. Nombramientos. Consejero: GUREL EITAN;YANAI ZEEV. Datosregistrales. T 18820 , F 191, S 8, H M 4959, I/A 62 (20.06.11).
30 de Junio de 2011Ceses/Dimisiones. Consejero: DASKAL SHALOM. Nombramientos. Consejero: SEGEV OFER. Datos registrales. T 18820 , F191, S 8, H M 4959, I/A 60 (17.06.11).
Sociedad unipersonal. Cambio de identidad del socio 煤nico: ADVANTECH PRO (IT). Datos registrales. T 18820 , F 191, S 8, HM 4959, I/A 61 (17.06.11).
18 de Mayo de 2011Revocaciones. Apoderado: CREMONESI EMILIO. Datos registrales. T 18820 , F 191, S 8, H M 4959, I/A 59 ( 6.05.11).
20 de Agosto de 2010Reelecciones. Auditor: ERNST & YOUNG SL. Datos registrales. T 18820 , F 191, S 8, H M 4959, I/A 58 (10.08.10).
07 de Julio de 2010Nombramientos. Apoderado: SIERRA SAN MIGUEL ALBERTO;MARTINEZ MARTINEZ MAURICIO;VILLALON GONZALEZESTHER. Datos registrales. T 18820 , F 191, S 8, H M 4959, I/A 57 (25.06.10).
25 de Marzo de 2010Ceses/Dimisiones. Consejero: EFAAL SHACHAR ITSHAK. Nombramientos. Consejero: DASKAL SHALOM. Datos registrales. T18820 , F 189, S 8, H M 4959, I/A 55 (10.03.10).
Revocaciones. Apoderado: EFAAL SHACHAR ITSHAK;EFAAL SHACHAR ITSHAK;ROTEM ILAN;MARTINEZ MARTINEZMAURICIO;EFAAL SHACHAR ITSHAK;ROTEM ILAN;CREMONESI EMILIO;SIERRA SAN MIGUEL ALBERTO;VILLALON GONZALEZESTHER;MARTIN SERRANO MANUEL. Nombramientos. Apoderado: DASKAL SHALOM;DASKAL SHALOM;ROTEMILAN;MARTINEZ MARTINEZ MAURICIO;DASKAL SHALOM;ROTEM ILAN;CREMONESI EMILIO;SIERRA SAN MIGUELALBERTO;VILLALON GONZALEZ ESTHER;MARTIN SERRANO MANUEL. Datos registrales. T 18820 , F 190, S 8, H M 4959, I/A 56(10.03.10).
30 de Diciembre de 2009Nombramientos. Apoderado: SEGEV OFER;GUR IZHAK. Datos registrales. T 18820 , F 189, S 8, H M 4959, I/A 54 (17.12.09).
09 de Octubre de 2009Reelecciones. Auditor: ERNST & YOUNG SL. Datos registrales. T 18820 , F 189, S 8, H M 4959, I/A 53 (30.09.09).
31 de Agosto de 2009Ceses/Dimisiones. Consejero: MICHAELIS YORAM. Nombramientos. Consejero: EFAAL SHACHAR ITSHAK. Datos registrales.T 18820 , F 188, S 8, H M 4959, I/A 51 (18.08.09).
Revocaciones. Apoderado: MICHAELIS YORAM;ROTEM ILAN;MARTINEZ MARTINEZ MAURICIO;CREMONESI EMILIO;SIERRASAN MIGUEL ALBERTO;VILLALON GONZALEZ ESTHER;MARTIN SERRANO MANUEL. Nombramientos. Apoderado: EFAALSHACHAR ITSHAK;EFAAL SHACHAR ITSHAK;ROTEM ILAN;MARTINEZ MARTINEZ MAURICIO;EFAAL SHACHAR ITSHAK;ROTEMILAN;CREMONESI EMILIO;SIERRA SAN MIGUEL ALBERTO;VILLALON GONZALEZ ESTHER;MARTIN SERRANO MANUEL. Datosregistrales. T 18820 , F 188, S 8, H M 4959, I/A 52 (18.08.09).