Actos BORME de Neumotecnologias Sl
13 de Octubre de 2023Ceses/Dimisiones. Adm. Unico: BRDENK JEAN CLAUDE. Nombramientos. Adm. Unico: JOURDANNEY OLIVIER. Datosregistrales. T 36797 , F 29, S 8, H M 658989, I/A 16 ( 5.10.23).
13 de Febrero de 2023Revocaciones. Apoderado: CAMPOS MARTINEZ MANUEL. Datos registrales. T 36797 , F 28, S 8, H M 658989, I/A 15 ( 6.02.23).
03 de Febrero de 2023Ceses/Dimisiones. Consejero: JOURDANNEY OLIVIER;CAMPOS MARTINEZ MANUEL. Presidente: CAMPOS MARTINEZMANUEL. Consejero: BASTIDE VICENT PIERRE. SecreNoConsj: OLIVA VILA MARC. Nombramientos. Adm. Unico: BRDENKJEAN CLAUDE. Otros conceptos: Cambio del Organo de Administraci贸n: Consejo de administraci贸n a Administrador 煤nico. Datosregistrales. T 36797 , F 28, S 8, H M 658989, I/A 14 (27.01.23).
09 de Diciembre de 2022Nombramientos. Apoderado: OLIVA VILA MARC. Datos registrales. T 36797 , F 28, S 8, H M 658989, I/A 13 (30.11.22).
31 de Octubre de 2022Modificaciones estatutarias. 5. Ejercicio social.-. Fecha de Cierre de Ejercicio: 30/6. Datos registrales. T 36797 , F 27, S 8, H M658989, I/A 12 (24.10.22).
30 de Agosto de 2022Nombramientos. Apoderado: BARAMBIO DOMENECH SUSANA. Datos registrales. T 36797 , F 27, S 8, H M 658989, I/A 11(23.08.22).
10 de Junio de 2022Nombramientos. Apoderado: REINOSO VESGA MARC;OLIVA VILA MARC;JOURDANNEY OLIVIER. Datos registrales. T 36797 ,F 26, S 8, H M 658989, I/A 10 ( 3.06.22).
09 de Junio de 2022Cambio de domicilio social. C/ DOMENICO SCARLATTI 3 - LOCAL 18 B (MADRID). Datos registrales. T 36797 , F 25, S 8, H M658989, I/A 9 ( 2.06.22).
09 de Marzo de 2022Revocaciones. Apoderado: RUIZ DORADO DAVID. Datos registrales. T 36797 , F 25, S 8, H M 658989, I/A 8 ( 2.03.22).
24 de Enero de 2022Declaraci贸n de unipersonalidad. Socio 煤nico: BASTIDE LE CONFORT MEDICAL. Datos registrales. T 36797 , F 25, S 8, H M658989, I/A 7 (17.01.22).
28 de Diciembre de 2021Ceses/Dimisiones. Consejero: FAYOLLE ARNAUD. Nombramientos. Consejero: BASTIDE VICENT PIERRE. Datos registrales.T 36797 , F 25, S 8, H M 658989, I/A 6 (21.12.21).
25 de Junio de 2021Nombramientos. Apoderado: OLIVA VILA MARC;CAMPOS MARTINEZ MANUEL;REINOSO VESGA MARC;JOURDANNEYOLIVIER. Datos registrales. T 36797 , F 24, S 8, H M 658989, I/A 5 (18.06.21).
02 de Junio de 2021Ceses/Dimisiones. Consejero: REINOSO VESGA MARC. Secretario: REINOSO VESGA MARC. Nombramientos. SecreNoConsj:OLIVA VILA MARC. Datos registrales. T 36797 , F 23, S 8, H M 658989, I/A 4 (26.05.21).
20 de Octubre de 2020Ceses/Dimisiones. Consejero: CAMPOS MARTINEZ JOSE LUIS;CAMPOS MARTINEZ MANUEL;CAMPOS MARTINEZSANTIAGO;RUIZ DORADO DAVID. Secretario: CAMPOS MARTINEZ JOSE LUIS. Con.Delegado: CAMPOS MARTINEZ MANUEL.Presidente: CAMPOS MARTINEZ SANTIAGO. Nombramientos. Consejero: FAYOLLE ARNAUD;JOURDANNEY OLIVIER;REINOSOVESGA MARC;CAMPOS MARTINEZ MANUEL. Secretario: REINOSO VESGA MARC. Presidente: CAMPOS MARTINEZ MANUEL.Datos registrales. T 36797 , F 22, S 8, H M 658989, I/A 3 (13.10.20).
15 de Diciembre de 2017Cambio de domicilio social. C/ SANCHO DAVILA 21 BAJO 3 (MADRID). Datos registrales. T 36797 , F 22, S 8, H M 658989, I/A 2( 7.12.17).
16 de Noviembre de 2017Revocaciones. ADM.UNICO: PELLICER FLORIT DAVID. Nombramientos. CONSEJERO: CAMPOS MARTINEZ SANTIAGO.PRESIDENTE: CAMPOS MARTINEZ SANTIAGO. CONSEJERO: CAMPOS MARTINEZ MANUEL. CONS. DELEG.: CAMPOSMARTINEZ MANUEL. CONSEJERO: CAMPOS MARTINEZ JOSE LUIS. SECRETARIO: CAMPOS MARTINEZ JOSE LUIS.CONSEJERO: RUIZ DORADO DAVID. Modificaciones estatutarias. ARTS.15 A 20.- ESTRUCTURA DEL ORGANO DEADMINISTRACION SOCIAL. Datos registrales. T 30059 , F 216, S 8, H B 163250, I/A 8 (31.10.17).
26 de Enero de 2015Nombramientos. APODERAD.SOL: RUIZ DORADO DAVID. Datos registrales. T 30059 , F 215, S 8, H B 163250, I/A 7 (19.01.15).