Buscador CIF Logo

Actos BORME Neumotecnologias Sl

驴Quieres acceder a la API de EMPRESAS CIF? Obten la informaci贸n de todas las empresas en tiempo real desde tu plataforma.
Ahora con un 25% de DESCUENTO el primer MES. Quiero la API de EMPRESAS

Logo cabecera Neumotecnologias Sl

Actos BORME Neumotecnologias Sl - B61408597

Tenemos registrados 17 Actos BORME del Registro Mercantil de Madrid para Neumotecnologias Sl con CIF B61408597

馃敊 Perfil de Neumotecnologias Sl
馃洅 Comprar listado completo de Empresas de Madrid

Actos BORME de Neumotecnologias Sl

13 de Octubre de 2023
Ceses/Dimisiones. Adm. Unico: BRDENK JEAN CLAUDE. Nombramientos. Adm. Unico: JOURDANNEY OLIVIER. Datosregistrales. T 36797 , F 29, S 8, H M 658989, I/A 16 ( 5.10.23).

13 de Febrero de 2023
Revocaciones. Apoderado: CAMPOS MARTINEZ MANUEL. Datos registrales. T 36797 , F 28, S 8, H M 658989, I/A 15 ( 6.02.23).

03 de Febrero de 2023
Ceses/Dimisiones. Consejero: JOURDANNEY OLIVIER;CAMPOS MARTINEZ MANUEL. Presidente: CAMPOS MARTINEZMANUEL. Consejero: BASTIDE VICENT PIERRE. SecreNoConsj: OLIVA VILA MARC. Nombramientos. Adm. Unico: BRDENKJEAN CLAUDE. Otros conceptos: Cambio del Organo de Administraci贸n: Consejo de administraci贸n a Administrador 煤nico. Datosregistrales. T 36797 , F 28, S 8, H M 658989, I/A 14 (27.01.23).

09 de Diciembre de 2022
Nombramientos. Apoderado: OLIVA VILA MARC. Datos registrales. T 36797 , F 28, S 8, H M 658989, I/A 13 (30.11.22).

31 de Octubre de 2022
Modificaciones estatutarias. 5. Ejercicio social.-. Fecha de Cierre de Ejercicio: 30/6. Datos registrales. T 36797 , F 27, S 8, H M658989, I/A 12 (24.10.22).

30 de Agosto de 2022
Nombramientos. Apoderado: BARAMBIO DOMENECH SUSANA. Datos registrales. T 36797 , F 27, S 8, H M 658989, I/A 11(23.08.22).

10 de Junio de 2022
Nombramientos. Apoderado: REINOSO VESGA MARC;OLIVA VILA MARC;JOURDANNEY OLIVIER. Datos registrales. T 36797 ,F 26, S 8, H M 658989, I/A 10 ( 3.06.22).

09 de Junio de 2022
Cambio de domicilio social. C/ DOMENICO SCARLATTI 3 - LOCAL 18 B (MADRID). Datos registrales. T 36797 , F 25, S 8, H M658989, I/A 9 ( 2.06.22).

09 de Marzo de 2022
Revocaciones. Apoderado: RUIZ DORADO DAVID. Datos registrales. T 36797 , F 25, S 8, H M 658989, I/A 8 ( 2.03.22).

24 de Enero de 2022
Declaraci贸n de unipersonalidad. Socio 煤nico: BASTIDE LE CONFORT MEDICAL. Datos registrales. T 36797 , F 25, S 8, H M658989, I/A 7 (17.01.22).

28 de Diciembre de 2021
Ceses/Dimisiones. Consejero: FAYOLLE ARNAUD. Nombramientos. Consejero: BASTIDE VICENT PIERRE. Datos registrales.T 36797 , F 25, S 8, H M 658989, I/A 6 (21.12.21).

25 de Junio de 2021
Nombramientos. Apoderado: OLIVA VILA MARC;CAMPOS MARTINEZ MANUEL;REINOSO VESGA MARC;JOURDANNEYOLIVIER. Datos registrales. T 36797 , F 24, S 8, H M 658989, I/A 5 (18.06.21).

02 de Junio de 2021
Ceses/Dimisiones. Consejero: REINOSO VESGA MARC. Secretario: REINOSO VESGA MARC. Nombramientos. SecreNoConsj:OLIVA VILA MARC. Datos registrales. T 36797 , F 23, S 8, H M 658989, I/A 4 (26.05.21).

20 de Octubre de 2020
Ceses/Dimisiones. Consejero: CAMPOS MARTINEZ JOSE LUIS;CAMPOS MARTINEZ MANUEL;CAMPOS MARTINEZSANTIAGO;RUIZ DORADO DAVID. Secretario: CAMPOS MARTINEZ JOSE LUIS. Con.Delegado: CAMPOS MARTINEZ MANUEL.Presidente: CAMPOS MARTINEZ SANTIAGO. Nombramientos. Consejero: FAYOLLE ARNAUD;JOURDANNEY OLIVIER;REINOSOVESGA MARC;CAMPOS MARTINEZ MANUEL. Secretario: REINOSO VESGA MARC. Presidente: CAMPOS MARTINEZ MANUEL.Datos registrales. T 36797 , F 22, S 8, H M 658989, I/A 3 (13.10.20).

15 de Diciembre de 2017
Cambio de domicilio social. C/ SANCHO DAVILA 21 BAJO 3 (MADRID). Datos registrales. T 36797 , F 22, S 8, H M 658989, I/A 2( 7.12.17).

16 de Noviembre de 2017
Revocaciones. ADM.UNICO: PELLICER FLORIT DAVID. Nombramientos. CONSEJERO: CAMPOS MARTINEZ SANTIAGO.PRESIDENTE: CAMPOS MARTINEZ SANTIAGO. CONSEJERO: CAMPOS MARTINEZ MANUEL. CONS. DELEG.: CAMPOSMARTINEZ MANUEL. CONSEJERO: CAMPOS MARTINEZ JOSE LUIS. SECRETARIO: CAMPOS MARTINEZ JOSE LUIS.CONSEJERO: RUIZ DORADO DAVID. Modificaciones estatutarias. ARTS.15 A 20.- ESTRUCTURA DEL ORGANO DEADMINISTRACION SOCIAL. Datos registrales. T 30059 , F 216, S 8, H B 163250, I/A 8 (31.10.17).

26 de Enero de 2015
Nombramientos. APODERAD.SOL: RUIZ DORADO DAVID. Datos registrales. T 30059 , F 215, S 8, H B 163250, I/A 7 (19.01.15).

Utilizamos cookies de terceros con finalidades anal铆ticas, de personalizaci贸n, y de publicidad comportamental. Puede configurar ahora el uso de esta tecnolog铆a. Si acepta o contin煤a navegando, consideramos que est谩 de acuerdo con su uso. Mas informaci贸n