Buscador CIF Logo

Actos BORME Neuronics Data Intelligence Sa

驴Quieres acceder a la API de EMPRESAS CIF? Obten la informaci贸n de todas las empresas en tiempo real desde tu plataforma.
Ahora con un 25% de DESCUENTO el primer MES. Quiero la API de EMPRESAS

Logo cabecera Neuronics Data Intelligence Sa

Actos BORME Neuronics Data Intelligence Sa - A28961860

Tenemos registrados 32 Actos BORME del Registro Mercantil de Madrid para Neuronics Data Intelligence Sa con CIF A28961860

馃敊 Perfil de Neuronics Data Intelligence Sa
馃洅 Comprar listado completo de Empresas de Madrid

Actos BORME de Neuronics Data Intelligence Sa

29 de Diciembre de 2023
Ceses/Dimisiones. Consejero: MOSER JAMES THOMAS. Datos registrales. T 39131 , F 164, S 8, H M 81815, I/A 58 (21.12.23).

Nombramientos. Consejero: BYRNES JOHN J. Datos registrales. T 39131 , F 164, S 8, H M 81815, I/A 59 (21.12.23).

23 de Agosto de 2023
Revocaciones. Apoderado: GOMEZ ESTEBAN JOSE LUIS. Datos registrales. T 39131 , F 164, S 8, H M 81815, I/A 57 (16.08.23).

28 de Diciembre de 2022
Ceses/Dimisiones. Consejero: BYRNES JOHN J. Nombramientos. Consejero: SANDERS MARTIN PAUL. Datos registrales. T39131 , F 163, S 8, H M 81815, I/A 56 (20.12.22).

24 de Mayo de 2021
Revocaciones. Apo.Manc.: GOMEZ ESTEBAN JOSE LUIS;ARBOLI TRIAS MARTA;MEDINA EXPOSITO PABLOJESUS;GUTIERREZ SANZ JORGE ROMAN. Nombramientos. Apoderado: GOMEZ ESTEBAN JOSE LUIS;GUTIERREZ SANZJORGE ROMAN;BARRAGAN FERNANDEZ LUIS JAVIER;ARBOLI TRIAS MARTA;GUTIERREZ SANZ JORGE ROMAN;LOPEZGIMENEZ TERESA;GUTIERREZ ASENSIO ARANZAZU. Datos registrales. T 39131 , F 162, S 8, H M 81815, I/A 54 (14.05.21).

Nombramientos. Apoderado: GUTIERREZ SANZ JORGE ROMAN. Datos registrales. T 39131 , F 163, S 8, H M 81815, I/A 55(14.05.21).

20 de Octubre de 2020
Ceses/Dimisiones. Consejero: RAMIS PLA JOAQUIM;GILLESPIE DENNIS PAUL;BETTS JOHN MARTIN WILLIAM. Presidente:RAMIS PLA JOAQUIM. Revocaciones. Apoderado: RAMIS PLA JOAQUIM. Nombramientos. Consejero: MOSER JAMESTHOMAS;BYRNES JOHN J;CAVANAGH HELEN ROSINA. Presidente: CAVANAGH HELEN ROSINA. Apoderado: CORAL MORRALDAVID. Datos registrales. T 39131 , F 161, S 8, H M 81815, I/A 53 (13.10.20).

13 de Marzo de 2020
Revocaciones. Apoderado: FRANCESCUTTI ALESSIA. Nombramientos. Apoderado: RAMIS PLA JOAQUIM. Datos registrales.T 39131 , F 160, S 8, H M 81815, I/A 51 ( 6.03.20).

Revocaciones. Apoderado: GOMEZ ESTEBAN JOSE LUIS;ARBOLI TRIAS MARTA;MEDINA EXPOSITO PABLOJESUS;GUTIERREZ SANZ JORGE ROMAN. Nombramientos. Apo.Manc.: GOMEZ ESTEBAN JOSE LUIS;ARBOLI TRIASMARTA;MEDINA EXPOSITO PABLO JESUS;GUTIERREZ SANZ JORGE ROMAN. Datos registrales. T 39131 , F 160, S 8, H M81815, I/A 52 ( 6.03.20).

27 de Septiembre de 2019
Ceses/Dimisiones. Consejero: BBDO ESPA脩A SA;BYRNES JOHN J;FRANCESCUTTI ALESSIA. Presidente: FRANCESCUTTIALESSIA. Consejero: CAVANAGH HELEN ROSINA. Nombramientos. Consejero: RAMIS PLA JOAQUIM;GILLESPIE DENNISPAUL;BETTS JOHN MARTIN WILLIAM. Presidente: RAMIS PLA JOAQUIM. Datos registrales. T 24246 , F 105, S 8, H M 81815, I/A49 (19.09.19).

Modificaciones estatutarias. Se modifican los articulos 11 y 12 de los estatutos sociales. Datos registrales. T 24246 , F 105, S 8, HM 81815, I/A 50 (19.09.19).

04 de Diciembre de 2018
Revocaciones. Apoderado: CORAL MORRAL DAVID;ARBOLI TRIAS MARTA;MEDINA EXPOSITO PABLO JESUS;GUTIERREZSANZ JORGE ROMAN. Nombramientos. Apoderado: GOMEZ ESTEBAN JOSE LUIS;ARBOLI TRIAS MARTA;MEDINA EXPOSITOPABLO JESUS;GUTIERREZ SANZ JORGE ROMAN. Datos registrales. T 24246 , F 104, S 8, H M 81815, I/A 48 (27.11.18).

12 de Mayo de 2017
Revocaciones. Apo.Manc.: CORAL MORRAL DAVID;YHERLA CAMPA脩A JORDI;MEDINA EXPOSITO PABLO JESUS;GUTIERREZSANZ JORGE ROMAN. Nombramientos. Apoderado: CORAL MORRAL DAVID;ARBOLI TRIAS MARTA;MEDINA EXPOSITOPABLO JESUS;GUTIERREZ SANZ JORGE ROMAN. Datos registrales. T 24246 , F 103, S 8, H M 81815, I/A 47 ( 3.05.17).

05 de Junio de 2015
Ceses/Dimisiones. Consejero: MARK WALKER JOHN. Nombramientos. Consejero: CAVANAGH HELEN ROSINA. Datosregistrales. T 24246 , F 103, S 8, H M 81815, I/A 46 (27.05.15).

30 de Junio de 2014
Declaraci贸n de unipersonalidad. Socio 煤nico: CONTRAPUNTO BBDO SA. Datos registrales. T 24246 , F 103, S 8, H M 81815,I/A 45 (18.06.14).

30 de Mayo de 2014
Revocaciones. Apoderado: CORAL MORRAL DAVID;MARTINEZ PEREZ CONCHA;MEDINA EXPOSITO PABLOJESUS;GUTIERREZ SANZ JORGE ROMAN. Apo.Manc.: YHERLA CAMPA脩A JORDI. Nombramientos. Apo.Manc.: CORALMORRAL DAVID;YHERLA CAMPA脩A JORDI;MEDINA EXPOSITO PABLO JESUS;GUTIERREZ SANZ JORGE ROMAN. Datosregistrales. T 24246 , F 102, S 8, H M 81815, I/A 44 (22.05.14).

27 de Marzo de 2014
Nombramientos. Apo.Manc.: YHERLA CAMPA脩A JORDI. Datos registrales. T 24246 , F 101, S 8, H M 81815, I/A 43 (20.03.14).

17 de Marzo de 2014
Ceses/Dimisiones. Representan: KEENAN SHERMAN PETER. Nombramientos. Representan: WALSHE WILLIAM ST JOHN.Datos registrales. T 24246 , F 101, S 8, H M 81815, I/A 42 ( 5.03.14).

19 de Febrero de 2014
Revocaciones. Apoderado: KEENAN SHERMAN PETER. Nombramientos. Apoderado: FRANCESCUTTI ALESSIA. Datosregistrales. T 24246 , F 100, S 8, H M 81815, I/A 41 (11.02.14).

14 de Febrero de 2014
Revocaciones. Apoderado: MARTINEZ CORTES JAIME;MARTINEZ PEREZ CONCHA;MEDINA EXPOSITO PABLOJESUS;GUTIERREZ SANZ JORGE ROMAN. Nombramientos. Apoderado: CORAL MORRAL DAVID;MARTINEZ PEREZCONCHA;MEDINA EXPOSITO PABLO JESUS;GUTIERREZ SANZ JORGE ROMAN. Datos registrales. T 24246 , F 100, S 8, H M81815, I/A 40 ( 7.02.14).

13 de Febrero de 2014
Ceses/Dimisiones. Consejero: KEENAN SHERMAN PETER;BBDO ESPA脩A SA;BYRNES JOHN J;MARK WALKERJOHN;MARTINEZ CORTES JAIME PABLO. Presidente: KEENAN SHERMAN PETER. Nombramientos. Consejero: BBDO ESPA脩ASA;BYRNES JOHN J;MARK WALKER JOHN;FRANCESCUTTI ALESSIA. Presidente: FRANCESCUTTI ALESSIA. Datos registrales.T 24246 , F 99, S 8, H M 81815, I/A 39 ( 5.02.14).

18 de Abril de 2013
Nombramientos. Auditor: KPMG AUDITORES SL. Datos registrales. T 24246 , F 99, S 8, H M 81815, I/A 38 (10.04.13).

01 de Abril de 2013
Revocaciones. Apoderado: MARTINEZ CORTES JAIME;MARTINEZ PEREZ CONCHA;BARRAGAN FERNANDEZ LUISJAVIER;GUTIERREZ SANZ JORGE ROMAN. Nombramientos. Apoderado: MARTINEZ CORTES JAIME;MARTINEZ PEREZCONCHA;MEDINA EXPOSITO PABLO JESUS;GUTIERREZ SANZ JORGE ROMAN. Datos registrales. T 24246 , F 98, S 8, H M81815, I/A 37 (19.03.13).

03 de Enero de 2013
Ceses/Dimisiones. Consejero: BBDO ESPA脩A SA;MARTINEZ CORTES JAIME PABLO;BYRNES JOHN J;MARK WALKERJOHN;KEENAN SHERMAN PETER. Presidente: KEENAN SHERMAN PETER. Representan: KEENAN SHERMAN PETER.Nombramientos. Consejero: KEENAN SHERMAN PETER;BBDO ESPA脩A SA;BYRNES JOHN J;MARK WALKER JOHN;MARTINEZCORTES JAIME PABLO. Presidente: KEENAN SHERMAN PETER. Representan: KEENAN SHERMAN PETER. Datos registrales. T24246 , F 98, S 8, H M 81815, I/A 36 (21.12.12).

09 de Octubre de 2012
Modificaciones estatutarias. COMO CONSECUENCIA DE LA EXTINCION PARCIAL DE PRESTACIONES ACCESORIAS, SEMODIFICAN LOS ARTICULOS 5 Y 6 DE LOS ESTATUTOSSOCIALES. Datos registrales. T 24246 , F 97, S 8, H M 81815, I/A 35(27.09.12).

26 de Septiembre de 2012
Ceses/Dimisiones. Representan: BA脩UELOS DE LUCAS MIGUEL ANGEL. Nombramientos. Representan: SHERMAN PETERKEENAN. Datos registrales. T 24246 , F 97, S 8, H M 81815, I/A 34 (17.09.12).

24 de Septiembre de 2012
Ceses/Dimisiones. Secretario: FERRER LORENZO JOSE IGNACIO. Nombramientos. SecreNoConsj: GUTIERREZ SANZ JORGEROMAN. Datos registrales. T 24246 , F 96, S 8, H M 81815, I/A 32 (13.09.12).

Revocaciones. Apoderado: FERRER LORENZO JOSE IGNACIO;MARTINEZ CORTES JAIME PABLO;MARTINEZ PEREZCONCHA;BARRAGAN FERNANDEZ LUIS. Nombramientos. Apoderado: MARTINEZ CORTES JAIME;MARTINEZ PEREZCONCHA;BARRAGAN FERNANDEZ LUIS JAVIER;GUTIERREZ SANZ JORGE ROMAN. Datos registrales. T 24246 , F 97, S 8, H M81815, I/A 33 (13.09.12).

20 de Junio de 2011
Nombramientos. Apoderado: SHERMAN PETER KEENAN. Datos registrales. T 24246 , F 96, S 8, H M 81815, I/A 31 ( 8.06.11).

16 de Junio de 2011
Ceses/Dimisiones. Consejero: BA脩UELOS DE LUCAS MIGUEL ANGEL. Presidente: BA脩UELOS DE LUCAS MIGUEL ANGEL.Nombramientos. Consejero: SHERMAN PETER KEENAN. Presidente: SHERMAN PETER KEENAN. Datos registrales. T 24246 , F96, S 8, H M 81815, I/A 30 ( 3.06.11).

25 de Enero de 2011
Otros conceptos: SEGREGACION DE LA UNIDAD DE NEGOCIO UBICADA EN BARCELONA DESARROLLADA POR LASOCIEDAD "NEURONICS DATA INTELLIGENCE, S.A.", EN FAVOR DE LA DOMICILIADA EN DICHA CIUDAD, DENOMINADA "CPPROXIMITY BARCELONA S.L.". Datos registrales. T 24246 , F 92, S 8, H M 81815, I/A 29 (13.01.11).

22 de Septiembre de 2010
Revocaciones. Apo.Manc.: FERRER LORENZO JOSE IGNACIO;MARTINEZ CORTES JAIME;MARTINEZ PEREZCONCHA;MEDINA EXPOSITO PABLO JESUS. Nombramientos. Apoderado: FERRER LORENZO JOSE IGNACIO;MARTINEZCORTES JAIME PABLO;MARTINEZ PEREZ CONCHA;BARRAGAN FERNANDEZ LUIS. Datos registrales. T 24246 , F 92, S 8, H M81815, I/A 28 (13.09.10).

Utilizamos cookies de terceros con finalidades anal铆ticas, de personalizaci贸n, y de publicidad comportamental. Puede configurar ahora el uso de esta tecnolog铆a. Si acepta o contin煤a navegando, consideramos que est谩 de acuerdo con su uso. Mas informaci贸n