Actos BORME de Neutra Network Services Sl
30 de Diciembre de 2019Disoluci贸n. Fusion. Extinci贸n. Datos registrales. T 37459 , F 11, S 8, H M 549915, I/A 37 (20.12.19).
28 de Noviembre de 2019Revocaciones. Apoderado: RUIZ SERRANO DANIEL. Datos registrales. T 37459 , F 10, S 8, H M 549915, I/A 36 (21.11.19).
26 de Junio de 2019Modificaciones estatutarias. SE INCLUYE EL ARTICULO 8 BIS EN LOS ESTATUTOS SOCIALES.. Datos registrales. T 37459 , F10, S 8, H M 549915, I/A 35 (19.06.19).
13 de Septiembre de 2018Nombramientos. Apoderado: DE LA TORRE RODRIGUEZ MARIA. Datos registrales. T 37459 , F 9, S 8, H M 549915, I/A 34 (6.09.18).
04 de Julio de 2018Nombramientos. Apoderado: RUIZ SERRANO DANIEL. Datos registrales. T 37459 , F 8, S 8, H M 549915, I/A 33 (26.06.18).
20 de Junio de 2018Cambio de domicilio social. AVDA DE LA VEGA 15 (ALCOBENDAS). Datos registrales. T 37459 , F 8, S 8, H M 549915, I/A 32(13.06.18).
14 de Junio de 2018Revocaciones. Apoderado: MOLINA ZAMORA FERNANDO. Datos registrales. T 37459 , F 8, S 8, H M 549915, I/A 31 ( 5.06.18).
05 de Junio de 2018Nombramientos. Apo.Man.Soli: DUATO SALMERON EDUARDO. Datos registrales. T 37459 , F 4, S 8, H M 549915, I/A 29(28.05.18).
Nombramientos. Apo.Man.Soli: MONTERO SANCHEZ ANTONIO JESUS. Datos registrales. T 37459 , F 7, S 8, H M 549915, I/A 30(28.05.18).
03 de Abril de 2018Revocaciones. Apoderado: GONZALEZ DE LUNA I脩IGO. Apo.Man.Soli: FERNANDEZ AMIGO BARRANCO JAVIER. Apo.Manc.:TEJERA OSUNA CARLOS;GONZALEZ DE LUNA I脩IGO. Apo.Sol.: SANCHEZ DEL RIO Y PRECIOSO MARIA ABIGAIL. Datosregistrales. T 30554 , F 222, S 8, H M 549915, I/A 24 (22.03.18).
Nombramientos. Apoderado: MEDINA SANTAMARIA ARTURO;BLASCO MORENO JORGE;SUAREZ GARCIA MIGUELANGEL;LOPEZ FERNANDEZ GERMAN;GUERRERO FERRER VICTOR;MARIN DE LA PLAZA FRANCISCO JAVIER;DEL CORROGARCIA LOMAS JOSE MARIA;DELGADO DOMINGUEZ JUAN LUIS. Datos registrales. T 30554 , F 222, S 8, H M 549915, I/A 25(22.03.18).
Nombramientos. Apoderado: FREIRE BARRAL PABLO;LOPEZ GRANADOS BELEN. Datos registrales. T 30554 , F 225, S 8, H M549915, I/A 26 (22.03.18).
Nombramientos. Apoderado: MOLINA ZAMORA FERNANDO;SANTOS FERNANDEZ MIGUEL. Datos registrales. T 37459 , F 1, S8, H M 549915, I/A 27 (22.03.18).
Nombramientos. Apoderado: PASCUAL ZARATE PILAR. Datos registrales. T 37459 , F 2, S 8, H M 549915, I/A 28 (22.03.18).
23 de Marzo de 2018Revocaciones. Auditor: DELOITTE SL. Datos registrales. T 30554 , F 221, S 8, H M 549915, I/A 22 (15.03.18).
Sociedad unipersonal. Cambio de identidad del socio 煤nico: MASMOVIL BROADBAND SA. Ceses/Dimisiones. Adm. Unico:PEDROSILLO SANCHEZ CARLOS. Nombramientos. Adm. Unico: SPENGER MEINRAD. Datos registrales. T 30554 , F 221, S 8,H M 549915, I/A 23 (16.03.18).
01 de Marzo de 2018Revocaciones. Apo.Sol.: MURGA PEREZ BUSTAMANTE PEDRO;GORDILLO FLORENCIO MANUEL;BLASCO GARCIA ANA.Apoderado: DOMINGUEZ RIOS JAVIER;JIMENEZ MAYORGA MARIA EUGENIA. Datos registrales. T 30554 , F 220, S 8, H M549915, I/A 20 (21.02.18).
Ampliaci贸n de capital. Capital: 4.000.000,00 Euros. Resultante Suscrito: 13.115.300,00 Euros. Datos registrales. T 30554 , F 221,S 8, H M 549915, I/A 21 (21.02.18).
05 de Enero de 2018Nombramientos. Auditor: DELOITTE SL. Datos registrales. T 30554 , F 220, S 8, H M 549915, I/A 19 (27.12.17).
07 de Diciembre de 2017Ceses/Dimisiones. Consejero: FERNANDEZ AMIGO BARRANCO JAVIER;TEJERA OSUNA CARLOS. Presidente: TEJERA OSUNACARLOS. Consejero: MEDINA SANTAMARIA ARTURO. Con.Delegado: MEDINA SANTAMARIA ARTURO. SecreNoConsj: SANCHEZDEL RIO Y PRECIOSO MARIA ABIGAIL. Nombramientos. Adm. Unico: PEDROSILLO SANCHEZ CARLOS. Otros conceptos:Cambio del Organo de Administraci贸n: Consejo de administraci贸n a Administrador 煤nico. Datos registrales. T 30554 , F 220, S 8, HM 549915, I/A 18 (29.11.17).
07 de Agosto de 2017Ceses/Dimisiones. Consejero: TALDE ADVISORS SL. Representan: DELGADO MATIAS MIGUEL. SecreNoConsj: ALBA FERRELUIS. VsecrNoConsj: SANCHEZ DEL RIO Y PRECIOSO MARIA ABIGAIL. Nombramientos. SecreNoConsj: SANCHEZ DEL RIO YPRECIOSO MARIA ABIGAIL. Datos registrales. T 30554 , F 204, S 8, H M 549915, I/A 17 (26.07.17).
22 de Septiembre de 2016Modificaciones estatutarias. Art铆culo de los estatutos: 4潞. Domicilio social .-. Cambio de domicilio social. C/ O'DONNELL 34,PLANTA 7 (MADRID). Datos registrales. T 30554 , F 204, S 8, H M 549915, I/A 16 (14.09.16).
03 de Febrero de 2016Ceses/Dimisiones. Consejero: GONZALEZ DE LUNA I脩IGO. Con.Delegado: GONZALEZ DE LUNA I脩IGO. Nombramientos.Consejero: MEDINA SANTAMARIA ARTURO. Con.Delegado: MEDINA SANTAMARIA ARTURO. Datos registrales. T 30554 , F 203,
12 de Enero de 2016Ampliaci贸n de capital. Capital: 20.000,00 Euros. Resultante Suscrito: 9.100.000,00 Euros. Datos registrales. T 30554 , F 202, S 8,H M 549915, I/A 13 ( 4.01.16).
Ampliaci贸n de capital. Capital: 15.300,00 Euros. Resultante Suscrito: 9.115.300,00 Euros. Datos registrales. T 30554 , F 203, S 8,H M 549915, I/A 14 ( 4.01.16).
07 de Agosto de 2015Ceses/Dimisiones. Secretario: TALDE ADVISORS SL. Nombramientos. SecreNoConsj: ALBA FERRE LUIS. Datos registrales. T30554 , F 202, S 8, H M 549915, I/A 12 (28.07.15).
04 de Agosto de 2015Ceses/Dimisiones. Consejero: GORDILLO & PARTNERS SL. Representan: GORDILLO FLORENCIO MANUEL. Presidente:GORDILLO & PARTNERS SL. Nombramientos. Consejero: TEJERA OSUNA CARLOS. Presidente: TEJERA OSUNA CARLOS.Datos registrales. T 30554 , F 202, S 8, H M 549915, I/A 11 (27.07.15).
27 de Abril de 2015Ceses/Dimisiones. Consejero: ARRANZ SOLER CESAR. Nombramientos. Auditor: ERNST & YOUNG SL. Datos registrales. T30554 , F 201, S 8, H M 549915, I/A 10 (20.04.15).
25 de Febrero de 2015Modificaciones estatutarias. SE MODIFICA LOS ARTICULOS 20 APARTADO 6, 23 Y 24 DE LOS ESTATUTOS SOCIALES.. Datosregistrales. T 30554 , F 200, S 8, H M 549915, I/A 9 (17.02.15).