Actos BORME de Nexea Gestion Documental Sa Sme
25 de Mayo de 2023Otros conceptos: El 11 de abril de 2023 fue insertado en la p谩gina web corporativa de la Sociedad absorbente, SOCIEDADESTATAL CORREOS Y TELEGRAFOS SA S.M.E., el Proyecto de Fusi贸n por absorci贸n conforme al cual la SOCIEDAD ESTATALCORREOS Y TELEGRAFOS SA S.M.E absorber谩 a NEXEA GESTION DOCUMENTA SA S.M.E. Datos registrales. T 14499 , F 150,S 8, H M 239913, I/A 1.M (18.05.23).
26 de Abril de 2023Ceses/Dimisiones. Consejero: SACHEZ MIRA ROCIO. Datos registrales. T 42375 , F 102, S 8, H M 239913, I/A 91 (19.04.23).
01 de Febrero de 2023Otros conceptos: Inserci贸n en la p谩gina web de la sociedad absorbida www.nexea.es del proyecto com煤n de fusi贸n por absorci贸n de"NEXEA GESTION DOCUMENTAL S.A. S.M.E." como sociedad absorbida, por "SOCIEDAD ESTATAL CORREOS Y TELEGRAFOSS.A. S.M.E", como sociedad absorbente, el d铆a 22 de diciembre de 2022. Datos registrales. T 14499 , F 149, S 8, H M 239913, I/A 1m (25.01.23).
25 de Noviembre de 2022Fe de erratas: Se public贸 por error en la inscripci贸n 88陋 el nombramiento como consejero de CERVERA GRAJERA ENRIQUE, siendolo correcto CERVERA GRAJERA ENRIQUE JESUS. Datos registrales. T 42375 , F 101, S 8, H M 239913, I/A 88 (11.11.22).
22 de Noviembre de 2022Reelecciones. Auditor: GRANT THORNTON SLP. Datos registrales. T 42375 , F 102, S 8, H M 239913, I/A 90 (15.11.22).
18 de Noviembre de 2022Ceses/Dimisiones. Consejero: PEINADO JIMENEZ SERGIO-IGNACIO. Nombramientos. Consejero: CERVERA GRAJERAENRIQUE. Datos registrales. T 42375 , F 101, S 8, H M 239913, I/A 88 (11.11.22).
Ceses/Dimisiones. Cons.Ejecuti: GIL VALENTIN ELENA. Nombramientos. Consejero: SACHEZ MIRA ROCIO. Datos registrales.T 42375 , F 102, S 8, H M 239913, I/A 89 (11.11.22).
17 de Noviembre de 2022Reelecciones. Auditor: GRANT THORNTON SLP. Datos registrales. T 42375 , F 101, S 8, H M 239913, I/A 87 (10.11.22).
15 de Octubre de 2021Revocaciones. Apoderado: MARTINEZ MU脩OZ ALVARO. Apo.Manc.: MARTINEZ MU脩OZ ALVARO;MARTINEZ MU脩OZALVARO;MARTINEZ MU脩OZ ALVARO. Nombramientos. Apoderado: COUVERT FRANETOVICH SANTIAGO;CASTA脩O OSCARADIS;ALONSO NISTAL JOSE LUIS;COUVERT FRANETOVICH SANTIAGO. Datos registrales. T 34010 , F 211, S 8, H M 239913,I/A 86 ( 7.10.21).
22 de Julio de 2021Ceses/Dimisiones. Cons.Ejecuti: RAMIREZ PALACIN ENRIQUE. Nombramientos. Consejero: PEINADO JIMENEZ SERGIO-IGNACIO. Datos registrales. T 34010 , F 211, S 8, H M 239913, I/A 85 (15.07.21).
16 de Junio de 2021Ceses/Dimisiones. Presidente: RAMIREZ PALACIN ENRIQUE. Revocaciones. Apo.Manc.: RAMIREZ PALACIN ENRIQUE.Nombramientos. Presidente: CASTA脩O OSCAR ADIS. Apo.Manc.: CASTA脩O OSCAR ADIS;MARTINEZ MU脩OZ ALVARO. Datosregistrales. T 34010 , F 208, S 8, H M 239913, I/A 83 ( 9.06.21).
Revocaciones. Apo.Man.Soli: CANO GONZALEZ JOSE MANUEL. Apoderado: CANO GONZALEZ JOSE MANUEL.Nombramientos. Apo.Man.Soli: ALONSO NISTAL JOSE LUIS. Apo.Manc.: CASTA脩O OSCAR ADIS;MARTINEZ MU脩OZ ALVARO.Datos registrales. T 34010 , F 209, S 8, H M 239913, I/A 84 ( 9.06.21).
15 de Junio de 2021Nombramientos. Consejero: CASTA脩O OSCAR ADIS. Datos registrales. T 34010 , F 207, S 8, H M 239913, I/A 82 ( 8.06.21).
24 de Diciembre de 2020Nombramientos. Apo.Manc.: MARTINEZ MU脩OZ ALVARO;RAMIREZ PALACIN ENRIQUE. Datos registrales. T 34010 , F 206, S8, H M 239913, I/A 81 (17.12.20).
20 de Agosto de 2020Revocaciones. Apo.Man.Soli: SANZ AUBERT BRIAN. Nombramientos. Apoderado: CANO GONZALEZ JOSE MANUEL;RAMIREZPALACIN ENRIQUE;MARTINEZ MU脩OZ ALVARO. Datos registrales. T 34010 , F 204, S 8, H M 239913, I/A 80 (13.08.20).
10 de Agosto de 2020Ceses/Dimisiones. Cons.Ejecuti: CASTRO LOPEZ AVELINO. Nombramientos. Consejero: GIL VALENTIN ELENA. Datosregistrales. T 34010 , F 204, S 8, H M 239913, I/A 79 ( 3.08.20).
28 de Octubre de 2019Revocaciones. Apo.Manc.: BARBERAN MARTIN LAURA. Apoderado: BARBERAN MARTIN LAURA. Nombramientos.Apo.Man.Soli: CANO GONZALEZ JOSE MANUEL;SANZ AUBERT BRIAN. Apo.Manc.: RAMIREZ PALACIN ENRIQUE. Otrosconceptos: Revocado el poder conferido a Do帽a Laura Barberan Mart铆n en escritura autorizada por el Notario de Madrid Don JuanKutz Azqueta el 12 de julio de 2016 con el n煤mero 802 de protocolo y que caus贸 la inscripci贸n 59陋 de la hoja social. Datosregistrales. T 34010 , F 203, S 8, H M 239913, I/A 78 (21.10.19).
11 de Octubre de 2019Nombramientos. Cons.Ejecuti: LEON CORRALES JAVIER. Datos registrales. T 34010 , F 202, S 8, H M 239913, I/A 75 ( 4.10.19).
Nombramientos. Apo.Sol.: MEDINA DE ARESPACOCHAGA ANA TERESA. Datos registrales. T 34010 , F 202, S 8, H M 239913,I/A 76 ( 4.10.19).
Ceses/Dimisiones. Consejero: MILLAN RUIZ CARLOS. Datos registrales. T 34010 , F 202, S 8, H M 239913, I/A 77 ( 4.10.19).
09 de Octubre de 2019Revocaciones. Apo.Manc.: MEDINA MARTIN OSCAR. Nombramientos. Apoderado: BARBERAN MARTIN LAURA;SABAN PEREZRAQUEL;CRESPO GONZALEZ ANA ISABEL;MOYA DE LA RICA MARTA;DOBLE RODRIGUEZ CARMEN;SOLANO MARTINTRINIDAD;RAMIREZ PALACIN ENRIQUE. Datos registrales. T 34010 , F 200, S 8, H M 239913, I/A 74 ( 2.10.19).
16 de Julio de 2019Ceses/Dimisiones. SecreNoConsj: VACAS CHALFOUN LUIS ENRIQUE. Revocaciones. Apo.Sol.: VACAS CHALFOUN LUISENRIQUE. Nombramientos. SecreNoConsj: MEDINA DE ARESPACOCHAGA ANA TERESA. Datos registrales. T 34010 , F 199, S8, H M 239913, I/A 72 ( 9.07.19).
Nombramientos. Cons.Ejecuti: PEREZ PASTOR JOSE LUIS. Datos registrales. T 34010 , F 200, S 8, H M 239913, I/A 73 (9.07.19).
15 de Abril de 2019Nombramientos. Apoderado: MARCO GARCIA SANTIAGO;VAQUERO OSCAR PALOMINO. Datos registrales. T 34010 , F 199, S8, H M 239913, I/A 71 ( 8.04.19).
21 de Marzo de 2019Nombramientos. Consj.Domini: REVILLA HUERTA MARIA DOLORES. Datos registrales. T 34010 , F 198, S 8, H M 239913, I/A 69(14.03.19).
Nombramientos. Apo.Sol.: REJAS TELLO MONICA;VACAS CHALFOUN LUIS ENRIQUE. Datos registrales. T 34010 , F 199, S 8,H M 239913, I/A 70 (14.03.19).
20 de Marzo de 2019Nombramientos. Auditor: GRANT THORNTON SLP. Datos registrales. T 34010 , F 198, S 8, H M 239913, I/A 68 (13.03.19).
19 de Marzo de 2019Ceses/Dimisiones. SecreNoConsj: GARCIA DUARTE MATILDE. VsecrNoConsj: DE LA CRUZ LOPEZ PABLO. Consejero: SANZGARCIA JAIME;FERNANDEZ DE LA RIVA GOZALVEZ LOURDES;MEDINA MARTIN OSCAR;ALONSO POZA ALBERTO. Presidente:MEDINA MARTIN OSCAR. Nombramientos. SecreNoConsj: VACAS CHALFOUN LUIS ENRIQUE. Cons.Ejecuti: PAVO LOPEZ EVAMARIA;RAMIREZ PALACIN ENRIQUE;CASTRO LOPEZ AVELINO. Presidente: RAMIREZ PALACIN ENRIQUE. Datos registrales. T34010 , F 197, S 8, H M 239913, I/A 67 (12.03.19).
23 de Julio de 2018Nombramientos. VsecrNoConsj: DE LA CRUZ LOPEZ PABLO. Datos registrales. T 34010 , F 197, S 8, H M 239913, I/A 66(16.07.18).
09 de Mayo de 2018Ceses/Dimisiones. SecreNoConsj: BOTELLA PEDRAZA ALVARO. Nombramientos. SecreNoConsj: GARCIA DUARTE MATILDE.Datos registrales. T 34010 , F 197, S 8, H M 239913, I/A 65 (27.04.18).
25 de Agosto de 2017Reelecciones. Auditor: PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES SL. Datos registrales. T 34010 , F 196, S 8, H M 239913,I/A 64 (17.08.17).
23 de Agosto de 2017Ceses/Dimisiones. Consejero: CU脩ADO AUSIN GREGORIO. Reelecciones. Consejero: MEDINA MARTIN OSCAR;ALONSOPOZA ALBERTO. Presidente: MEDINA MARTIN OSCAR. Datos registrales. T 34010 , F 196, S 8, H M 239913, I/A 63 (10.08.17).
03 de Julio de 2017Nombramientos. Apoderado: MEDINA MARTIN OSCAR. Datos registrales. T 34010 , F 196, S 8, H M 239913, I/A 62 (23.06.17).
20 de Febrero de 2017Nombramientos. Consejero: MILLAN RUIZ CARLOS. Datos registrales. T 34010 , F 195, S 8, H M 239913, I/A 60 (13.02.17).