Actos BORME de Nexus Information Tecnology Sa
27 de Diciembre de 2023Reelecciones. Auditor: MAZARS AUDITORES SLP. Datos registrales. T 46041 , F 20, S 8, H M 193375, I/A 68 (19.12.23).
12 de Diciembre de 2023Nombramientos. Apoderado: BAKER TILLY ESPA脩A SLP. Datos registrales. T 39544 , F 80, S 8, H M 193375, I/A 67 ( 1.12.23).
06 de Septiembre de 2023Nombramientos. Apo.Man.Soli: TAVARES GUERREIRO GOMES PEDRO NUNO;CARUS RIESGO MARIA JOSE. Datosregistrales. T 39544 , F 75, S 8, H M 193375, I/A 63 (30.08.23).
Nombramientos. Apo.Man.Soli: CARUS RIESGO MARIA JOSE;TAVARES GUERREIRO GOMES PEDRO NUNO. Datosregistrales. T 39544 , F 77, S 8, H M 193375, I/A 64 (30.08.23).
Nombramientos. Apo.Sol.: DIEZ RODRIGUEZ SANTIAGO;BAZAN GIL LIDIA;DIAZ CUEVAS CRISTINA;ALVARO CORTES JONANDER;RODRIGUEZ REDONDO DIANA;MATO MILLAN MARIA DEL CARMEN;GOMEZ LUELMO TERESA;ALCOLEA CANTOSANTONIO;GARCIA MOSQUERA PABLO. Datos registrales. T 39544 , F 79, S 8, H M 193375, I/A 65 (30.08.23).
Nombramientos. Apoderado: BAKER TILLY ESPA脩A SLP. Datos registrales. T 39544 , F 80, S 8, H M 193375, I/A 66 (30.08.23).
05 de Septiembre de 2023Revocaciones. Apoderado: LION RESOURCES IBERIA SL. Apo.Man.Soli: BOUGUERRA LEILA;CARRACEDO BUENOJULIO;CARUS RIESGO MARIA JOSE;MEHTA ATUL PUSHKARApoderado: LION RESOURCES IBERIA SL;FINS ALBERT NEIL;DAHORA E SILVA CRUZ MACARA HUMBERTO JORGE;DA HORA E SILVA CRUZ MACARA HUMBERTO JORGE;DE SOUSASOBRAL LUIS MIGUEL;TAVARES GUERREIRO GOMES PEDRO NUNO;DA HORA E SILVA CRUZ MACARA HUMBERTO JORGE.Datos registrales. T 39544 , F 69, S 8, H M 193375, I/A 60 (29.08.23).
Nombramientos. Apo.Man.Soli: DE SOUSA SOBRAL LUIS MIGUEL. Apo.Manc.: TAVARES GUERREIRO GOMES PEDRONUNO;CARUS RIESGO MARIA JOSE. Datos registrales. T 39544 , F 69, S 8, H M 193375, I/A 61 (29.08.23).
Nombramientos. Apo.Man.Soli: DA HORA E SILVA CRUZ MACARA HUMBERTO JORGE. Apo.Manc.: TAVARES GUERREIROGOMES PEDRO NUNO;CARUS RIESGO MARIA JOSE. Datos registrales. T 39544 , F 72, S 8, H M 193375, I/A 62 (29.08.23).
04 de Septiembre de 2023Ceses/Dimisiones. Consejero: DE SOUSA SOBRAL LUIS MIGUEL;TAVARES GUERREIRO GOMES PEDRO NUNO;DA HORA ESILVA CRUZ MACARA HUMBERTO JORGE. Presidente: TAVARES GUERREIRO GOMES PEDRO NUNO. Secretario: DA HORA E
30 de Enero de 2023Reelecciones. Auditor: MAZARS AUDITORES SLP. Datos registrales. T 39544 , F 66, S 8, H M 193375, I/A 58 (23.01.23).
14 de Septiembre de 2022Nombramientos. Apoderado: DA HORA E SILVA CRUZ MACARA HUMBERTO JORGE. Datos registrales. T 39544 , F 65, S 8, HM 193375, I/A 57 ( 7.09.22).
06 de Abril de 2022Nombramientos. Apoderado: DA HORA E SILVA CRUZ MACARA HUMBERTO JORGE. Datos registrales. T 39544 , F 64, S 8, HM 193375, I/A 54 (30.03.22).
Nombramientos. Apoderado: DA HORA E SILVA CRUZ MACARA HUMBERTO JORGE;DE SOUSA SOBRAL LUISMIGUEL;TAVARES GUERREIRO GOMES PEDRO NUNO. Datos registrales. T 39544 , F 64, S 8, H M 193375, I/A 55 (30.03.22).
Nombramientos. Apoderado: DIEZ RODRIGUEZ SANTIAGO;REDON REVUELTA BEGO脩A;DIAZ CUEVAS CRISTINA. Datosregistrales. T 39544 , F 65, S 8, H M 193375, I/A 56 (30.03.22).
20 de Enero de 2022Reelecciones. Auditor: MAZARS AUDITORES SLP. Datos registrales. T 39544 , F 63, S 8, H M 193375, I/A 53 (13.01.22).
19 de Noviembre de 2021Sociedad unipersonal. Cambio de identidad del socio 煤nico: VORTAL SGPS SA. Ceses/Dimisiones. SecreNoConsj: ORPEZUCEDA JOSE LUIS. VsecrNoConsj: CAMARERO MARTIN OLGA. Consejero: BOUGUERRA LEILA. Vicepresid.: BOUGUERRALEILA. Consejero: MEHTA ATUL PUSHKAR;FINS ALBERT NEIL. Presidente: FINS ALBERT NEIL. Nombramientos. Consejero: DESOUSA SOBRAL LUIS MIGUEL;TAVARES GUERREIRO GOMES PEDRO NUNO;DA HORA E SILVA CRUZ MACARA HUMBERTOJORGE. Presidente: TAVARES GUERREIRO GOMES PEDRO NUNO. Secretario: DA HORA E SILVA CRUZ MACARA HUMBERTOJORGE. Datos registrales. T 39544 , F 63, S 8, H M 193375, I/A 52 (12.11.21).
13 de Abril de 2021Ceses/Dimisiones. Consejero: SIGNORE KRISTEN EMILY. Presidente: SIGNORE KRISTEN EMILY. SecreNoConsj: CERRILLOARIAS PATRICIA. Revocaciones. Apo.Man.Soli: SIGNORE KRISTEN EMILY. Nombramientos. Consejero: FINS ALBERT NEIL.Presidente: FINS ALBERT NEIL. SecreNoConsj: ORPEZ UCEDA JOSE LUIS. Apoderado: FINS ALBERT NEIL;VIADA FRAILEDAMERIS. Datos registrales. T 39544 , F 62, S 8, H M 193375, I/A 51 ( 6.04.21).
18 de Noviembre de 2020Reelecciones. Auditor: MAZARS AUDITORES SLP. Datos registrales. T 39544 , F 62, S 8, H M 193375, I/A 50 (11.11.20).
11 de Septiembre de 2020Revocaciones. Apo.Man.Soli: ALVEAR PEREZ JAIME. Otros conceptos: Modificado el Anexo A relativo a la lista de bancosprincipales del poder conferido en escritura autorizada por el Notario de Madrid Don Manuel Richi Alberti el 23 de julio de 2019 con eln煤mero 2700 de protocolo que caus贸 la inscripci贸n 47陋 de la hoja social. Datos registrales. T 39544 , F 61, S 8, H M 193375, I/A 49 (4.09.20).
05 de Diciembre de 2019Reelecciones. Auditor: MAZARS AUDITORES SLP. Datos registrales. T 39544 , F 61, S 8, H M 193375, I/A 48 (28.11.19).
26 de Agosto de 2019Ceses/Dimisiones. Consejero: CARUS RIESGO MARIA JOSE;STURGEON EWEN CAMERON;BOUGUERRA LEILA. Presidente:STURGEON EWEN CAMERON. Vicepresid.: CARUS RIESGO MARIA JOSE. Revocaciones. Apoderado: STURGEON EWEN
22 de Agosto de 2018Reelecciones. Auditor: MAZARS AUDITORES SLP. Datos registrales. T 31867 , F 198, S 8, H M 193375, I/A 46 (13.08.18).
12 de Septiembre de 2017Nombramientos. Apoderado: LION RESOURCES IBERIA SL. Datos registrales. T 31867 , F 197, S 8, H M 193375, I/A 45 (5.09.17).
25 de Agosto de 2017Reelecciones. Auditor: MAZARS AUDITORES SLP. Datos registrales. T 31867 , F 197, S 8, H M 193375, I/A 44 (16.08.17).
08 de Agosto de 2016Reelecciones. Auditor: MAZARS AUDITORES SLP. Datos registrales. T 31867 , F 197, S 8, H M 193375, I/A 43 (29.07.16).
15 de Marzo de 2016Nombramientos. Apoderado: ALVEAR PEREZ JAIME;ALVEAR PEREZ JAIME. Datos registrales. T 31867 , F 196, S 8, H M193375, I/A 41 ( 7.03.16).
Otros conceptos: MODIFICADO EL ANEXO A RELATIVO A LA LISTA DE BANCOS PRINCIPALES, QUE CONSTA EN LAESCRITURA QUE ORIGINO LA INSCRIPCION 38&. Datos registrales. T 31867 , F 197, S 8, H M 193375, I/A 42 ( 7.03.16).
19 de Octubre de 2015Ampliacion del objeto social. a) La planificaci贸n, realizaci贸n, organizaci贸n y gesti贸n de todo tipo de medidas, actuacionesyactividades de marketing y publicidad de cualesquiera naturaleza tanto en el 谩mbito y mercado convencionales como en el 谩mbito delas nuevas tecnolog铆as, tecnolog铆as de la informaci贸n . Fusi贸n por absorci贸n. Sociedades absorbidas: LBI SPAIN DIGITALAGENCY SL. Datos registrales. T 31867 , F 192, S 8, H M 193375, I/A 40 ( 8.10.15).
02 de Diciembre de 2014Modificaciones estatutarias. Se modifica el art铆culo 11 y el apartado b) del art铆culo 18 de los Estatutos Sociales.. Datos registrales.T 31867 , F 191, S 8, H M 193375, I/A 39 (24.11.14).
18 de Agosto de 2014Otros conceptos: MODIFICADO EL ANEXO A RELATIVO A LA LISTA DE BANCOS PRINCIPALES, QUE CONSTA EN LAESCRITURA QUE ORIGINO LA INSCRIPCION 36&. Datos registrales. T 31867 , F 191, S 8, H M 193375, I/A 38 ( 6.08.14).
28 de Mayo de 2014Nombramientos. Auditor: MAZARS AUDITORES SLP. Datos registrales. T 31867 , F 191, S 8, H M 193375, I/A 37 (20.05.14).
24 de Marzo de 2014Sociedad unipersonal. Cambio de identidad del socio 煤nico: MULTI MARKET SERVICES SPAIN HOLDINGS SL.Ceses/Dimisiones. Adm. Solid.: CARUS RIESGO MARIA JOSE;WEZENBERG HUBERTUS JOHANNES FRANCISCUS.Revocaciones. Apoderado: CARRACEDO BUENO JULIO. Nombramientos. SecreNoConsj: CERRILLO ARIAS PATRICIA.VsecrNoConsj: CAMARERO MARTIN OLGA. Consejero: CARUS RIESGO MARIA JOSE;STURGEON EWENCAMERON;BOUGUERRA LEILA. Presidente: STURGEON EWEN CAMERON. Vicepresid.: CARUS RIESGO MARIA JOSE.Apoderado: STURGEON EWEN CAMERON;BOUGUERRA LEILA;CARUS RIESGO MARIA JOSE;CARRACEDO BUENO JULIO;LIONRESOURCES IBERIA SL. Modificaciones estatutarias. Se modifican los art铆culos 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 y 19 de losEstatutos sociales y se dejan sin contenido los art铆culos 20, 25, 26 y 28 de los Estatutos Sociales.. Cambio del Organo deAdministraci贸n: Administradores solidarios a Consejo de administraci贸n. Datos registrales. T 12222 , F 223, S 8, H M 193375, I/A 36(17.03.14).
05 de Marzo de 2014Sociedad unipersonal. Cambio de identidad del socio 煤nico: LBI INTERNACIONAL NV. Datos registrales. T 12222 , F 223, S 8,H M 193375, I/A 35 (24.02.14).
11 de Marzo de 2013Reelecciones. Auditor: PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES SL. Datos registrales. T 12222 , F 223, S 8, H M 193375,I/A 34 ( 4.03.13).
10 de Julio de 2012Reelecciones. Auditor: PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES SL. Datos registrales. T 12222 , F 223, S 8, H M 193375,I/A 33 (28.06.12).
16 de Marzo de 2012Cambio de domicilio social. C/ JOSE ECHEGARAY NUMERO 8, EDIFICIO 3, PARQUE ALV (ROZAS DE MADRID (LAS)). Datosregistrales. T 12222 , F 223, S 8, H M 193375, I/A 32 ( 6.03.12).
07 de Julio de 2011Reelecciones. Auditor: PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES SL. Datos registrales. T 12222 , F 222, S 8, H M 193375,I/A 31 (27.06.11).
18 de Marzo de 2011Reelecciones. Auditor: PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES SL. Datos registrales. T 12222 , F 222, S 8, H M 193375,I/A 30 ( 7.03.11).
24 de Septiembre de 2009Reelecciones. Auditor: PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES SL. Datos registrales. T 12222 , F 222, S 8, H M 193375,I/A 28 (14.09.09).
Ceses/Dimisiones. Adm. Solid.: EDGARD CORDESIUS THEODORE FRANCIS. Nombramientos. Adm. Solid.: WEZENBERGHUBERTUS JOHANNES FRANCISCUS. Datos registrales. T 12222 , F 222, S 8, H M 193375, I/A 29 (15.09.09).