Actos BORME de Nirvauto La Mancha Sociedad Anonima
18 de Agosto de 2022Ceses/Dimisiones. Liquidador: NIRVAUTO SOCIEDAD ANONIMA. Adm. Unico: NIRVAUTO SOCIEDAD ANONIMA. Revocaciones.Apoderado: YESTE PALACIOS MARIANO;VIVES MARTINEZ ANDRES. Nombramientos. Liquidador: NIRVAUTO SOCIEDADANONIMA. Disoluci贸n. Voluntaria. Extinci贸n. Datos registrales. T 993, L 757, F 179, S 8, H AB 6565, I/A 35 (10.08.22).
11 de Septiembre de 2019Reelecciones. Adm. Unico: NIRVAUTO SOCIEDAD ANONIMA. Datos registrales. T 993, L 757, F 179, S 8, H AB 6565, I/A 34 (4.09.19).
08 de Mayo de 2018Revocaciones. Apoderado: VIVES MARTINEZ ANDRES. Nombramientos. Apoderado: VIVES MARTINEZ ANDRES. Datosregistrales. T 931, L 695, F 139, S 8, H AB 6565, I/A 33 (27.04.18).
06 de Mayo de 2014Revocaciones. Apoderado: SERRANO VIVES JUAN MIGUEL. Datos registrales. T 931, L 695, F 139, S 8, H AB 6565, I/A 32(25.04.14).
02 de Julio de 2013Revocaciones. Apoderado: CALVENTE ALVAREZ ANTONIO MANUEL. Datos registrales. T 931, L 695, F 139, S 8, H AB 6565, I/A31 (25.06.13).
22 de Mayo de 2013Nombramientos. Apoderado: CALVENTE ALVAREZ ANTONIO MANUEL. Datos registrales. T 931, L 695, F 138, S 8, H AB 6565,I/A 30 (14.05.13).
21 de Mayo de 2013Ceses/Dimisiones. Consejero: VIVES FERRANDIZ PEDRO. Presidente: VIVES FERRANDIZ PEDRO. Consejero: CALVENTEALVAREZ ANTONIO MANUEL. Secretario: CALVENTE ALVAREZ ANTONIO MANUEL. Consejero: VIVES IGUALADA PEDROVICENTE. Con.Delegado: VIVES IGUALADA PEDRO VICENTE. Consejero: VIVES MARTINEZ JUAN CARLOS;SERRANO VIVESJUAN MIGUEL. Con.Delegado: CALVENTE ALVAREZ ANTONIO MANUEL. Consejero: CENTENO PULIDO FERNANDO.Nombramientos. Adm. Unico: NIRVAUTO SOCIEDAD ANONIMA. Modificaciones estatutarias. Art铆culo de los estatutos:ARTICULO 20潞.- Del 贸rgano de administraci贸n, nombramiento y composici贸n. 20.1. La Sociedad estar谩 regida y administrada por unADMINISTRADOR UNICO, a quien tambi茅n le corresponde la representaci贸n de la Sociedad,en juicio y fuera de 茅l. 20.2. Larepresentaci贸n se ARTICULO 21潞.- Retribuci贸n. El cargo de Administrador se desempe帽a de forma gratuita. ARTICULO 23潞.-Ejecuci贸n de acuerdos. 23.1. La facultad de certificar las actas corresponde al Administrador Unico. 23.2. La elevaci贸n a p煤blico de losacuerdos sociales corresponde al Administrador Unico. 23.3. Tambi茅n podr谩n ser elevadosa p煤blico por cualquier persona que ostenteestas. Otros conceptos: Derogaci贸n del Art铆culo 22潞 de los Estatutos Sociales. Datos registrales. T 897, L 661, F 38, S 8, H AB6565, I/A 29 (13.05.13).
23 de Julio de 2012Reelecciones. Consejero: CENTENO PULIDO FERNANDO. Datos registrales. T 897, L 661, F 38, S 8, H AB 6565, I/A 28(12.07.12).
10 de Noviembre de 2010Revocaciones. Apo.Sol.: CALVENTE ALVAREZ ANTONIO MANUEL. Datos registrales. T 897, L 661, F 38, S 8, H AB 6565, I/A 27(29.10.10).
30 de Junio de 2010Nombramientos. Apoderado: VIVES MARTINEZ ANDRES. Datos registrales. T 823, L 587, F 172, S 8, H AB 6565, I/A 26(21.06.10).
12 de Enero de 2010Revocaciones. Auditor: APRADAS AUDITORES SOCIEDAD LIMITADA PROFESIONAL. Datos registrales. T 823, L 587, F 172, S8, H AB 6565, I/A 25 (31.12.09).
24 de Agosto de 2009Reelecciones. Consejero: VIVES FERRANDIZ PEDRO. Presidente: VIVES FERRANDIZ PEDRO. Consejero: CALVENTE ALVAREZANTONIO MANUEL. Secretario: CALVENTE ALVAREZ ANTONIO MANUEL. Consejero: VIVES IGUALADA PEDRO VICENTE.Con.Delegado: VIVES IGUALADA PEDRO VICENTE. Consejero: VIVES MARTINEZ JUAN CARLOS;SERRANO VIVES JUANMIGUEL. Con.Delegado: CALVENTE ALVAREZ ANTONIO MANUEL. Ampliaci贸n de capital. Suscrito: 1.500.000,00 Euros.Desembolsado: 1.500.000,00 Euros. Resultante Suscrito: 5.500.000,00 Euros. Resultante Desembolsado: 5.500.000,00 Euros. Datosregistrales. T 823, L 587, F 172, S 8, H AB 6565, I/A 24 (14.08.09).