Buscador CIF Logo

Actos BORME Nisa Nuevas Inversiones En Servicios Sociedad Anonima

¿Quieres acceder a la API de EMPRESAS CIF? Obten la información de todas las empresas en tiempo real desde tu plataforma.
Ahora con un 25% de DESCUENTO el primer MES. Quiero la API de EMPRESAS

Logo cabecera Nisa Nuevas Inversiones En Servicios Sociedad Anonima

Actos BORME Nisa Nuevas Inversiones En Servicios Sociedad Anonima - A46036984

Tenemos registrados 60 Actos BORME del Registro Mercantil de Valencia para Nisa Nuevas Inversiones En Servicios Sociedad Anonima con CIF A46036984

🔙 Perfil de Nisa Nuevas Inversiones En Servicios Sociedad Anonima
🛒 Comprar listado completo de Empresas de Valencia

Actos BORME de Nisa Nuevas Inversiones En Servicios Sociedad Anonima

30 de Noviembre de 2023
Reelecciones. Auditor: PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES SL. Datos registrales. T 10852, L 8131, F 165, S 8, H V16220, I/A 160 (23.11.23).

24 de Julio de 2023
Reelecciones. Adm. Solid.: GIL CELMA FRANCISCO JAVIER. Datos registrales. T 10852, L 8131, F 165, S 8, H V 16220, I/A 159(17.07.23).

28 de Febrero de 2023
Revocaciones. Apo.Sol.: CABRERIZO EXTREMERA ABEL. Datos registrales. T 10852, L 8131, F 165, S 8, H V 16220, I/A 158(21.02.23).

13 de Febrero de 2023
Nombramientos. Apo.Sol.: MUÑOZ CUEVAS RAQUEL. Datos registrales. T 10852, L 8131, F 163, S 8, H V 16220, I/A 157 (6.02.23).

08 de Febrero de 2023
Nombramientos. Apoderado: ONCINS FANNING MARIA DEL PILAR. Datos registrales. T 10852, L 8131, F 163, S 8, H V 16220,I/A 156 ( 1.02.23).

28 de Diciembre de 2022
Reelecciones. Auditor: PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES SL. Aud.C.Con.: PRICEWATERHOUSECOOPERSAUDITORES SL. Datos registrales. T 10852, L 8131, F 163, S 8, H V 16220, I/A 155 (20.12.22).

04 de Noviembre de 2022
Revocaciones. Apoderado: MARTINEZ ABASOLO MARIA LUISA. Datos registrales. T 10852, L 8131, F 163, S 8, H V 16220, I/A154 (27.10.22).

07 de Octubre de 2022
Nombramientos. Apoderado: ACASO LLAMAS SILVIA. Datos registrales. T 10852, L 8131, F 162, S 8, H V 16220, I/A 153(30.09.22).

14 de Enero de 2022
Reelecciones. Auditor: PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES SL. Datos registrales. T 10852, L 8131, F 162, S 8, H V16220, I/A 152 ( 7.01.22).

31 de Diciembre de 2021
Modificaciones estatutarias. Se modifica el artículo 14º de los Estatutos Sociales en cuanto a la página web de la Sociedad. Páginaweb de la sociedad. Traslado de la página web corporativa.Nueva página web: https://vithas.es/quienes-somos/accionistas/sociedad-nisa. Datos registrales. T 10852, L 8131, F 161, S 8, H V 16220, I/A 151 (24.12.21).

02 de Noviembre de 2021
Revocaciones. Apoderado: RODRIGUEZ BERNABE JESUS. Datos registrales. T 10852, L 8131, F 161, S 8, H V 16220, I/A 150(25.10.21).

14 de Octubre de 2021
Nombramientos. Apoderado: RICO PEREZ PEDRO CANDIDO. Datos registrales. T 10852, L 8131, F 161, S 8, H V 16220, I/A 149( 5.10.21).

25 de Junio de 2021
Nombramientos. Apo.Sol.: CABRERIZO EXTREMERA ABEL;MARQUEZ SIEVERS OSCAR. Datos registrales. T 10852, L 8131, F160, S 8, H V 16220, I/A 148 (18.06.21).

21 de Mayo de 2021
Nombramientos. Apo.Sol.: NAVARRO MARTINEZ-AVIAL IGNACIO;MORA GARCIA JUAN. Datos registrales. T 10852, L 8131, F159, S 8, H V 16220, I/A 147 (14.05.21).

28 de Abril de 2021
Nombramientos. Apo.Sol.: ALVAREZ LLANAS ANA. Datos registrales. T 10852, L 8131, F 157, S 8, H V 16220, I/A 146 (21.04.21).

03 de Febrero de 2021
Revocaciones. Apoderado: MONTENEGRO GRAU JOAQUIN RAFAEL. Datos registrales. T 10852, L 8131, F 157, S 8, H V 16220,I/A 145 (27.01.21).

13 de Noviembre de 2020
Reelecciones. Auditor: PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES SL. Datos registrales. T 10852, L 8131, F 157, S 8, H V16220, I/A 144 ( 5.11.20).

07 de Octubre de 2020
Revocaciones. Apoderado: MATEO SANZ GERARDO. Datos registrales. T 10852, L 8131, F 157, S 8, H V 16220, I/A 143(30.09.20).

06 de Octubre de 2020
Nombramientos. Apo.Sol.: VERDU LLORCA VICTORIA. Datos registrales. T 4549, L 1860, F 225, S 8, H V 16220, I/A 142(29.09.20).

17 de Agosto de 2020
Nombramientos. Apo.Sol.: VERDU LLORCA VICTORIA. Datos registrales. T 4549, L 1860, F 224, S 8, H V 16220, I/A 141(10.08.20).

20 de Febrero de 2020
Nombramientos. Apo.Sol.: MATA GARCIA DEL VALLE ICIAR. Datos registrales. T 4549, L 1860, F 223, S 8, H V 16220, I/A 140(13.02.20).

10 de Febrero de 2020
Modificaciones estatutarias. Se traslada la página Web inscrita por la siguiente https://vithas.es/Valencia, con la consiguientemodificación del artículo 14º de los Estatutos Sociales. . Página web de la sociedad. Traslado de la página web corporativa.Nuevapágina web: https://vithas.es/Valencia. Datos registrales. T 4549, L 1860, F 223, S 8, H V 16220, I/A 139 (31.01.20).

20 de Diciembre de 2019
Nombramientos. Apoderado: CALERO MANZANERO RAQUEL. Datos registrales. T 4549, L 1860, F 222, S 8, H V 16220, I/A 138(13.12.19).

04 de Noviembre de 2019
Ceses/Dimisiones. Adm. Solid.: PARDO IZQUIERDO JOSE LUIS. Nombramientos. Adm. Solid.: RICO PEREZ PEDRO CANDIDO.Datos registrales. T 4549, L 1860, F 222, S 8, H V 16220, I/A 137 (25.10.19).

03 de Mayo de 2019
Nombramientos. Apoderado: VITHAS SANIDAD SL. Datos registrales. T 4549, L 1860, F 221, S 8, H V 16220, I/A 136 (24.04.19).

23 de Abril de 2019
Revocaciones. Apoderado: NOZAL AYUSO JUAN-CARLOS. Datos registrales. T 4549, L 1860, F 221, S 8, H V 16220, I/A 135(12.04.19).

16 de Abril de 2019
Nombramientos. Apoderado: MARTINEZ ABASOLO MARIA LUISA. Datos registrales. T 4549, L 1860, F 220, S 8, H V 16220, I/A134 ( 9.04.19).

22 de Enero de 2019
Nombramientos. Apoderado: RODRIGUEZ BERNABE JESUS. Datos registrales. T 4549, L 1860, F 219, S 8, H V 16220, I/A 133(15.01.19).

22 de Noviembre de 2018
Revocaciones. Apoderado: CARRASCOSA CORTES JOSE LUIS. Datos registrales. T 4549, L 1860, F 219, S 8, H V 16220, I/A132 (15.11.18).

17 de Enero de 2018
Revocaciones. Auditor: ERNST & YOUNG SL. Aud.C.Con.: ERNST & YOUNG SL. Nombramientos. Auditor:PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES SL. Aud.C.Con.: PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES SL. Datosregistrales. T 4549, L 1860, F 219, S 8, H V 16220, I/A 131 (10.01.18).

27 de Septiembre de 2017
Nombramientos. Apoderado: NOZAL AYUSO JUAN-CARLOS. Datos registrales. T 4549, L 1860, F 218, S 8, H V 16220, I/A 130(20.09.17).

17 de Agosto de 2017
Cambio de objeto social. El objeto social está integrado por las siguientes actividades: (i) La explotación mercantil en forma deprestación de servicios mediante remuneración de servicios de hospitalización y asistencia médica quirúrgica-farmacéutica. Para ellose podrá valer la Sociedad de toda clase de sanatorios o polic. Datos registrales. T 4549, L 1860, F 217, S 8, H V 16220, I/A 129 (9.08.17).

22 de Mayo de 2017
Ceses/Dimisiones. Consejero: GINER QUILIS MANUEL. Presidente: GINER QUILIS MANUEL. Consejero: HONRUBIA LOPEZJOSE;GIL MORET CONSUELO ISABEL;GIL MORET DESAMPARADOS. Vicepresid.: HONRUBIA LOPEZ JOSE. Consejero:SANATORIO DE NUESTRA SEÑORA DE LA SALUD DE GRANADA;XANIT HEALTH CARE MANAGEMENT SL;VITHAS SANIDADINTERNACIONAL SL;VITHAS SANIDAD SL. SecreNoConsj: ADELL SANCHEZ JORGE. Nombramientos. Adm. Solid.: PARDOIZQUIERDO JOSE LUIS;GIL CELMA FRANCISCO JAVIER. Modificaciones estatutarias. Artículo 28.- Retribución El cargo deadministrador no será retribuido. Otros conceptos: Como consecuencia de los cambio efectuados en determinados artículos de losEstatutos Sociales, se refunden la totalidad de los mismos en un solo texto. Cambio del Organo de Administración: Consejo deadministración a Administradores solidarios. La duración del cargo de Administrador será de SEIS AÑOS. Cambio de objeto social.El objeto social está integrado por las siguientes actividades: la explotación mercantil en forma de prestación de servicios medianteremuneración de servicios de hospitalización y asistencia médica quirúrgica-farmacéutica. Para ello se podrá valer la Sociedad de todaclase de sanatorios o policlíni. Página web de la sociedad. Creación de la página web corporativa: www.hospitales.nisa.es. Datosregistrales. T 4549, L 1860, F 215, S 8, H V 16220, I/A 127 (12.05.17).

Nombramientos. Apoderado: ADELL SANCHEZ JORGE;PONS ESTRADE LAURA;POL LONGO DIEGO;GARCIA FUSTER LAURA.Datos registrales. T 4549, L 1860, F 217, S 8, H V 16220, I/A 128 (12.05.17).

16 de Marzo de 2017
Ceses/Dimisiones. SecreNoConsj: FITA TORTOSA FRANCISCO. VsecrNoConsj: IBAÑEZ BENLLOCH JESUS. Consejero: ROIGNEBOT ELISA. M.Comit.Aud: ROIG NEBOT ELISA. Cons.Del.Man: HONRUBIA LOPEZ JOSE;GINER QUILIS MANUEL. Director:RIBELLES ARELLANO SANTIAGO. Cons.Del.Man: ROIG NEBOT ELISA. M.Comit.Aud: GIL MORET DESAMPARADOS.R.L.C.Perma.: SILES LOPEZ JOSE;NEBOT PELLICER ANTONIO. Revocaciones. Apoderado: MURCIA GARCIAFRANCISCO;MURCIA GARCIA FRANCISCO;MATAIX SANCHO CARLOS. Nombramientos. SecreNoConsj: ADELL SANCHEZJORGE. Consejero: SANATORIO DE NUESTRA SEÑORA DE LA SALUD DE GRANADA;XANIT HEALTH CARE MANAGEMENTSL;VITHAS SANIDAD INTERNACIONAL SL. Otros conceptos: se cesa a DON MANUEL GINER QUILIS y se nombra a DON JOSELUIS PARDO IZQUIERDO, DNI 73.077.036-X, como persona física representante de la sociedad de esta hoja en el cargo deAdministrador de las sociedades HOSPITAL REY DON JAIME SL, GESNISA SEVILLA SL, HOSPITAL NISA SEVILLA ALJARAFE SL.se cesa a DON MANUEL GINER QUILIS y se nombra a DON JOSE LUIS PARDO IZQUIERDO, DNI 73.077.036-X, como personafísica representante de la sociedad de esta hoja en el cargo de Administrador de las sociedades HOSPITAL PARDO DE ARAVACASA, ACTUACIONES VALENCIA SUR, SL, NISA DENTAL SL, se cesa a DON MANUEL GINER QUILIS y se nombra a DON JOSELUIS PARDO IZQUIERDO, DNI 73.077.036-X, como persona física representante de la sociedad de esta hoja en el cargo deAdministrador de las sociedades HOSPITAL VALENCIA AL MAR SL y HOSPITAL 9 DE OCTUBRE SA. Datos registrales. T 4549, L1860, F 213, S 8, H V 16220, I/A 124 ( 9.03.17).

Nombramientos. Apoderado: PARDO IZQUIERDO JOSE LUIS. Datos registrales. T 4549, L 1860, F 214, S 8, H V 16220, I/A 125 (9.03.17).

Ceses/Dimisiones. Consejero: NEBOT OYANGUREN JUAN ANTONIO. M.Comit.Aud: NEBOT OYANGUREN JUAN ANTONIO.Consejero: PASCUAL VENTURA MANUEL;GINER QUILIS AMBROSIO IGNACIO. Nombramientos. Consejero: VITHAS SANIDADSL. Datos registrales. T 4549, L 1860, F 214, S 8, H V 16220, I/A 126 ( 9.03.17).

20 de Diciembre de 2016
Ceses/Dimisiones. Consejero: SANCHEZ MINGUET MARTINEZ TERESA. Secretario: SANCHEZ MINGUET MARTINEZ TERESA.Consejero: GINER GRIMA FRANCISCO. Vicepresid.: GINER GRIMA FRANCISCO. Nombramientos. SecreNoConsj: FITATORTOSA FRANCISCO. VsecrNoConsj: IBAÑEZ BENLLOCH JESUS. Vicepresid.: HONRUBIA LOPEZ JOSE. Datos registrales. T4549, L 1860, F 212, S 8, H V 16220, I/A 123 (13.12.16).

31 de Octubre de 2016
Ceses/Dimisiones. Consejero: AVIÑO VIGUER JOSE;AVIÑO MIRA JOSE CARLOS. Cons.Del.Man: GINER GRIMAFRANCISCO;AVIÑO VIGUER JOSE. Nombramientos. Cons.Del.Man: HONRUBIA LOPEZ JOSE. Datos registrales. T 4549, L1860, F 212, S 8, H V 16220, I/A 122 (24.10.16).

30 de Agosto de 2016
Nombramientos. Cons.Del.Man: ROIG NEBOT ELISA. M.Comit.Aud: ROIG NEBOT ELISA;GIL MORET DESAMPARADOS;NEBOTOYANGUREN JUAN ANTONIO. Datos registrales. T 4549, L 1860, F 56, S 8, H V 16220, I/A 121 (23.08.16).

01 de Agosto de 2016
Ceses/Dimisiones. Consejero: RAMIREZ PERIS ENRIQUE;GIL MORET DEMETRIO;MARTINEZ OCHOA FRANCISCO JAVIER.Cons.Del.Man: RAMIREZ PERIS ENRIQUE. Nombramientos. Consejero: GIL MORET CONSUELO ISABEL;GIL MORETDESAMPARADOS;PASCUAL VENTURA MANUEL. Datos registrales. T 4549, L 1860, F 56, S 8, H V 16220, I/A 119 (21.07.16).

Nombramientos. Aud.C.Con.: ERNST & YOUNG SL. Auditor: ERNST & YOUNG SL. Datos registrales. T 4549, L 1860, F 56, S 8, HV 16220, I/A 120 (25.07.16).

18 de Agosto de 2015
Nombramientos. Consejero: AVIÑO MIRA JOSE CARLOS. Reelecciones. Consejero: AVIÑO VIGUER JOSE;GIL MORETDEMETRIO;GINER QUILIS AMBROSIO IGNACIO;HONRUBIA LOPEZ JOSE;SANCHEZ MINGUET MARTINEZ TERESA. Secretario:SANCHEZ MINGUET MARTINEZ TERESA. Cons.Del.Man: AVIÑO VIGUER JOSE. Datos registrales. T 4549, L 1860, F 55, S 8, H V16220, I/A 117 (11.08.15).

Reelecciones. Aud.C.Con.: GRANT THORNTON SLP. Auditor: GRANT THORNTON SLP. Datos registrales. T 4549, L 1860, F 56,S 8, H V 16220, I/A 118 (11.08.15).

29 de Julio de 2014
Reelecciones. Auditor: GRANT THORNTON SLP. Aud.C.Con.: GRANT THORNTON SLP. Datos registrales. T 4549, L 1860, F 55,S 8, H V 16220, I/A 116 (22.07.14).

07 de Agosto de 2013
Reelecciones. Aud.C.Con.: GRANT THORNTON SLP. Auditor: GRANT THORNTON SLP. Datos registrales. T 4549, L 1860, F 55,S 8, H V 16220, I/A 115 (31.07.13).

15 de Julio de 2013
Reelecciones. Consejero: GINER QUILIS MANUEL;GINER GRIMA FRANCISCO;MARTINEZ OCHOA FRANCISCOJAVIER;RAMIREZ PERIS ENRIQUE;ROIG NEBOT ELISA;NEBOT OYANGUREN JUAN ANTONIO. Presidente: GINER QUILISMANUEL. Vicepresid.: GINER GRIMA FRANCISCO. Cons.Del.Man: GINER GRIMA FRANCISCO;RAMIREZ PERIS ENRIQUE;GINER

07 de Agosto de 2012
Reelecciones. Auditor: GRANT THORNTON SLP. Aud.C.Con.: GRANT THORNTON SLP. Datos registrales. T 4549, L 1860, F 53,S 8, H V 16220, I/A 113 (26.07.12).

05 de Junio de 2012
Ceses/Dimisiones. Cons.Del.Man: HONRUBIA LOPEZ JOSE. Nombramientos. Cons.Del.Man: RAMIREZ PERIS ENRIQUE.Datos registrales. T 4549, L 1860, F 53, S 8, H V 16220, I/A 112 (25.05.12).

27 de Julio de 2011
Cancelaciones de oficio de nombramientos. Miem.Com.Ej.: AVIÑO VIGUER JOSE. Pres.Com.Ej.: AVIÑO VIGUER JOSE.Reelecciones. Consejero: SANCHEZ MINGUET MARTINEZ MARIA TERESA. Secretario: SANCHEZ MINGUET MARTINEZ MARIATERESA. Consejero: AVIÑO VIGUER JOSE;GIL MORET DEMETRIO;GINER QUILIS AMBROSIO IGNACIO. Cons.Del.Man: AVIÑOVIGUER JOSE. Consejero: HONRUBIA LOPEZ JOSE. Cons.Del.Man: HONRUBIA LOPEZ JOSE. Datos registrales. T 4471, L 1783,F 225, S 8, H V 16220, I/A 110 (15.07.11).

Reelecciones. Auditor: GRANT THORNTON SLP. Aud.C.Con.: GRANT THORNTON SLP. Datos registrales. T 4549, L 1860, F 53,S 8, H V 16220, I/A 111 (15.07.11).

26 de Agosto de 2010
Otros conceptos: Ratificados los nombramientos por cooptación a favor de DONENRIQUE RAMIREZ PERIS Y DE DONFRANCISCO JAVIER MURCIA GARCIA, que fueron objeto de la inscripción 108.- Datos registrales. T 4471, L 1783, F 225, S 8, H V16220, I/A 109 (17.08.10).

18 de Mayo de 2010
Ceses/Dimisiones. Consejero: PASCUAL VENTURA MARIA JOSE;MURCIA GARCIA FRANCISCO. Nombramientos. Consejero:RAMIREZ PERIS ENRIQUE;MARTINEZ OCHOA FRANCISCO JAVIER. Datos registrales. T 4471, L 1783, F 225, S 8, H V 16220,I/A 108 ( 7.05.10).

27 de Noviembre de 2009
Nombramientos. Apoderado: MATEO SANZ GERARDO. Datos registrales. T 4471, L 1783, F 224, S 8, H V 16220, I/A 106(18.11.09).

Revocaciones. Apoderado: BUSO CORTES JESUS IGNACIO. Datos registrales. T 4471, L 1783, F 225, S 8, H V 16220, I/A 107(18.11.09).

09 de Octubre de 2009
Nombramientos. Apoderado: MONTENEGRO GRAU JOAQUIN RAFAEL. Datos registrales. T 4471, L 1783, F 224, S 8, H V16220, I/A 105 (30.09.09).

04 de Septiembre de 2009
Ceses/Dimisiones. D. Gerente: SILES LOPEZ JOSE;ROSA TORNER ALBERTO;SILES LOPEZ JOSE. Revocaciones. Apoderado:DIEZ ZABALETA ALBERTO;PARET Y BIBILONI MIGUEL;GARCIA OTERO JESUS;NEBOT CALZA JOAQUIN;RUBIO RIBESESTEBAN;RUBIO RIBES ESTEBAN;SAN MARTIN ECHAURI BEGOÑA;BAYO MAICAS SIXTO. Datos registrales. T 4471, L 1783, F224, S 8, H V 16220, I/A 104 (26.08.09).

10 de Agosto de 2009
Fe de erratas: En el envío 141/2009, se omitió por error, hacer constar que la Junta General de la sociedad NISA NUEVASINVERSIONES EN SERVICIOS SA, ha ratificado el nombramiento efectuado por cooptación a DON JUAN ANTONIO NEBOTOYANGUREN como Consejero. Datos registrales. T 4471, L 1783, F 223, S 8, H V 16220, I/A 103 (29.07.09).

07 de Agosto de 2009
Ceses/Dimisiones. Miem.Com.Ej.: GINER GRIMA FRANCISCO. Sec.Com.Ej.: GINER QUILIS MANUEL. Miem.Com.Ej.: GINERQUILIS MANUEL. Nombramientos. Cons.Del.Man: HONRUBIA LOPEZ JOSE. Reelecciones. Consejero: GINER QUILISMANUEL;MURCIA GARCIA FRANCISCO. Vicepresid.: GINER GRIMA FRANCISCO. Consejero: PASCUAL VENTURA MARIAJOSE;GINER GRIMA FRANCISCO. Presidente: GINER QUILIS MANUEL. Consejero: ROIG NEBOT ELISA. Cons.Del.Man: GINERGRIMA FRANCISCO;GINER QUILIS MANUEL. Datos registrales. T 4471, L 1783, F 223, S 8, H V 16220, I/A 103 (29.07.09).

05 de Mayo de 2009
Ceses/Dimisiones. Consejero: CASADO CASASECA SANTIAGO. Nombramientos. Consejero: NEBOT OYANGUREN JUANANTONIO. Datos registrales. T 4471, L 1783, F 223, S 8, H V 16220, I/A 102 (23.04.09).

Utilizamos cookies de terceros con finalidades analíticas, de personalización, y de publicidad comportamental. Puede configurar ahora el uso de esta tecnología. Si acepta o continúa navegando, consideramos que está de acuerdo con su uso. Mas información