Actos BORME de Nor Rubber Sal
29 de Marzo de 2023Nombramientos. Auditor: K4 IBERICA AUDITORES SLP. Datos registrales. T 4247, L 4247, F 156, S 8, H PO 27709, I/A 40(20.03.23).
21 de Septiembre de 2022Cancelaciones de oficio de nombramientos. Consejero: ALONSO GONZALEZ MANUEL;AMANDI GOMEZ JESUS;MARTINEZVIDAL JUAN JOSE;MOREIRA JIMENEZ MANUEL;VAZ ALONSO ALEJO;VENINGA BURGOS MARIA NIEVES;VILA AREAL JOSEMANUEL. Cons.Del.Man: ALONSO GONZALEZ MANUEL;AMANDI GOMEZ JESUS;MARTINEZ VIDAL JUAN JOSE;MOREIRAJIMENEZ MANUEL;VAZ ALONSO ALEJO. Vicepresid.: VAZ ALONSO ALEJO. Cons.Del.Man: VENINGA BURGOS MARIA NIEVES.Secretario: VENINGA BURGOS MARIA NIEVES. Cons.Del.Man: VILA AREAL JOSE MANUEL. Presidente: VILA AREAL JOSEMANUEL. Nombramientos. Consejero: VERDE MARTINEZ MIGUEL. Secretario: VERDE MARTINEZ MIGUEL. Consejero:VENINGA BURGOS MARIA NIEVES. Presidente: VENINGA BURGOS MARIA NIEVES. Consejero: ALVAREZ BARGIELAVICTORINO. Vicepresid.: ALVAREZ BARGIELA VICTORINO. Consejero: ALONSO GONZALEZ MANUEL;ALVAREZ PENEDOALFONSO;MARI脩O DURAN PEDRO;PAMPIN PENEDO DANIEL. Cons.Del.Man: ALONSO GONZALEZ MANUEL;ALVAREZBARGIELA VICTORINO;ALVAREZ PENEDO ALFONSO;MARI脩O DURAN PEDRO;PAMPIN PENEDO DANIEL;VENINGA BURGOSMARIA NIEVES;VERDE MARTINEZ MIGUEL. Datos registrales. T 4247, L 4247, F 155, S 8, H PO 27709, I/A 39 (12.09.22).
19 de Enero de 2022Nombramientos. Auditor: K4 IBERICA AUDITORES SLP. Datos registrales. T 4247, L 4247, F 155, S 8, H PO 27709, I/A 38(11.01.22).
10 de Marzo de 2021Reducci贸n de capital. Importe reducci贸n: 287.950,00 Euros. Resultante Suscrito: 1.151.800,00 Euros. Otros conceptos: Semodifican los art铆culos 6 y 7 de los estatutos sociales relativos al capital social y las clases de acciones, respectivamente. Datosregistrales. T 4247, L 4247, F 154, S 8, H PO 27709, I/A 37 (26.02.21).
28 de Enero de 2021Nombramientos. Aud.Supl.: K4 IBERICA AUDITORES SOCIEDAD LIMITADA PROFESIONAL. Reelecciones. Auditor: CARBALLOFIDALGO MARIA PILAR. Datos registrales. T 4247, L 4247, F 154, S 8, H PO 27709, I/A 36 (20.01.21).
08 de Julio de 2020Reelecciones. Auditor: CARBALLO FIDALGO MARIA PILAR. Aud.Supl.: AUDITA 2 PRADILLA SLP. Datos registrales. T 4247, L4247, F 154, S 8, H PO 27709, I/A 35 (30.06.20).
18 de Diciembre de 2019Reducci贸n de capital. Importe reducci贸n: 282.175,00 Euros. Resultante Suscrito: 1.439.750,00 Euros. Datos registrales. T 4247, L4247, F 153, S 8, H PO 27709, I/A 34 (10.12.19).
10 de Julio de 2019Reelecciones. Auditor: CARBALLO FIDALGO MARIA PILAR. Aud.Supl.: AUDITA 2 PRADILLA SLP. Datos registrales. T 4247, L4247, F 153, S 8, H PO 27709, I/A 33 ( 2.07.19).
30 de Noviembre de 2018Nombramientos. Aud.Supl.: AUDITA 2 PRADILLA SLP. Reelecciones. Auditor: CARBALLO FIDALGO MARIA PILAR. Datosregistrales. T 4247, L 4247, F 152, S 8, H PO 27709, I/A 32 (22.11.18).
09 de Agosto de 2018Ceses/Dimisiones. Cons.Del.Man: MOREIRA JIMENEZ MANUEL;VAZ ALONSO ALEJO;VENINGA BURGOS MARIANIEVES;SOLLA AROS JOSE MANUEL;MARTINEZ VIDAL JUAN JOSE;ALONSO GONZALEZ MANUEL;VILA AREAL JOSE MANUEL.Consejero: SOLLA AROS JOSE MANUEL. Nombramientos. Consejero: AMANDI GOMEZ JESUS. Cons.Del.Man: MARTINEZVIDAL JUAN JOSE;MOREIRA JIMENEZ MANUEL;VAZ ALONSO ALEJO;VENINGA BURGOS MARIA NIEVES;VILA AREAL JOSEMANUEL. Apo.Man.Soli: GONZALEZ VAZQUEZ JAVIER ESTEBAN. Cons.Del.Man: AMANDI GOMEZ JESUS;ALONSO GONZALEZMANUEL. Reelecciones. Consejero: ALONSO GONZALEZ MANUEL;MARTINEZ VIDAL JUAN JOSE;MOREIRA JIMENEZMANUEL;VAZ ALONSO ALEJO;VENINGA BURGOS MARIA NIEVES;VILA AREAL JOSE MANUEL. Presidente: VILA AREAL JOSEMANUEL. Secretario: VENINGA BURGOS MARIA NIEVES. Vicepresid.: VAZ ALONSO ALEJO. Adaptaci贸n Ley 44/2015. Otrosconceptos: SE REFUNDEN LOS ESTATUTOS SOCIALES. Datos registrales. T 3166, L 3166, F 224, S 8, H PO 27709, I/A 31 (2.08.18).
06 de Octubre de 2017Cancelaciones de oficio de nombramientos. Aud.Supl.: GODOY VAZQUEZ MARTA. Nombramientos. Aud.Supl.: FERNANDEZDE LA PRADILLA MEIJIDE PATRICIA. Reelecciones. Auditor: CARBALLO FIDALGO MARIA PILAR. Datos registrales. T 3166, L3166, F 223, S 8, H PO 27709, I/A 30 (26.09.17).
13 de Octubre de 2016Otros conceptos: Se modifica el art铆culo 17潞 de los Estatutos sociales relativo a la publicaci贸n de la convocatoria de las Juntas.P谩gina web de la sociedad. Creaci贸n de la p谩gina web corporativa: www.norrubber.com. Datos registrales. T 3166, L 3166, F 223,S 8, H PO 27709, I/A 29 ( 3.10.16).
23 de Febrero de 2016Reducci贸n de capital. Importe reducci贸n: 234.612,00 Euros. Resultante Suscrito: 2.479.572,00 Euros. Reducci贸n de capital.Importe reducci贸n: 757.647,00 Euros. Resultante Suscrito: 1.721.925,00 Euros. Datos registrales. T 3166, L 3166, F 222, S 8, H PO27709, I/A 28 (15.02.16).
26 de Noviembre de 2015Reelecciones. Auditor: CARBALLO FIDALGO MARIA PILAR. Aud.Supl.: GODOY VAZQUEZ MARTA. Datos registrales. T 3166, L3166, F 222, S 8, H PO 27709, I/A 27 (16.11.15).
08 de Mayo de 2015Reducci贸n de capital. Importe reducci贸n: 706.860,00 Euros. Resultante Suscrito: 2.714.184,00 Euros. Datos registrales. T 3166, L3166, F 221, S 8, H PO 27709, I/A 26 (28.04.15).
30 de Enero de 2015Fe de erratas: En la inscripci贸n 20& de la sociedad NOR RUBBER SAL se indic贸 como fecha de adopci贸n de los acuerdos delConsejo el 30 de junio de 2012 cuando la fecha correcta es 6 de julio de 2012. Datos registrales. T 3064, L 3064, F 210, S 8, H PO27709, I/A 20 (28.08.12).
24 de Septiembre de 2014Cancelaciones de oficio de nombramientos. Aud.Supl.: GONZALEZ TENORIO PABLO. Nombramientos. Auditor: CARBALLOFIDALGO MARIA PILAR. Aud.Supl.: GODOY VAZQUEZ MARTA. Datos registrales. T 3166, L 3166, F 221, S 8, H PO 27709, I/A 24(12.09.14).
22 de Septiembre de 2014Nombramientos. Consejero: VAZ ALONSO ALEJO. Datos registrales. T 3064, L 3064, F 210, S 8, H PO 27709, I/A 20 (28.08.12).
Reelecciones. Auditor: CARBALLO FIDALGO MARIA PILAR. Aud.Supl.: GODOY VAZQUEZ MARTA. Datos registrales. T 3166, L3166, F 221, S 8, H PO 27709, I/A 25 (12.09.14).
17 de Diciembre de 2013Modificaciones estatutarias. Art铆culo 10 .- Extinci贸n de la Relaci贸n Laboral.- 1. En caso de extinci贸n de la relaci贸n laboral del sociotrabajador, 茅ste habr谩 de ofrecer la adquisici贸n de sus acciones conforme a lo dispuesto en el art铆culo 7 y si nadie ejercita su derechode adquisici贸n, conservar谩 aqu茅l la cualidad de socio. Otros conceptos: MODIFICACION DEL APARTADO 2a DEL ARTICULO 10DE LOS ESTATUTOS SOCIALES. Datos registrales. T 3166, L 3166, F 220, S 8, H PO 27709, I/A 23 ( 5.12.13).
25 de Julio de 2013Reelecciones. Auditor: CARBALLO FIDALGO MARIA PILAR. Aud.Supl.: GONZALEZ TENORIO PABLO. Datos registrales. T 3064,L 3064, F 220, S 8, H PO 27709, I/A 22 (15.07.13).
11 de Abril de 2012Reducci贸n de capital. Importe reducci贸n: 201.760,00 Euros. Resultante Suscrito: 4.960.020,00 Euros. Reducci贸n de capital.Importe reducci贸n: 190.770,00 Euros. Resultante Suscrito: 4.769.250,00 Euros. Datos registrales. T 3064, L 3064, F 210, S 8, H PO27709, I/A 19 (27.03.12).
Cancelaciones de oficio de nombramientos. Aud.Supl.: DE LA PRADILLA AUDITORES SLP. Nombramientos. Aud.Supl.:GONZALEZ TENORIO PABLO. Reelecciones. Auditor: CARBALLO FIDALGO MARIA PILAR. Datos registrales. T 3064, L 3064, F209, S 8, H PO 27709, I/A 18 (27.03.12).
04 de Abril de 2012Cancelaciones de oficio de nombramientos. Aud.Supl.: DE LA PRADILLA AUDITORES SLP. Auditor: CARBALLO FIDALGOMARIA PILAR. Reelecciones. Auditor: CARBALLO FIDALGO MARIA PILAR. Aud.Supl.: DE LA PRADILLA AUDITORES SLP. Datosregistrales. T 3064, L 3064, F 209, S 8, H PO 27709, I/A 16 (22.03.12).
Reelecciones. Auditor: CARBALLO FIDALGO MARIA PILAR. Aud.Supl.: DE LA PRADILLA AUDITORES SLP. Datos registrales. T3064, L 3064, F 209, S 8, H PO 27709, I/A 17 (22.03.12).
29 de Octubre de 2009Reelecciones. Auditor: CARBALLO FIDALGO MARIA PILAR. Aud.Supl.: DE LA PRADILLA AUDITORES SLP. Datos registrales. T3064, L 3064, F 209, S 8, H PO 27709, I/A 15 (16.10.09).