Actos BORME de Nordikas Sl
30 de Agosto de 2022Ceses/Dimisiones. Consejero: TOMAS TORRES GREGORIO;JUAREZ MELERO GONZALO;SEPULCRE COVES ANTONIOJAVIER;VIVES RODRIGUEZ MIGUEL ANGEL. Presidente: TOMAS TORRES GREGORIO. Secretario: JUAREZ MELERO GONZALO.Con.Delegado: SEPULCRE COVES ANTONIO JAVIER. Nombramientos. Consejero: JUAREZ MELERO GONZALO;HERNANDEZPASTOR MATILDE;SEPULCRE COVES ANTONIO JAVIER;VIVES RODRIGUEZ MIGUEL ANGEL. Presidente: JUAREZ MELEROGONZALO. Secretario: HERNANDEZ PASTOR MATILDE. Con.Delegado: SEPULCRE COVES ANTONIO JAVIER. Datosregistrales. T 4106 , F 201, S 8, H A 13333, I/A 25 (19.08.22).
09 de Octubre de 2020Modificaciones estatutarias. ARTICULO 8潞.- Plazo y retribuci贸n de la Administraci贸n. Datos registrales. T 4106 , F 201, S 8, H A13333, I/A 24 ( 1.10.20).
12 de Marzo de 2018Reelecciones. Auditor: CASAMITJANA E IBORRA AUDITORES SLP. Datos registrales. T 1438 , F 61, S 8, H A 13333, I/A 23 (2.03.18).
04 de Septiembre de 2017Revocaciones. Auditor: MARK AUDITORES SLP. Nombramientos. Auditor: CASAMITJANA E IBORRA AUDITORES SLP. Datosregistrales. T 1438 , F 61, S 8, H A 13333, I/A 22 (25.08.17).
03 de Junio de 2016Reelecciones. Auditor: MARK AUDITORES SLP. Datos registrales. T 1438 , F 61, S 8, H A 13333, I/A 21 (26.05.16).
17 de Febrero de 2016Segregaci贸n. Beneficiarios de la segregaci贸n: NORDIKA'S DISTRIBUCION SL. Datos registrales. T 1438 , F 61, S 8, H A 13333,I/A 20 (10.02.16).
16 de Julio de 2015Nombramientos. Auditor: MARK AUDITORES SLP. Datos registrales. T 1438 , F 61, S 8, H A 13333, I/A 19 ( 9.07.15).
19 de Noviembre de 2014Ampliaci贸n de capital. Capital: 502.020,00 Euros. Resultante Suscrito: 1.102.020,00 Euros. Cambio de objeto social. Lafabricaci贸n y venta de toda clase de calzados. La direcci贸n y gesti贸n de valores representativos de sus fondos propios en sociedades yotras entidades. La prestaci贸n de servicios de administraci贸n y apoyo a las entidades participadas, todo ello por cuenta propia. Elarrendamiento de bienes inmueb. Datos registrales. T 1438 , F 60, S 8, H A 13333, I/A 18 (12.11.14).
06 de Junio de 2013Modificaciones estatutarias. Art铆culo 8潞.- Plazo y retribuci贸n de la administraci贸n. Datos registrales. T 1438 , F 60, S 8, H A 13333,I/A 17 (30.05.13).
22 de Febrero de 2013Modificaciones estatutarias. Art铆culo 8潞.- Plazo y Retribuci贸n de la Administraci贸n. Datos registrales. T 1438 , F 60, S 8, H A13333, I/A 16 (14.02.13).
27 de Junio de 2012Ceses/Dimisiones. Consejero: TOMAS TORRES GREGORIO;JUAREZ MELERO GONZALO;SEPULCRE COVES ANTONIOJAVIER;MARTINEZ PEREZ GERARDO ANTONIO;TOMAS HERNANDEZ IRENE;TOMAS HERNANDEZ RAUL;JUAREZ LOPEZMIGUEL ANGEL;JUAREZ LOPEZ GONZALO;VIVES RODRIGUEZ MIGUEL ANGEL. Presidente: TOMAS TORRES GREGORIO.Secretario: JUAREZ MELERO GONZALO. Con.Delegado: SEPULCRE COVES ANTONIO JAVIER. Nombramientos. Consejero:TOMAS TORRES GREGORIO;JUAREZ MELERO GONZALO;SEPULCRE COVES ANTONIO JAVIER;VIVES RODRIGUEZ MIGUELANGEL. Presidente: TOMAS TORRES GREGORIO. Secretario: JUAREZ MELERO GONZALO. Con.Delegado: SEPULCRE COVESANTONIO JAVIER. Datos registrales. T 1438 , F 60, S 8, H A 13333, I/A 15 (16.06.12).
10 de Junio de 2009Ceses/Dimisiones. Adm. Unico: TOMAS TORRES GREGORIO. Nombramientos. Consejero: TOMAS TORRESGREGORIO;JUAREZ MELERO GONZALO;SEPULCRE COVES ANTONIO JAVIER;MARTINEZ PEREZ GERARDOANTONIO;TOMAS HERNANDEZ IRENE;TOMAS HERNANDEZ RAUL;JUAREZ LOPEZ MIGUEL ANGEL;JUAREZ LOPEZGONZALO;VIVES RODRIGUEZ MIGUEL ANGEL. Presidente: TOMAS TORRES GREGORIO. Secretario: JUAREZ MELEROGONZALO. Con.Delegado: SEPULCRE COVES ANTONIO JAVIER. Apo.Sol.: TOMAS TORRES GREGORIO;JUAREZ MELEROGONZALO. Modificaciones estatutarias. Art铆culo 7潞. Administraci贸n social. Art铆culo 8潞. Plazo y retribuci贸n del cargo deAdministrador. Art铆culo 9潞. R茅gimen del Consejo de Administraci贸n.Cambio del Organo de Administraci贸n: Administrador 煤nico aConsejo de administraci贸n. Datos registrales. T 1438 , F 47, S 8, H A 13333, I/A 14 ( 1.06.09).