Actos BORME de Norprensa Sa
21 de Enero de 2019Sociedad unipersonal. Cambio de identidad del socio 煤nico: PRISAPRINT SL. Datos registrales. T 408 , F 7, S 8, H LU 11393,I/A 26 ( 7.01.19).
23 de Agosto de 2017Revocaciones. Apoderado: GONZALEZ GARCIA ALBERTO;SABOYA MARISCAL CARIDAD;LIZARRAGA BONELLI JUANIGNACIO;JOHNSTON PETER DOUGLAS;CHICHARRO ORTEGA LUIS;CHINCHURRETA BOLLAIN FERNANDO;FRANCIAROMERO ENRIQUE;LORENZO ELVIRA JOSE RAMON;MALAGA COCHELLA JOSE ALFONSO;CHINCHURRETA BOLLAINFERNANDO;GONZALEZ GARCIA ALBERTO;SABOYA MARISCAL CARIDAD;LIZARRAGA BONELLI JUAN IGNACIO;CHICHARROORTEGA LUIS;CHICHARRO ORTEGA LUIS;MARTIN MARTINEZ JOSE MARIANO;FRANCIA ROMERO ENRIQUE;LOZA BOSQUEPEDRO. Datos registrales. T 408 , F 6, S 8, H LU 11393, I/A 25 ( 7.08.17).
21 de Junio de 2017Ceses/Dimisiones. Adm. Unico: DEDALO GRUPO GRAFICO SL. Nombramientos. Adm. Unico: PRISAPRINT SL. Datosregistrales. T 408 , F 6, S 8, H LU 11393, I/A 24 ( 8.06.17).
09 de Mayo de 2017Revocaciones. Apoderado: MARTIN MAGDALENA JORGE. Nombramientos. Apoderado: MARTIN MAGDALENA JORGE. Datosregistrales. T 408 , F 5, S 8, H LU 11393, I/A 22 (28.04.17).
Revocaciones. Apoderado: SOTO PEREZ IGNACIO. Datos registrales. T 408 , F 6, S 8, H LU 11393, I/A 23 (28.04.17).
02 de Junio de 2016Reelecciones. Adm. Unico: DEDALO GRUPO GRAFICO SL. Datos registrales. T 408 , F 5, S 8, H LU 11393, I/A 21 (27.05.16).
26 de Febrero de 2016Nombramientos. Apoderado: SOTO PEREZ IGNACIO. Datos registrales. T 408 , F 4, S 8, H LU 11393, I/A 19 (18.02.16).
Nombramientos. Apoderado: MARTIN MAGDALENA JORGE. Datos registrales. T 408 , F 5, S 8, H LU 11393, I/A 20 (18.02.16).
17 de Diciembre de 2013Reducci贸n de capital. Importe reducci贸n: 1.530.000,00 Euros. Resultante Suscrito: 270.000,00 Euros. Datos registrales. T 408 , F3, S 8, H LU 11393, I/A 17 ( 9.12.13).
07 de Agosto de 2013Revocaciones. Apo.Man.Soli: LOZA BOSQUE PEDRO;ZARAGOZA GARCIA NOEMI. Datos registrales. T 408 , F 3, S 8, H LU11393, I/A 16 (30.07.13).
25 de Octubre de 2012Reelecciones. Auditor: DELOITTE SL. Datos registrales. T 408 , F 3, S 8, H LU 11393, I/A 15 (11.10.12).
20 de Septiembre de 2012Revocaciones. Apoderado: DIEZ FERRERAS RAFAEL. Datos registrales. T 408 , F 3, S 8, H LU 11393, I/A 14 (10.09.12).
22 de Noviembre de 2011Revocaciones. Apo.Man.Soli: RUIZ DELGADO FRANCISCO JAVIER. Datos registrales. T 408 , F 3, S 8, H LU 11393, I/A 13(10.11.11).
26 de Octubre de 2011Reelecciones. Auditor: DELOITTE SL. Datos registrales. T 408 , F 3, S 8, H LU 11393, I/A 12 (13.10.11).
09 de Febrero de 2011Reelecciones. Auditor: DELOITTE SL. Datos registrales. T 408 , F 2, S 8, H LU 11393, I/A 11 (27.01.11).
31 de Mayo de 2010Ceses/Dimisiones. Adm. Unico: MARTIN MARTINEZ JOSE MARIANO. Nombramientos. Adm. Unico: DEDALO GRUPO GRAFICOSL. Datos registrales. T 408 , F 2, S 8, H LU 11393, I/A 9 (19.05.10).
02 de Abril de 2009Ceses/Dimisiones. Adm. Mancom.: MARTIN MARTINEZ JOSE MARIANO;CHINCHURRETA BOLLAIN FERNANDO.Nombramientos. Adm. Unico: MARTIN MARTINEZ JOSE MARIANO. Modificaciones estatutarias. Art铆culo de los estatutos: 19 a22. Administraci贸n y Representacion.-. Refundici贸n de estatutos.. Datos registrales. T 365 , F 68, S 8, H LU 11393, I/A 8 (20.03.09).