Actos BORME de Noster Sl
20 de Octubre de 2021Revocaciones. Apoderado: CAPARROZ ALONSO ANTONIO;CAPARROZ ALONSO ANTONIO;CAPARROZ ALONSO ANTONIO.Datos registrales. T 4321 , F 14, S 8, H SE 23128, I/A 20 (13.10.21).
07 de Octubre de 2016Nombramientos. Apoderado: PIÑEIRO GALLARDO GERMAN. Datos registrales. T 4321 , F 14, S 8, H SE 23128, I/A 19 (30.09.16).
14 de Febrero de 2014Nombramientos. Apo.Sol.: ROMERO REYES JOSE MANUEL;ORTEGA VERDUGO FRANCISCO JAVIER. Datos registrales. T4321 , F 13, S 8, H SE 23128, I/A 18 ( 5.02.14).
04 de Diciembre de 2013Ceses/Dimisiones. Adm. Solid.: JIMENEZ ROMERO FRANCISCO. Nombramientos. Adm. Solid.: JIMENEZ SAN MARTINCARMEN. Datos registrales. T 4321 , F 13, S 8, H SE 23128, I/A 17 (26.11.13).
04 de Mayo de 2011Nombramientos. Apoderado: MUÑOZ OCAÑA MANUEL JESUS. Datos registrales. T 4321 , F 13, S 8, H SE 23128, I/A 16 (8.04.11).
16 de Abril de 2010Otros conceptos: se acepta la RENUNCIA AL CARGO DE AUDITOR de cuentas para el ejercicio 2009, de la entidad "Valle &Asociados Auditores, S.L.P. Datos registrales. T 4321 , F 12, S 8, H SE 23128, I/A 15 ( 6.04.10).
24 de Marzo de 2010Nombramientos. Apo.Sol.: JIMENEZ SAN MARTIN FRANCISCO;JIMENEZ SANMARTIN CARMEN. Datos registrales. T 4321 , F12, S 8, H SE 23128, I/A 14 ( 9.03.10).
18 de Marzo de 2009Nombramientos. Auditor: VALLE & ASOCIADOS AUDITORES SL. Datos registrales. T 2170 , F 85, S 8, H SE 23128, I/A 13 (3.03.09).