Buscador CIF Logo

Actos BORME Nouteme Sa

驴Quieres acceder a la API de EMPRESAS CIF? Obten la informaci贸n de todas las empresas en tiempo real desde tu plataforma.
Ahora con un 25% de DESCUENTO el primer MES. Quiero la API de EMPRESAS

Logo cabecera Nouteme Sa

Actos BORME Nouteme Sa - A60741352

Tenemos registrados 23 Actos BORME del Registro Mercantil de Barcelona para Nouteme Sa con CIF A60741352

馃敊 Perfil de Nouteme Sa
馃洅 Comprar listado completo de Empresas de Barcelona

Actos BORME de Nouteme Sa

24 de Marzo de 2023
Revocaciones. CONSEJERO: ROVIRA NAVARRO ALEIX. PRESIDENTE: ROVIRA NAVARRO ALEIX. CONS.DEL.SOL: ROVIRANAVARRO ALEIX. CONSEJERO: JURADO GALLARDO MARIA DEL CARMEN. SECRETARIO: JURADO GALLARDO MARIA DELCARMEN. CONSEJERO: DURAN DUELT XAVIER;SALAS LOPEZ JOSE LUIS. Otros conceptos: JUZGADO MERCANTIL 1 DEBARCELONA, PROCEDIMIENTO CONCURSO VOLUNTARIO 1022/2021, AUTOS FIRMES DE FECHA 02/02/2022: APERTURAFASE DE LIQUIDACION; Y 20/06/2022 COMPLEMENTADO POR AUTO DE FECHA 15/12/2022: APROBACION PLAN DELIQUIDACION. Disoluci贸n. Judicial. Datos registrales. T 46455 , F 82, S 8, H B 129848, I/A 32 (16.03.23).

Otros conceptos: JUZGADO DE LO MERCANTIL NUMERO 1 DE BARCELONA, PROCEDIMIENTO CONCURSO VOLUNTARIO1022/2021, AUTO FIRME DE FECHA 21/02/2023, POR EL QUE SE ACUERDA EL ARCHIVO DE LA PIEZA DE CALIFICACION DELA SOCIEDAD. Datos registrales. T 46455 , F 83, S 8, H B 129848, I/A 33 (16.03.23).

25 de Enero de 2022
Nombramientos. ADM.CONCURS.: DE SOLER ALEGRET PABLO. Otros conceptos: JUZGADO DE LO MERCANTIL NUMERO 1DE BARCELONA, PROCEDIMIENTO ABREVIADO DE CONCURSO VOLUNTARIO 1022/2021, AUTO FIRME DE FECHA 04/11/2021,DECLARACION DE CONCURSO VOLUNTARIO DE LA SOCIEDAD. Datos registrales. T 46455 , F 82, S 8, H B 129848, I/A 31(18.01.22).

08 de Junio de 2021
Revocaciones. CONSEJERO: FERNANDEZ BRETONES ALFREDO. Nombramientos. CONSEJERO: ROVIRA NAVARRO ALEIX.PRESIDENTE: ROVIRA NAVARRO ALEIX. CONS.DEL.SOL: ROVIRA NAVARRO ALEIX. CONSEJERO: JURADO GALLARDOMARIA DEL CARMEN. SECRETARIO: JURADO GALLARDO MARIA DEL CARMEN. CONSEJERO: DURAN DUELT XAVIER;SALAS

29 de Julio de 2019
Fe de erratas: En el BORME no.120/2018 y con referencia 264587 y 264590 SE OMITIO EN SU DIA LA PUBLICACION DEL ACTODE REVOCACION DE ALFREDO FERNANDEZ BRETONES COMO PRESIDENTE Y CONSEJERO DELEGADO. Datos registrales.T 35340 , F 108, S 8, H B 129848, I/A 23 ( 2.06.16).

16 de Julio de 2019
Revocaciones. SECRETARIO: FERNANDEZ BRETONES ALFREDO. Nombramientos. SECRETARIO: JURADO GALLARDOMARIA DEL CARMEN. CONSEJERO: JURADO GALLARDO MARIA DEL CARMEN. Datos registrales. T 46455 , F 81, S 8, H B129848, I/A 29 ( 5.07.19).

04 de Julio de 2018
Nombramientos. APODERAD.SOL: FERNANDEZ BRETONES ALFREDO. Datos registrales. T 35340 , F 109, S 8, H B 129848, I/A27 (27.06.18).

Revocaciones. APODERAD.SOL: FERNANDEZ BRETONES ALFREDO. Datos registrales. T 46455 , F 81, S 8, H B 129848, I/A 28(27.06.18).

25 de Junio de 2018
Fe de erratas: En el BORME no.110/2016 y con referencia 246553 SE OMITIO EN SU DIA LA PUBLICACION DEL ACTO DEREVOCACION DE DON ALEIX ROVIRA NAVARRO, COMO SECRETARIO. Datos registrales. T 35340 , F 108, S 8, H B 129848, I/A23 ( 2.06.16).

Revocaciones. SECRETARIO: ROVIRA NAVARRO ALEIX. Datos registrales. T 35340 , F 108, S 8, H B 129848, I/A 23 ( 2.06.16).

16 de Abril de 2018
Revocaciones. APODERADO: GRANJA PEREZ ALBERTO;FERNANDEZ BRETONES ALFREDO. Datos registrales. T 35340 , F109, S 8, H B 129848, I/A 26 ( 5.04.18).

12 de Julio de 2017
Nombramientos. GERENTE: DURAN DUELT JAVIER. Datos registrales. T 35340 , F 108, S 8, H B 129848, I/A 25 ( 4.07.17).

24 de Mayo de 2017
Nombramientos. CONSEJERO: DURAN DUELT JAVIER. Datos registrales. T 35340 , F 108, S 8, H B 129848, I/A 24 (12.05.17).

10 de Junio de 2016
Nombramientos. CONSEJERO: FERNANDEZ BRETONES ALFREDO. SECRETARIO: FERNANDEZ BRETONES ALFREDO.CONSEJERO: ROVIRA NAVARRO ALEIX. PRESIDENTE: ROVIRA NAVARRO ALEIX. CONS. DELEG.: ROVIRA NAVARRO ALEIX.CONSEJERO: SALAS LOPEZ JOSE LUIS. Cambio de domicilio social. CL RAMON MARTI ALSINA NUMEROS 40-42 BAJOS(BADALONA). Datos registrales. T 35340 , F 108, S 8, H B 129848, I/A 23 ( 2.06.16).

08 de Enero de 2016
Reducci贸n de capital. Importe reducci贸n: 71.280,00 Euros. Resultante Suscrito: 290.220,00 Euros. Datos registrales. T 35340 , F107, S 8, H B 129848, I/A 22 (30.12.15).

23 de Enero de 2015
Revocaciones. CONSEJERO: GONZALEZ GARCIA DOLORES. SECRETARIO: GONZALEZ GARCIA DOLORES. CONSEJERO:PASTOR MIQUELEZ ANTONIO. Nombramientos. CONSEJERO: ROVIRA NAVARRO ALEIX. SECRETARIO: ROVIRA NAVARROALEIX. CONSEJERO: SALAS LOPEZ JOSE LUIS. Datos registrales. T 35340 , F 107, S 8, H B 129848, I/A 21 (15.01.15).

11 de Agosto de 2014
Revocaciones. CONSEJERO: SALVADOR MARTIN JAIME. Datos registrales. T 35340 , F 107, S 8, H B 129848, I/A 20 ( 1.08.14).

28 de Mayo de 2014
Reducci贸n de capital. Importe reducci贸n: 117.120,00 Euros. Resultante Suscrito: 361.500,00 Euros. Datos registrales. T 35340 , F106, S 8, H B 129848, I/A 19 (21.05.14).

20 de Enero de 2014
Revocaciones. CONSEJERO: MACIA FORNES MIGUEL. Datos registrales. T 35340 , F 106, S 8, H B 129848, I/A 18 (13.01.14).

29 de Octubre de 2013
P谩gina web de la sociedad. Creaci贸n de la p谩gina web corporativa: www.nouteme.com. Datos registrales. T 35340 , F 106, S 8, HB 129848, I/A 17 (22.10.13).

01 de Octubre de 2012
Revocaciones. CONSEJERO: RODRIGUEZ GIL JOSE. VICEPRESIDEN: RODRIGUEZ GIL JOSE. Datos registrales. T 35340 , F106, S 8, H B 129848, I/A 16 (20.09.12).

01 de Junio de 2011
Revocaciones. CONSEJERO: FERNANDEZ BRETONES ALFREDO. PRESIDENTE: FERNANDEZ BRETONES ALFREDO. CONS.DELEG.: FERNANDEZ BRETONES ALFREDO. CONSEJERO: RODRIGUEZ GIL JOSE. VICEPRESIDEN: RODRIGUEZ GIL JOSE.CONSEJERO: SIBILA RAMIREZ JUAN. SECRETARIO: SIBILA RAMIREZ JUAN. CONSEJERO: SALVADOR MARTINJAIME;PASTOR MIQUELEZ ANTONIO;MACIA FORNES MIGUEL. Nombramientos. CONSEJERO: FERNANDEZ BRETONESALFREDO. PRESIDENTE: FERNANDEZ BRETONES ALFREDO. CONS. DELEG.: FERNANDEZ BRETONES ALFREDO.CONSEJERO: RODRIGUEZ GIL JOSE. VICEPRESIDEN: RODRIGUEZ GIL JOSE. CONSEJERO: GONZALEZ GARCIA DOLORES.SECRETARIO: GONZALEZ GARCIA DOLORES. CONSEJERO: SALVADOR MARTIN JAIME;PASTOR MIQUELEZ ANTONIO;MACIAFORNES MIGUEL. Datos registrales. T 35340 , F 104, S 8, H B 129848, I/A 15 (20.05.11).

27 de Agosto de 2009
Revocaciones. CONSEJERO: SUGRA脩ES CASTELLSAGUE JAIME. VICESECRET.: SUGRA脩ES CASTELLSAGUE JAIME. Datosregistrales. T 35340 , F 104, S 8, H B 129848, I/A 14 (17.08.09).

Utilizamos cookies de terceros con finalidades anal铆ticas, de personalizaci贸n, y de publicidad comportamental. Puede configurar ahora el uso de esta tecnolog铆a. Si acepta o contin煤a navegando, consideramos que est谩 de acuerdo con su uso. Mas informaci贸n