Buscador CIF Logo

Actos BORME Novo Vanguarda Sl

驴Quieres acceder a la API de EMPRESAS CIF? Obten la informaci贸n de todas las empresas en tiempo real desde tu plataforma.
Ahora con un 25% de DESCUENTO el primer MES. Quiero la API de EMPRESAS

Logo cabecera Novo Vanguarda Sl

Actos BORME Novo Vanguarda Sl - B86313954

Tenemos registrados 25 Actos BORME del Registro Mercantil de Madrid para Novo Vanguarda Sl con CIF B86313954

馃敊 Perfil de Novo Vanguarda Sl
馃洅 Comprar listado completo de Empresas de Madrid

Actos BORME de Novo Vanguarda Sl

23 de Noviembre de 2021
Ceses/Dimisiones. Adm. Mancom.: CABRANES AZCONA JORGE;PEREIRA DIAS REBELO CARLA SOFIA. Nombramientos.Liquidador M: PEREIRAS DIAS REBELO CARLA SOFIA;CABRANES AZCONA JORGE. Disoluci贸n. Voluntaria. Extinci贸n. Datosregistrales. T 40240 , F 40, S 8, H M 527773, I/A 32 (16.11.21).

02 de Agosto de 2021
Revocaciones. Apoderado: JUAN Y SEVA MAGANTO LUIS. Apo.Manc.: Y SEVA MAGANTO LUIS JUAN;Y SEVA MAGANTO LUISJUAN. Apo.Sol.: Y SEVA MAGANTO LUIS JUAN. Apo.Manc.: JUAN Y SEVA MAGANTO LUIS. Datos registrales. T 40240 , F 40, S8, H M 527773, I/A 31 (26.07.21).

29 de Octubre de 2020
Ceses/Dimisiones. Adm. Mancom.: LIMA DE CARVALHO MOURA VALENCA PINTO LUIS TIAGO. Nombramientos. Adm.Mancom.: PEREIRA DIAS REBELO CARLA SOFIA. Datos registrales. T 40240 , F 40, S 8, H M 527773, I/A 29 (22.10.20).

Nombramientos. Apoderado: PEREIRA DIAS REBELO CARLA SOFIA. Datos registrales. T 40240 , F 40, S 8, H M 527773, I/A 30(22.10.20).

13 de Marzo de 2020
Revocaciones. Apo.Sol.: POMBO LANZA FRANCISCO;CUESTA GALVEZ ANTONIO. Datos registrales. T 29320 , F 14, S 8, H M527773, I/A 28 ( 6.03.20).

21 de Octubre de 2019
Nombramientos. Apo.Manc.: JUAN Y SEVA MAGANTO LUIS;LIMA DE CARVALHO MOURA VALENCA PINTO LUIS TIAGO. Datosregistrales. T 29320 , F 14, S 8, H M 527773, I/A 27 (14.10.19).

01 de Agosto de 2019
Nombramientos. Apoderado: LIMA DE CARVALHO MOURA VALENCA PINTO LUIS TIAGO. Datos registrales. T 29320 , F 14, S 8,H M 527773, I/A 26 (25.07.19).

25 de Junio de 2019
Ceses/Dimisiones. Adm. Mancom.: DE OLIVEIRA GUTERRES ARTUR. Nombramientos. Adm. Mancom.: LIMA DE CARVALHOMOURA VALENCA PINTO LUIS TIAGO. Datos registrales. T 29320 , F 13, S 8, H M 527773, I/A 24 (18.06.19).

Revocaciones. Apoderado: DE OLIVEIRA GUTERRES ARTUR. Datos registrales. T 29320 , F 14, S 8, H M 527773, I/A 25(19.06.19).

21 de Junio de 2019
Cambio de domicilio social. C/ PRINCIPE DE VERGARA 112 - 8潞 (MADRID). Datos registrales. T 29320 , F 13, S 8, H M 527773,I/A 23 (14.06.19).

22 de Junio de 2018
Nombramientos. Apo.Manc.: Y SEVA MAGANTO LUIS JUAN;CABRANES AZCONA JORGE;DE OLIVEIRA GUTERRES ARTUR;YSEVA MAGANTO LUIS JUAN. Apo.Sol.: Y SEVA MAGANTO LUIS JUAN. Datos registrales. T 29320 , F 12, S 8, H M 527773, I/A 22(13.06.18).

12 de Junio de 2018
Nombramientos. Apo.Man.Soli: RATA LOPEZ MARIA LUISA;TORRES RUBIO MARIA. Datos registrales. T 29320 , F 11, S 8, H M527773, I/A 21 ( 5.06.18).

24 de Enero de 2017
Ceses/Dimisiones. Adm. Mancom.: ROMANOS SERRANO CESAR. Datos registrales. T 29320 , F 11, S 8, H M 527773, I/A 20(17.01.17).

16 de Enero de 2017
Nombramientos. Apoderado: JUAN Y SEVA MAGANTO LUIS. Datos registrales. T 29320 , F 10, S 8, H M 527773, I/A 19 (4.01.17).

15 de Noviembre de 2016
Nombramientos. Apo.Manc.: MADOLELL ORTEGA FRANCISCO;LANCHARES URIA LUIS. Datos registrales. T 29320 , F 9, S 8, HM 527773, I/A 18 ( 4.11.16).

22 de Junio de 2016
Revocaciones. Apoderado: ROMANOS SERRANO CESAR. Datos registrales. T 29320 , F 9, S 8, H M 527773, I/A 17 (14.06.16).

20 de Junio de 2016
Nombramientos. Apoderado: DE OLIVEIRA GUTERRES ARTUR. Datos registrales. T 29320 , F 9, S 8, H M 527773, I/A 16(10.06.16).

27 de Abril de 2016
Nombramientos. Apo.Sol.: RATA LOPEZ MARIA LUISA. Datos registrales. T 29320 , F 9, S 8, H M 527773, I/A 14 (19.04.16).

Revocaciones. Apo.Sol.: ANDRADAS MARTIN DE LOECHES MONICA. Datos registrales. T 29320 , F 9, S 8, H M 527773, I/A 15(19.04.16).

21 de Marzo de 2016
Nombramientos. Apo.Sol.: CUESTA GALVEZ ANTONIO. Datos registrales. T 29320 , F 8, S 8, H M 527773, I/A 13 (14.03.16).

11 de Marzo de 2016
Ceses/Dimisiones. Adm. Mancom.: SANTOS GARCIA JOSE LUIS. Nombramientos. Adm. Mancom.: CABRANES AZCONAJORGE. Datos registrales. T 29320 , F 8, S 8, H M 527773, I/A 12 ( 4.03.16).

06 de Mayo de 2015
Nombramientos. Apoderado: JUAN Y SEVA MAGANTO LUIS. Datos registrales. T 29320 , F 8, S 8, H M 527773, I/A 11 (27.04.15).

16 de Marzo de 2015
Ceses/Dimisiones. Adm. Mancom.: IGLESIAS ARAUZO IGNACIO. Nombramientos. Adm. Mancom.: DE OLIVEIRA GUTERRESARTUR. Datos registrales. T 29320 , F 8, S 8, H M 527773, I/A 10 ( 6.03.15).

30 de Enero de 2015
Nombramientos. Auditor: PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES SL. Datos registrales. T 29320 , F 7, S 8, H M 527773,

26 de Diciembre de 2014
Revocaciones. Apoderado: IGLESIAS ARAUZO IGNACIO. Nombramientos. Apoderado: ROMANOS SERRANO CESAR. Datosregistrales. T 29320 , F 7, S 8, H M 527773, I/A 8 (18.12.14).

Utilizamos cookies de terceros con finalidades anal铆ticas, de personalizaci贸n, y de publicidad comportamental. Puede configurar ahora el uso de esta tecnolog铆a. Si acepta o contin煤a navegando, consideramos que est谩 de acuerdo con su uso. Mas informaci贸n