Actos BORME de Novocargo Zaragoza Sa
28 de Diciembre de 2022Otros conceptos: CERRADA LA HOJA POR PLAZO PROVISIONAL DE 6 MESES, CONFORME AL ARTICULO 231 RRM. Datosregistrales. T 4275 , F 51, S 8, H Z 10826, I/A 27 N (21.12.22).
27 de Enero de 2020Ceses/Dimisiones. Consejero: CAMPOS PRIVAT GLORIA;MARTIN RIAZA JUAN ANTONIO;CAMPOS MARTINEZ SANTIAGO.Presidente: CAMPOS MARTINEZ SANTIAGO. Secretario: MARTIN RIAZA JUAN ANTONIO. Con.Delegado: CAMPOS MARTINEZSANTIAGO. Consejero: CONTRERAS PABLOS JOAQUIN. Nombramientos. Adm. Solid.: CONTRERAS PABLOSJOAQUIN;CAMPOS PRIVAT GLORIA. Otros conceptos: Cambio del Organo de Administraci贸n: Consejo de administraci贸n aAdministradores solidarios. Modificados los art铆culos 10, 11潞 y 13陋 y eliminado el art铆culo 12潞 de los estatutos sociales. Datosregistrales. T 4275 , F 51, S 8, H Z 10826, I/A 27 (20.01.20).
20 de Marzo de 2018Nombramientos. Apoderado: CONTRERAS PABLOS JOAQUIN. Datos registrales. T 1483 , F 60, S 8, H Z 10826, I/A 26(14.03.18).
25 de Mayo de 2017Sociedad unipersonal. Cambio de identidad del socio 煤nico: SURE脩A DE TRANSITOS SL. Datos registrales. T 1483 , F 60, S8, H Z 10826, I/A 24 (17.05.17).
Ceses/Dimisiones. Consejero: BORRELL PAMIES SALVADOR. Revocaciones. Apoderado: MORALES GONZALEZ LUIS. Datosregistrales. T 1483 , F 60, S 8, H Z 10826, I/A 25 (17.05.17).
26 de Agosto de 2016Nombramientos. Consejero: CONTRERAS PABLOS JOAQUIN. Datos registrales. T 1483 , F 60, S 8, H Z 10826, I/A 23 (17.08.16).
01 de Diciembre de 2014Nombramientos. Consejero: CAMPOS PRIVAT GLORIA. Reelecciones. Consejero: BORRELL PAMIES SALVADOR;MARTINRIAZA JUAN ANTONIO;CAMPOS MARTINEZ SANTIAGO. Presidente: CAMPOS MARTINEZ SANTIAGO. Secretario: MARTIN RIAZAJUAN ANTONIO. Con.Delegado: CAMPOS MARTINEZ SANTIAGO. Datos registrales. T 1483 , F 60, S 8, H Z 10826, I/A 22(24.11.14).
29 de Abril de 2014Nombramientos. Apoderado: CAMPOS PRIVAT GLORIA. Datos registrales. T 1483 , F 59, S 8, H Z 10826, I/A 21 (21.04.14).
17 de Enero de 2014Declaraci贸n de unipersonalidad. Socio 煤nico: NOVOCARGO SA. Reducci贸n de capital. Importe reducci贸n: 60.200,00 Euros.Resultante Suscrito: 0,00 Euros. Ampliaci贸n de capital. Suscrito: 70.000,00 Euros. Desembolsado: 70.000,00 Euros. ResultanteSuscrito: 70.000,00 Euros. Resultante Desembolsado: 70.000,00 Euros. Datos registrales. T 1483 , F 59, S 8, H Z 10826, I/A 20 (8.01.14).
24 de Junio de 2013Reelecciones. Consejero: BORRELL PAMIES SALVADOR;MARTIN RIAZA JUAN ANTONIO;CAMPOS MARTINEZ SANTIAGO.Presidente: CAMPOS MARTINEZ SANTIAGO. Secretario: MARTIN RIAZA JUAN ANTONIO. Con.Delegado: CAMPOS MARTINEZSANTIAGO. Datos registrales. T 1483 , F 59, S 8, H Z 10826, I/A 19 (14.06.13).
14 de Junio de 2013Nombramientos. Auditor: ALVAREZ FERNANDEZ CARLOS. Datos registrales. T 1483 , F 58, S 8, H Z 10826, I/A 18 ( 5.06.13).
13 de Junio de 2012Ceses/Dimisiones. Consejero: MARTIN GONZALEZ EDUARDO. Datos registrales. T 1483 , F 58, S 8, H Z 10826, I/A 17 ( 1.06.12).
07 de Junio de 2012Revocaciones. Apoderado: MARTIN ARIZA FELIX. D. Gerente: MARTIN ARIZA FELIX. Datos registrales. T 1483 , F 58, S 8, H Z10826, I/A 16 (29.05.12).
21 de Mayo de 2012Nombramientos. Auditor: IBERAUDIT AUDITORES ARAGON SLP. Datos registrales. T 1483 , F 58, S 8, H Z 10826, I/A 15 (8.05.12).
12 de Marzo de 2012Nombramientos. Apoderado: CONTRERAS PABLOS JOAQUIN. Datos registrales. T 1483 , F 58, S 8, H Z 10826, I/A 14(28.02.12).
06 de Marzo de 2012Revocaciones. Apoderado: MARTIN GONZALEZ EDUARDO. Datos registrales. T 1483 , F 58, S 8, H Z 10826, I/A 13 (22.02.12).