Actos BORME de Novovilla Sl
07 de Agosto de 2017Disoluci贸n. Fusion. Extinci贸n. Datos registrales. T 17889 , F 180, S 8, H M 30934, I/A 127 (31.07.17).
15 de Febrero de 2016Revocaciones. Apo.Man.Soli: LOPEZ MOLINILLO JOSE LUIS. Datos registrales. T 17889 , F 179, S 8, H M 30934, I/A 124 (8.02.16).
Nombramientos. Apoderado: CARRION HERNANDEZ JOSE LUIS. Datos registrales. T 17889 , F 179, S 8, H M 30934, I/A 125 (8.02.16).
Nombramientos. Apoderado: MATA ARBIDE ALEJANDRO. Datos registrales. T 17889 , F 180, S 8, H M 30934, I/A 126 ( 8.02.16).
16 de Diciembre de 2015Revocaciones. Apo.Man.Soli: ZORNOZA SOTO JOSE. Datos registrales. T 17889 , F 179, S 8, H M 30934, I/A 123 ( 4.12.15).
05 de Mayo de 2015Nombramientos. Apoderado: GARCIA ARANGO PAULA. Datos registrales. T 17889 , F 178, S 8, H M 30934, I/A 122 (24.04.15).
28 de Abril de 2014Nombramientos. Apoderado: ALDAMIZ-ECHEVARRIA GONZALEZ DE DURANA CRISTINA. Datos registrales. T 17889 , F 177, S8, H M 30934, I/A 121 (15.04.14).
25 de Enero de 2011Nombramientos. Apoderado: DEL VALLE PEREZ JOSE LUIS. Datos registrales. T 17889 , F 176, S 8, H M 30934, I/A 120(13.01.11).
30 de Julio de 2009Reelecciones. Adm. Unico: ACS ACTIVIDADES DE CONSTRUCCION Y SERVICIOS SA. Representan: GARCIA ALTOZANOANGEL. Datos registrales. T 17889 , F 176, S 8, H M 30934, I/A 119 (16.07.09).