Buscador CIF Logo

Actos BORME Nuevos Materiales De Construccion Sa

驴Quieres acceder a la API de EMPRESAS CIF? Obten la informaci贸n de todas las empresas en tiempo real desde tu plataforma.
Ahora con un 25% de DESCUENTO el primer MES. Quiero la API de EMPRESAS

Logo cabecera Nuevos Materiales De Construccion Sa

Actos BORME Nuevos Materiales De Construccion Sa - A28022168

Tenemos registrados 19 Actos BORME del Registro Mercantil de Madrid para Nuevos Materiales De Construccion Sa con CIF A28022168

馃敊 Perfil de Nuevos Materiales De Construccion Sa
馃洅 Comprar listado completo de Empresas de Madrid

Actos BORME de Nuevos Materiales De Construccion Sa

01 de Abril de 2022
Situaci贸n concursal. Procedimiento concursal 580/2011. FIRME: Si, Fecha de resoluci贸n 18/02/2022. Auto de conclusi贸n delconcurso. Finalizacion de la fase de liquidacion. Juzgado: num. 0 JUZGADO DE LO MERCANTIL NUMERO 11 DE MADRID. Juez:DON MANUEL RUIZ DE LARA. Extinci贸n. Datos registrales. T 28802 , F 216, S 8, H M 97786, I/A 45 (25.03.22).

13 de Noviembre de 2013
Situaci贸n concursal. Procedimiento concursal 580/2011. FIRME: No, Fecha de resoluci贸n 17/10/2013. Auto de declaraci贸n deconcurso. Necesario. Juzgado: num. 11 JUZGADO DE LO MERCANTIL. Juez: OLGA MARTIN ALONSO. Resoluciones:DECLARACION DEL CONCURSO DE ACREEDORES CON EL CARACTER DE NECESARIO, POR EL PROCEDIMIENTOORDINARIO, SUSPENDIDAS LAS FACULTADES DE ADMINISTRACION Y, NOMBRAMIENTO DE ADMINISTRADOR CONCURSAL.Situaci贸n concursal. Procedimiento concursal 580/2011. Fecha de resoluci贸n 17/10/2013. Nombramiento de administradores.Juzgado: num. 11 JUZGADO DE LO MERCANTIL. Juez: OLGA MARTIN ALONSO. Administrador Concursal. Fecha 17/10/2013,NIF/CIF 7212861S. ALEMANY POZUELO DOLORES. Datos registrales. T 28802 , F 214, S 8, H M 97786, I/A A ( 6.11.13).

09 de Enero de 2013
Ceses/Dimisiones. SecreNoConsj: SERRANO NAVARRO FERNANDO ANTONIO. Nombramientos. Secretario: SANCHEZTORREJON GUILLERMO. Datos registrales. T 28802 , F 214, S 8, H M 97786, I/A 44 (28.12.12).

27 de Diciembre de 2012
Nombramientos. Auditor: ACR AUDITORS GROUP SLP. Datos registrales. T 28802 , F 214, S 8, H M 97786, I/A 43 (19.12.12).

27 de Febrero de 2012
Ceses/Dimisiones. Consejero: IBERCAJA PARTICIPACIONES EMPRESARIALES SA. Representan: VICENTE PALOMAR ELENA.Datos registrales. T 28802 , F 214, S 8, H M 97786, I/A 41 (15.02.12).

Ceses/Dimisiones. Consejero: CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE ZARAGOZA ARAG. Representan: ROMERAREGA脩O DAVID. Datos registrales. T 28802 , F 214, S 8, H M 97786, I/A 42 (15.02.12).

28 de Noviembre de 2011
Ceses/Dimisiones. SecreNoConsj: GARCIA MORENO ANGEL. Nombramientos. SecreNoConsj: SERRANO NAVARROFERNANDO ANTONIO. Consejero: ASIN TEROL ENRIQUE;PETRIRENA HERNANDEZ JAVIER IGNACIO. M.Com.Ejec:VILLUENDAS SANTAMARIA ANTONIO ANGEL;ASIN TEROL ENRIQUE;PETRIRENA HERNANDEZ JAVIER IGNACIO. Datosregistrales. T 28802 , F 213, S 8, H M 97786, I/A 40 (15.11.11).

28 de Octubre de 2011
Ceses/Dimisiones. Consejero: PORTOBELLO BETA SL. Representan: RAMIREZ BELAUSTEGUI JUAN LUIS. Datos registrales. T28802 , F 212, S 8, H M 97786, I/A 38 (13.10.11).

Ceses/Dimisiones. Consejero: PORTOBELLO ALFA SL. Representan: RAMIREZ BELAUSTEGUI JUAN LUIS. Datos registrales. T28802 , F 212, S 8, H M 97786, I/A 39 (13.10.11).

28 de Septiembre de 2011
Nombramientos. Auditor: CARVAJAL GOMEZ-CANO BELEN. Datos registrales. T 28802 , F 212, S 8, H M 97786, I/A 37(15.09.11).

20 de Septiembre de 2011
Ceses/Dimisiones. SecreNoConsj: RAMIREZ BELAUSTEGUI JUAN LUIS. Nombramientos. SecreNoConsj: GARCIA MORENOANGEL. Datos registrales. T 18725 , F 9, S 8, H M 97786, I/A 34 ( 3.09.11).

Revocaciones. Apoderado: VILLUENDAS SANTAMARIA ANTONIO ANGEL;VILLUENDAS SANTAMARIA ANTONIO ANGEL. Datosregistrales. T 28802 , F 211, S 8, H M 97786, I/A 35 ( 3.09.11).

Nombramientos. Apoderado: ASIN TEROL ENRIQUE;PETRIRENA HERNANDEZ JAVIER IGNACIO. Datos registrales. T 28802 , F211, S 8, H M 97786, I/A 36 ( 3.09.11).

19 de Septiembre de 2011
Ceses/Dimisiones. Consejero: LOGISTICA DEL EMBALAJE SL. Representan: ARTIGAS VILLUENDAS EVA. Datos registrales. T18725 , F 9, S 8, H M 97786, I/A 33 ( 3.09.11).

25 de Abril de 2011
Ceses/Dimisiones. Consejero: IBERSUIZAS GESTION ALFA SL;IBERSUIZAS GESTION GAMMA SL. Representan: URQUIZUECHEVERRIA JOSE ANTONIO. Secretario: GIL CASARES GASSET ANDRES. Representan: CANOVAS NIELLA RAUL.Nombramientos. SecreNoConsj: RAMIREZ BELAUSTEGUI JUAN LUIS. Consejero: PORTOBELLO ALFA SL;PORTOBELLO BETASL. Representan: RAMIREZ BELAUSTEGUI JUAN LUIS;RAMIREZ BELAUSTEGUI JUAN LUIS. Datos registrales. T 18725 , F 8, S8, H M 97786, I/A 32 ( 7.04.11).

29 de Diciembre de 2010
Ceses/Dimisiones. Representan: RAMIREZ BELAUSTEGUI JUAN LUIS. Nombramientos. Representan: URQUIZU ECHEVERRIAJOSE ANTONIO. Datos registrales. T 18725 , F 8, S 8, H M 97786, I/A 31 (16.12.10).

19 de Abril de 2010
Reelecciones. Auditor: ERNST & YOUNG SL. Datos registrales. T 18725 , F 8, S 8, H M 97786, I/A 30 ( 5.04.10).

26 de Febrero de 2010
Reelecciones. Auditor: ERNST & YOUNG SL. Datos registrales. T 18725 , F 8, S 8, H M 97786, I/A 29 (16.02.10).

09 de Febrero de 2009
Ceses/Dimisiones. Consejero: ARYVI PATRIMONIOS SL. Representan: ARTIGAS VILLUENDAS EVA. Nombramientos.Consejero: LOGISTICA DEL EMBALAJE SL. Representan: ARTIGAS VILLUENDAS EVA. Datos registrales. T 18725 , F 7, S 8, H M97786, I/A 28 (28.01.09).

Utilizamos cookies de terceros con finalidades anal铆ticas, de personalizaci贸n, y de publicidad comportamental. Puede configurar ahora el uso de esta tecnolog铆a. Si acepta o contin煤a navegando, consideramos que est谩 de acuerdo con su uso. Mas informaci贸n