Actos BORME de Nuinsa Inversiones Sl
15 de Diciembre de 2023Nombramientos. Apoderado: MU脩OZ PEREZ CHRISTELLE. Datos registrales. T 41785 , F 163, S 8, H M 672790, I/A 23 (7.12.23).
Nombramientos. Apo.Man.Soli: ARGUELLES DE BUSTILLO JOSE MARIA;MURILLO DE TORRES GONZALO MARIA;MARTINEZBLAZQUEZ MIGUEL ANGEL;RUEDA LLAMAS ALVARO. Datos registrales. T 41785 , F 163, S 8, H M 672790, I/A 24 ( 7.12.23).
11 de Diciembre de 2023Ceses/Dimisiones. Adm. Mancom.: MARTINEZ RODRIGUEZ RAMON. Datos registrales. T 41785 , F 162, S 8, H M 672790, I/A 18(30.11.23).
Nombramientos. Adm. Mancom.: ARGUELLES DE BUSTILLO JOSE MARIA. Datos registrales. T 41785 , F 162, S 8, H M 672790,I/A 19 (30.11.23).
Revocaciones. Apoderado: MARTINEZ RODRIGUEZ RAMON. Datos registrales. T 41785 , F 162, S 8, H M 672790, I/A 20(30.11.23).
Revocaciones. Apoderado: MU脩OZ PEREZ CHRISTELLE. Datos registrales. T 41785 , F 162, S 8, H M 672790, I/A 21 (30.11.23).
Revocaciones. Apoderado: MARTINEZ RODRIGUEZ RAMON;MURILLO DE TORRES GONZALO;MARTINEZ BLAZQUEZ MIGUELANGEL;RUEDA LLAMAS ALVARO. Datos registrales. T 41785 , F 163, S 8, H M 672790, I/A 22 (30.11.23).
15 de Noviembre de 2023Revocaciones. Apoderado: MARTINEZ RODRIGUEZ RAMON. Datos registrales. T 41785 , F 161, S 8, H M 672790, I/A 16 (7.11.23).
Nombramientos. Apoderado: MARTINEZ RODRIGUEZ RAMON. Datos registrales. T 41785 , F 161, S 8, H M 672790, I/A 17 (7.11.23).
11 de Octubre de 2023Nombramientos. Apoderado: MU脩OZ PEREZ CHRISTELLE. Datos registrales. T 41785 , F 161, S 8, H M 672790, I/A 15 (4.10.23).
23 de Mayo de 2022Revocaciones. Apoderado: PROVENCIO GARCIA ALBERTO;TRAPERO RODRIGUEZ ALVARO. Datos registrales. T 41785 , F160, S 8, H M 672790, I/A 14 (13.05.22).
12 de Noviembre de 2021Ceses/Dimisiones. Consejero: PROVENCIO GARCIA ALBERTO;MARTINEZ RODRIGUEZ RAMON. Presidente: PROVENCIOGARCIA ALBERTO. Consejero: TRAPERO RODRIGUEZ ALVARO. SecreNoConsj: ACINAS VILLANUEVA JULIO. VsecrNoConsj:AYUSO GONZALEZ IRENE. Nombramientos. Adm. Mancom.: MURILLO DE TORRES GONZALO;KOEHN ROGERIO;MARTINEZRODRIGUEZ RAMON. Otros conceptos: Cambio del Organo de Administraci贸n: Consejo de administraci贸n a Administradoresmancomunados. Datos registrales. T 41785 , F 160, S 8, H M 672790, I/A 13 ( 3.11.21).
12 de Julio de 2021Nombramientos. Apoderado: MURILLO DE TORRES GONZALO. Datos registrales. T 37765 , F 200, S 8, H M 672790, I/A 12 (5.07.21).
28 de Abril de 2021Revocaciones. Apo.Man.Soli: PROVENCIO GARCIA ALBERTO;MARTINEZ RODRIGUEZ RAMON;RUEDA LLAMASALVARO;MINGO VILLALOBOS BERNARDO. Nombramientos. Apoderado: PROVENCIO GARCIA ALBERTO;MARTINEZRODRIGUEZ RAMON;TRAPERO RODRIGUEZ ALVARO;MURILLO DE TORRES GONZALO;MARTINEZ BLAZQUEZ MIGUELANGEL;RUEDA LLAMAS ALVARO. Datos registrales. T 37765 , F 199, S 8, H M 672790, I/A 11 (21.04.21).
14 de Diciembre de 2020Ceses/Dimisiones. Consejero: RUEDA LLAMAS ALVARO. SecreNoConsj: AYUSO GONZALEZ IRENE. VsecrNoConsj: HERASOMARQUEZ ALBERTO. Nombramientos. Consejero: TRAPERO RODRIGUEZ ALVARO. SecreNoConsj: ACINAS VILLANUEVAJULIO. VsecrNoConsj: AYUSO GONZALEZ IRENE. Datos registrales. T 37765 , F 198, S 8, H M 672790, I/A 10 ( 3.12.20).
22 de Mayo de 2020Revocaciones. Apoderado: RUBIO DIAZ DE TUDANCA JOSE LUIS;MURILLO DE TORRES GONZALO;VARELA FERNANDEZSABELA;MINGO VILLALOBOS BERNARDO;MARTINEZ RODRIGUEZ RAMON;MARTINEZ BLAZQUEZ MIGUEL ANGEL.Nombramientos. Apo.Man.Soli: PROVENCIO GARCIA ALBERTO;MARTINEZ RODRIGUEZ RAMON;RUEDA LLAMASALVARO;MINGO VILLALOBOS BERNARDO. Datos registrales. T 37765 , F 197, S 8, H M 672790, I/A 9 (14.05.20).
14 de Mayo de 2020Ceses/Dimisiones. Adm. Unico: RUBIO DIAZ DE TUDANCA JOSE-LUIS. Nombramientos. SecreNoConsj: AYUSO GONZALEZIRENE. VsecrNoConsj: HERASO MARQUEZ ALBERTO. Consejero: PROVENCIO GARCIA ALBERTO;MARTINEZ RODRIGUEZRAMON;RUEDA LLAMAS ALVARO. Presidente: PROVENCIO GARCIA ALBERTO. Otros conceptos: Cambio del Organo deAdministraci贸n: Administrador 煤nico a Consejo de administraci贸n. Datos registrales. T 37765 , F 197, S 8, H M 672790, I/A 8 (7.05.20).
27 de Septiembre de 2019Revocaciones. Apo.Man.Soli: PANS PIERRE JOSE CLAUDE. Apo.Manc.: MURILLO DE TORRES GONZALO;VARELAFERNANDEZ SABELA;MINGO VILLALOBOS BERNARDO;MARTINEZ RODRIGUEZ RAMON. Apoderado: RUBIO DIAZ DETUDANCA JOSE LUIS. Nombramientos. Apoderado: RUBIO DIAZ DE TUDANCA JOSE LUIS;MURILLO DE TORRESGONZALO;VARELA FERNANDEZ SABELA;MINGO VILLALOBOS BERNARDO;MARTINEZ RODRIGUEZ RAMON;MARTINEZBLAZQUEZ MIGUEL ANGEL. Datos registrales. T 37765 , F 196, S 8, H M 672790, I/A 7 (20.09.19).
28 de Marzo de 2019Nombramientos. Apoderado: MARTINEZ RODRIGUEZ RAMON. Datos registrales. T 37765 , F 194, S 8, H M 672790, I/A 5(21.03.19).
Nombramientos. Apo.Man.Soli: PANS PIERRE JOSE CLAUDE. Apo.Manc.: MURILLO DE TORRES GONZALO;VARELAFERNANDEZ SABELA;MINGO VILLALOBOS BERNARDO;MARTINEZ RODRIGUEZ RAMON. Datos registrales. T 37765 , F 195, S8, H M 672790, I/A 6 (21.03.19).
19 de Octubre de 2018Sociedad unipersonal. Cambio de identidad del socio 煤nico: GESTION Y TECNICAS DEL AGUA SA. Cambio de domiciliosocial. C/ ROSARIO DEL PINO 14-16 (MADRID). Datos registrales. T 37765 , F 194, S 8, H M 672790, I/A 4 (11.10.18).
12 de Septiembre de 2018Reducci贸n de capital. Importe reducci贸n: 2.728.093,00 Euros. Resultante Suscrito: 23.832.147,00 Euros. Datos registrales. T37765 , F 193, S 8, H M 672790, I/A 2 ( 4.09.18).
Ceses/Dimisiones. Adm. Unico: SACYR SERVICIOS SA. Representan: ABRIL-MARTORELL HERNANDEZ PABLO.Nombramientos. Adm. Unico: RUBIO DIAZ DE TUDANCA JOSE-LUIS. Datos registrales. T 37765 , F 193, S 8, H M 672790, I/A 3 (5.09.18).
20 de Julio de 2018Constituci贸n. Comienzo de operaciones: 11.06.18. Objeto social: a)-- Los servicios de gesti贸n de activos relacionados con serviciosde abastecimiento de agua y los servicios de operaci贸n mantenimiento de estaciones, plantas, redes e instalaciones generales deabastecimiento y saneamiento de agua. Domicilio: PASEO DE LA CASTELLANA 83-85 (MADRID). Capital: 26.560.240,00 Euros.Declaraci贸n de unipersonalidad. Socio 煤nico: SACYR SERVICIOS SA. Nombramientos. Adm. Unico: SACYR SERVICIOS SA.Datos registrales. T 37765 , F 189, S 8, H M 672790, I/A 1 (13.07.18).