Buscador CIF Logo

Actos BORME Nuinsa Inversiones Sl

驴Quieres acceder a la API de EMPRESAS CIF? Obten la informaci贸n de todas las empresas en tiempo real desde tu plataforma.
Ahora con un 25% de DESCUENTO el primer MES. Quiero la API de EMPRESAS

Logo cabecera Nuinsa Inversiones Sl

Actos BORME Nuinsa Inversiones Sl - B88140843

Tenemos registrados 24 Actos BORME del Registro Mercantil de Madrid para Nuinsa Inversiones Sl con CIF B88140843

馃敊 Perfil de Nuinsa Inversiones Sl
馃洅 Comprar listado completo de Empresas de Madrid

Actos BORME de Nuinsa Inversiones Sl

15 de Diciembre de 2023
Nombramientos. Apoderado: MU脩OZ PEREZ CHRISTELLE. Datos registrales. T 41785 , F 163, S 8, H M 672790, I/A 23 (7.12.23).

Nombramientos. Apo.Man.Soli: ARGUELLES DE BUSTILLO JOSE MARIA;MURILLO DE TORRES GONZALO MARIA;MARTINEZBLAZQUEZ MIGUEL ANGEL;RUEDA LLAMAS ALVARO. Datos registrales. T 41785 , F 163, S 8, H M 672790, I/A 24 ( 7.12.23).

11 de Diciembre de 2023
Ceses/Dimisiones. Adm. Mancom.: MARTINEZ RODRIGUEZ RAMON. Datos registrales. T 41785 , F 162, S 8, H M 672790, I/A 18(30.11.23).

Nombramientos. Adm. Mancom.: ARGUELLES DE BUSTILLO JOSE MARIA. Datos registrales. T 41785 , F 162, S 8, H M 672790,I/A 19 (30.11.23).

Revocaciones. Apoderado: MARTINEZ RODRIGUEZ RAMON. Datos registrales. T 41785 , F 162, S 8, H M 672790, I/A 20(30.11.23).

Revocaciones. Apoderado: MU脩OZ PEREZ CHRISTELLE. Datos registrales. T 41785 , F 162, S 8, H M 672790, I/A 21 (30.11.23).

Revocaciones. Apoderado: MARTINEZ RODRIGUEZ RAMON;MURILLO DE TORRES GONZALO;MARTINEZ BLAZQUEZ MIGUELANGEL;RUEDA LLAMAS ALVARO. Datos registrales. T 41785 , F 163, S 8, H M 672790, I/A 22 (30.11.23).

15 de Noviembre de 2023
Revocaciones. Apoderado: MARTINEZ RODRIGUEZ RAMON. Datos registrales. T 41785 , F 161, S 8, H M 672790, I/A 16 (7.11.23).

Nombramientos. Apoderado: MARTINEZ RODRIGUEZ RAMON. Datos registrales. T 41785 , F 161, S 8, H M 672790, I/A 17 (7.11.23).

11 de Octubre de 2023
Nombramientos. Apoderado: MU脩OZ PEREZ CHRISTELLE. Datos registrales. T 41785 , F 161, S 8, H M 672790, I/A 15 (4.10.23).

23 de Mayo de 2022
Revocaciones. Apoderado: PROVENCIO GARCIA ALBERTO;TRAPERO RODRIGUEZ ALVARO. Datos registrales. T 41785 , F160, S 8, H M 672790, I/A 14 (13.05.22).

12 de Noviembre de 2021
Ceses/Dimisiones. Consejero: PROVENCIO GARCIA ALBERTO;MARTINEZ RODRIGUEZ RAMON. Presidente: PROVENCIOGARCIA ALBERTO. Consejero: TRAPERO RODRIGUEZ ALVARO. SecreNoConsj: ACINAS VILLANUEVA JULIO. VsecrNoConsj:AYUSO GONZALEZ IRENE. Nombramientos. Adm. Mancom.: MURILLO DE TORRES GONZALO;KOEHN ROGERIO;MARTINEZRODRIGUEZ RAMON. Otros conceptos: Cambio del Organo de Administraci贸n: Consejo de administraci贸n a Administradoresmancomunados. Datos registrales. T 41785 , F 160, S 8, H M 672790, I/A 13 ( 3.11.21).

12 de Julio de 2021
Nombramientos. Apoderado: MURILLO DE TORRES GONZALO. Datos registrales. T 37765 , F 200, S 8, H M 672790, I/A 12 (5.07.21).

28 de Abril de 2021
Revocaciones. Apo.Man.Soli: PROVENCIO GARCIA ALBERTO;MARTINEZ RODRIGUEZ RAMON;RUEDA LLAMASALVARO;MINGO VILLALOBOS BERNARDO. Nombramientos. Apoderado: PROVENCIO GARCIA ALBERTO;MARTINEZRODRIGUEZ RAMON;TRAPERO RODRIGUEZ ALVARO;MURILLO DE TORRES GONZALO;MARTINEZ BLAZQUEZ MIGUELANGEL;RUEDA LLAMAS ALVARO. Datos registrales. T 37765 , F 199, S 8, H M 672790, I/A 11 (21.04.21).

14 de Diciembre de 2020
Ceses/Dimisiones. Consejero: RUEDA LLAMAS ALVARO. SecreNoConsj: AYUSO GONZALEZ IRENE. VsecrNoConsj: HERASOMARQUEZ ALBERTO. Nombramientos. Consejero: TRAPERO RODRIGUEZ ALVARO. SecreNoConsj: ACINAS VILLANUEVAJULIO. VsecrNoConsj: AYUSO GONZALEZ IRENE. Datos registrales. T 37765 , F 198, S 8, H M 672790, I/A 10 ( 3.12.20).

22 de Mayo de 2020
Revocaciones. Apoderado: RUBIO DIAZ DE TUDANCA JOSE LUIS;MURILLO DE TORRES GONZALO;VARELA FERNANDEZSABELA;MINGO VILLALOBOS BERNARDO;MARTINEZ RODRIGUEZ RAMON;MARTINEZ BLAZQUEZ MIGUEL ANGEL.Nombramientos. Apo.Man.Soli: PROVENCIO GARCIA ALBERTO;MARTINEZ RODRIGUEZ RAMON;RUEDA LLAMASALVARO;MINGO VILLALOBOS BERNARDO. Datos registrales. T 37765 , F 197, S 8, H M 672790, I/A 9 (14.05.20).

14 de Mayo de 2020
Ceses/Dimisiones. Adm. Unico: RUBIO DIAZ DE TUDANCA JOSE-LUIS. Nombramientos. SecreNoConsj: AYUSO GONZALEZIRENE. VsecrNoConsj: HERASO MARQUEZ ALBERTO. Consejero: PROVENCIO GARCIA ALBERTO;MARTINEZ RODRIGUEZRAMON;RUEDA LLAMAS ALVARO. Presidente: PROVENCIO GARCIA ALBERTO. Otros conceptos: Cambio del Organo deAdministraci贸n: Administrador 煤nico a Consejo de administraci贸n. Datos registrales. T 37765 , F 197, S 8, H M 672790, I/A 8 (7.05.20).

27 de Septiembre de 2019
Revocaciones. Apo.Man.Soli: PANS PIERRE JOSE CLAUDE. Apo.Manc.: MURILLO DE TORRES GONZALO;VARELAFERNANDEZ SABELA;MINGO VILLALOBOS BERNARDO;MARTINEZ RODRIGUEZ RAMON. Apoderado: RUBIO DIAZ DETUDANCA JOSE LUIS. Nombramientos. Apoderado: RUBIO DIAZ DE TUDANCA JOSE LUIS;MURILLO DE TORRESGONZALO;VARELA FERNANDEZ SABELA;MINGO VILLALOBOS BERNARDO;MARTINEZ RODRIGUEZ RAMON;MARTINEZBLAZQUEZ MIGUEL ANGEL. Datos registrales. T 37765 , F 196, S 8, H M 672790, I/A 7 (20.09.19).

28 de Marzo de 2019
Nombramientos. Apoderado: MARTINEZ RODRIGUEZ RAMON. Datos registrales. T 37765 , F 194, S 8, H M 672790, I/A 5(21.03.19).

Nombramientos. Apo.Man.Soli: PANS PIERRE JOSE CLAUDE. Apo.Manc.: MURILLO DE TORRES GONZALO;VARELAFERNANDEZ SABELA;MINGO VILLALOBOS BERNARDO;MARTINEZ RODRIGUEZ RAMON. Datos registrales. T 37765 , F 195, S8, H M 672790, I/A 6 (21.03.19).

19 de Octubre de 2018
Sociedad unipersonal. Cambio de identidad del socio 煤nico: GESTION Y TECNICAS DEL AGUA SA. Cambio de domiciliosocial. C/ ROSARIO DEL PINO 14-16 (MADRID). Datos registrales. T 37765 , F 194, S 8, H M 672790, I/A 4 (11.10.18).

12 de Septiembre de 2018
Reducci贸n de capital. Importe reducci贸n: 2.728.093,00 Euros. Resultante Suscrito: 23.832.147,00 Euros. Datos registrales. T37765 , F 193, S 8, H M 672790, I/A 2 ( 4.09.18).

Ceses/Dimisiones. Adm. Unico: SACYR SERVICIOS SA. Representan: ABRIL-MARTORELL HERNANDEZ PABLO.Nombramientos. Adm. Unico: RUBIO DIAZ DE TUDANCA JOSE-LUIS. Datos registrales. T 37765 , F 193, S 8, H M 672790, I/A 3 (5.09.18).

20 de Julio de 2018
Constituci贸n. Comienzo de operaciones: 11.06.18. Objeto social: a)-- Los servicios de gesti贸n de activos relacionados con serviciosde abastecimiento de agua y los servicios de operaci贸n mantenimiento de estaciones, plantas, redes e instalaciones generales deabastecimiento y saneamiento de agua. Domicilio: PASEO DE LA CASTELLANA 83-85 (MADRID). Capital: 26.560.240,00 Euros.Declaraci贸n de unipersonalidad. Socio 煤nico: SACYR SERVICIOS SA. Nombramientos. Adm. Unico: SACYR SERVICIOS SA.Datos registrales. T 37765 , F 189, S 8, H M 672790, I/A 1 (13.07.18).

Utilizamos cookies de terceros con finalidades anal铆ticas, de personalizaci贸n, y de publicidad comportamental. Puede configurar ahora el uso de esta tecnolog铆a. Si acepta o contin煤a navegando, consideramos que est谩 de acuerdo con su uso. Mas informaci贸n