Buscador CIF Logo

Actos BORME Nusim Sociedad Anonima

驴Quieres acceder a la API de EMPRESAS CIF? Obten la informaci贸n de todas las empresas en tiempo real desde tu plataforma.
Ahora con un 25% de DESCUENTO el primer MES. Quiero la API de EMPRESAS

Logo cabecera Nusim Sociedad Anonima

Actos BORME Nusim Sociedad Anonima - A28656726

Tenemos registrados 16 Actos BORME del Registro Mercantil de Madrid para Nusim Sociedad Anonima con CIF A28656726

馃敊 Perfil de Nusim Sociedad Anonima
馃洅 Comprar listado completo de Empresas de Madrid

Actos BORME de Nusim Sociedad Anonima

12 de Junio de 2023
Revocaciones. Apoderado: RUBIDO MU脩OZ PELAYO;RIESGO SAHELICES IGNACIO;REVILLA SAAVEDRA JULIOANTONIO;PASCUAL NARVAEZ MATIAS FRANCISCO. Datos registrales. T 7398 , F 10, S 8, H SE139068, I/A 5 ( 2.06.23).

09 de Mayo de 2023
Ceses/Dimisiones. Secretario: RIESGO SAHELICES IGNACIO. Consejero: REVILLA SAAVEDRA JULIO ANTONIO. Con.Delegado:REVILLA SAAVEDRA JULIO ANTONIO. Consejero: ZHAO BOHONG;WANG WEI. Presidente: WANG WEI. Nombramientos. Adm.Unico: WANG WEI. Modificaciones estatutarias. Art铆culo de los estatutos: 2. Domicilio social.-. REFUNDICION TOTALESTATUTARIA. Otros conceptos: Cambio del Organo de Administraci贸n: Consejo de administraci贸n a Administrador 煤nico. Cambiode domicilio social. C/ BALBINO MARRON 8 6 - MODULO 11, C.P. 41018 (SEVILLA). Datos registrales. T 7398 , F 2, S 8, HSE139068, I/A 2 (27.04.23).

Nombramientos. Apo.Man.Soli: BERNAL MARTINEZ FRANCISCO. Datos registrales. T 7398 , F 7, S 8, H SE139068, I/A 2(28.04.23).

07 de Julio de 2022
Ceses/Dimisiones. Consejero: SHI BOXUAN. Presidente: SHI BOXUAN. Nombramientos. Consejero: WANG WEI. Presidente:WANG WEI. Datos registrales. T 34059 , F 204, S 8, H M 65843, I/A 33 (30.06.22).

04 de Junio de 2020
Declaraci贸n de unipersonalidad. Socio 煤nico: TAIHAI MANOIR HE YUAN (SANGHAY) ENERGY EQUIPMENT C. Sociedadunipersonal. Cambio de identidad del socio 煤nico: NEPTU INTERNATIONAL ENVIRONMENTAL PROTECTION COMPA.Ceses/Dimisiones. Presidente: CHEMTROL ESPA脩OLA SA. Consejero: CHEMTROL ESPA脩OLA SA;PASCUAL NARVAEZ MATIASFRANCISCO;REVILLA SAAVEDRA JULIO ANTONIO. Cons.Del.Sol: PASCUAL NARVAEZ MATIAS FRANCISCO;REVILLASAAVEDRA JULIO ANTONIO. Representan: REVILLA SAAVEDRA JULIO. Nombramientos. Consejero: SHI BOXUAN;REVILLASAAVEDRA JULIO ANTONIO;ZHAO BOHONG. Presidente: SHI BOXUAN. Con.Delegado: REVILLA SAAVEDRA JULIO ANTONIO.Reelecciones. Secretario: RIESGO SAHELICES IGNACIO. Datos registrales. T 34059 , F 203, S 8, H M 65843, I/A 32 (28.05.20).

15 de Noviembre de 2019
Reelecciones. Auditor: AUDIREPORT SL. Datos registrales. T 34059 , F 203, S 8, H M 65843, I/A 31 ( 8.11.19).

25 de Enero de 2016
Ampliaci贸n de capital. Suscrito: 143.577,00 Euros. Desembolsado: 143.577,00 Euros. Resultante Suscrito: 300.097,00 Euros.Resultante Desembolsado: 300.097,00 Euros. Datos registrales. T 17215 , F 19, S 8, H M 65843, I/A 30 (15.01.16).

13 de Enero de 2016
Nombramientos. Auditor: AUDIREPORT SL. Datos registrales. T 17215 , F 19, S 8, H M 65843, I/A 29 ( 4.01.16).

08 de Septiembre de 2015
Revocaciones. Apoderado: GALLEGO CARDABA JOSE ROBERTO;PUNZON SANTORIO FRANCISCO JAVIER. Datos registrales.T 17215 , F 19, S 8, H M 65843, I/A 28 (28.08.15).

21 de Julio de 2015
Reelecciones. Presidente: CHEMTROL ESPA脩OLA SA. Consejero: CHEMTROL ESPA脩OLA SA;PASCUAL NARVAEZ MATIASFRANCISCO;REVILLA SAAVEDRA JULIO ANTONIO. Cons.Del.Sol: PASCUAL NARVAEZ MATIAS FRANCISCO;REVILLASAAVEDRA JULIO ANTONIO. Secretario: RIESGO SAHELICES IGNACIO. Representan: REVILLA SAAVEDRA JULIO. Datosregistrales. T 17215 , F 18, S 8, H M 65843, I/A 27 (10.07.15).

03 de Noviembre de 2014
Ceses/Dimisiones. Representan: REVILLA SAAVEDRA FRANCISCO JAVIER. Nombramientos. Representan: REVILLASAAVEDRA JULIO. Datos registrales. T 17215 , F 18, S 8, H M 65843, I/A 26 (27.10.14).

08 de Mayo de 2014
Ampliaci贸n de capital. Suscrito: 96.320,00 Euros. Desembolsado: 96.320,00 Euros. Resultante Suscrito: 156.520,00 Euros.Resultante Desembolsado: 156.520,00 Euros. Datos registrales. T 17215 , F 17, S 8, H M 65843, I/A 25 (28.04.14).

28 de Junio de 2013
Revocaciones. Apoderado: PEREZ VAZQUEZ FRANCISCO;GALLEGO CARDABA JOSE ROBERTO. Nombramientos.Apoderado: GALLEGO CARDABA JOSE ROBERTO;REVILLA SAAVEDRA JULIO ANTONIO;PASCUAL NARVAEZ MATIASFRANCISCO. Datos registrales. T 17215 , F 16, S 8, H M 65843, I/A 24 (20.06.13).

26 de Enero de 2012
Revocaciones. Apo.Man.Soli: ZAJARA ESPINOSA LUIS. Datos registrales. T 17215 , F 15, S 8, H M 65843, I/A 22 (16.01.12).

Nombramientos. Apoderado: GALLEGO CARDABA JOSE ROBERTO. Datos registrales. T 17215 , F 15, S 8, H M 65843, I/A 23(16.01.12).

28 de Julio de 2010
Reelecciones. Presidente: CHEMTROL ESPA脩OLA SA. Consejero: CHEMTROL ESPA脩OLA SA;PASCUAL NARVAEZ MATIASFRANCISCO;REVILLA SAAVEDRA JULIO ANTONIO. Cons.Del.Sol: PASCUAL NARVAEZ MATIAS FRANCISCO;REVILLASAAVEDRA JULIO ANTONIO. Representan: REVILLA SAAVEDRA FRANCISCO JAVIER. Secretario: RIESGO SAHELICESIGNACIO. Datos registrales. T 17215 , F 15, S 8, H M 65843, I/A 21 (15.07.10).

Utilizamos cookies de terceros con finalidades anal铆ticas, de personalizaci贸n, y de publicidad comportamental. Puede configurar ahora el uso de esta tecnolog铆a. Si acepta o contin煤a navegando, consideramos que est谩 de acuerdo con su uso. Mas informaci贸n