Actos BORME de Nutreco Iberia Sl
25 de Noviembre de 2021Disoluci贸n. Fusion. Extinci贸n. Datos registrales. T 35483 , F 113, S 8, H M 571154, I/A 51 (18.11.21).
30 de Abril de 2021Reelecciones. Auditor: KPMG AUDITORES SL. Datos registrales. T 35483 , F 113, S 8, H M 571154, I/A 50 (23.04.21).
13 de Agosto de 2020Ceses/Dimisiones. Adm. Mancom.: CORDERO CASTILLO PEDRO LUIS. Nombramientos. Adm. Mancom.: COUDERC PIERRE.Datos registrales. T 35483 , F 113, S 8, H M 571154, I/A 49 ( 6.08.20).
12 de Marzo de 2020Nombramientos. Apoderado: RODRIGUEZ COJO RAUL. Datos registrales. T 35483 , F 111, S 8, H M 571154, I/A 46 ( 5.03.20).
Ceses/Dimisiones. Adm. Mancom.: BOTTER GERHARD. Nombramientos. Adm. Mancom.: CORDERO CASTILLO PEDRO LUIS.Datos registrales. T 35483 , F 111, S 8, H M 571154, I/A 47 ( 5.03.20).
Revocaciones. Apoderado: FERNANDEZ DOCTOR JUAN PEDRO;FERNANDEZ DOCTOR JUAN PEDRO. Apo.Manc.:FERNANDEZ DOCTOR JUAN PEDRO. Apo.Man.Soli: BOTTER GERHARD. Apo.Manc.: FERNANDEZ DOCTOR JUAN PEDRO.Nombramientos. Apo.Man.Soli: DE ANCOS ARACIL MARIA ELENA. Datos registrales. T 35483 , F 111, S 8, H M 571154, I/A 48 (5.03.20).
30 de Enero de 2020Revocaciones. Apoderado: DEL BOSQUE SAENZ MARTA. Apo.Manc.: DEL BOSQUE SAENZ MARTA;DEL BOSQUE SAENZMARTA. Nombramientos. Apoderado: QUINTANA RODRIGUEZ MARIA ANGELES. Datos registrales. T 35483 , F 110, S 8, H M571154, I/A 45 (23.01.20).
20 de Noviembre de 2019Reelecciones. Auditor: KPMG AUDITORES SL. Datos registrales. T 35483 , F 110, S 8, H M 571154, I/A 44 (13.11.19).
29 de Julio de 2019Ceses/Dimisiones. Consejero: VELASCO ARROYO ENRIQUE;VAN REENEN REMCO;GARCIA LORENZO MANUEL;CORDEROCASTILLO PEDRO LUIS;BOTTER GERHARD. Presidente: BOTTER GERHARD. Consejero: FOGLIATO MARIA VERONICA.Vicepresid.: FOGLIATO MARIA VERONICA. SecreNoConsj: GOMEZ DE BONILLA GONZALEZ MARIA ELISA. Nombramientos.Adm. Mancom.: BOTTER GERHARD;FOGLIATO MARIA VERONICA. Otros conceptos: Cambio del Organo de Administraci贸n:Consejo de administraci贸n a Administradores mancomunados. Datos registrales. T 35483 , F 109, S 8, H M 571154, I/A 43(19.07.19).
07 de Marzo de 2019Revocaciones. Apo.Man.Soli: VAN DEN BERG GERARDUS HENDRIKUS JOHANNES. Nombramientos. Apoderado: GOMEZ DEBONILLA GONZALEZ MARIA ELISA;DEL CAMPO PASTOR AMALIA MARIA. Datos registrales. T 35483 , F 107, S 8, H M 571154,I/A 41 (28.02.19).
Nombramientos. Apoderado: FOGLIATO MARIA VERONICA. Datos registrales. T 35483 , F 108, S 8, H M 571154, I/A 42(28.02.19).
01 de Marzo de 2019Ceses/Dimisiones. Consejero: VAN DEN BERG GERARDUS HENDRIKUS JOHANNES. Vicepresid.: VAN DEN BERG GERARDUSHENDRIKUS JOHANNES. Nombramientos. Consejero: FOGLIATO MARIA VERONICA. Vicepresid.: FOGLIATO MARIAVERONICA. Datos registrales. T 35483 , F 107, S 8, H M 571154, I/A 40 (22.02.19).
14 de Enero de 2019Reelecciones. Auditor: KPMG AUDITORES SL. Datos registrales. T 35483 , F 106, S 8, H M 571154, I/A 39 ( 4.01.19).
11 de Julio de 2018Ceses/Dimisiones. SecreNoConsj: GALLEGO LONGAS ESTIBALIZ. Nombramientos. SecreNoConsj: GOMEZ DE BONILLAGONZALEZ MARIA ELISA. Datos registrales. T 35483 , F 105, S 8, H M 571154, I/A 36 ( 3.07.18).
Nombramientos. Apoderado: GOMEZ DE BONILLA GONZALEZ MARIA ELISA. Datos registrales. T 35483 , F 106, S 8, H M571154, I/A 37 ( 3.07.18).
Revocaciones. Apoderado: GALLEGO LONGAS ESTIBALIZ. Datos registrales. T 35483 , F 106, S 8, H M 571154, I/A 38 ( 3.07.18).
07 de Mayo de 2018Nombramientos. Apo.Man.Soli: VAN DEN BERG GERARDUS HENDRIKUS JOHANNES. Apo.Manc.: FERNANDEZ DOCTOR JUANPEDRO;DEL BOSQUE SAENZ MARTA;QUINTANA RODRIGUEZ MARIA ANGELES. Datos registrales. T 35483 , F 104, S 8, H M571154, I/A 35 (26.04.18).
28 de Marzo de 2018Ceses/Dimisiones. Consejero: MARTINEZ ASO ANGEL CARLOS. Vicepresid.: MARTINEZ ASO ANGEL CARLOS.
Revocaciones. Apoderado: MARTINEZ ASO ANGEL CARLOS. Apo.Manc.: MARTINEZ ASO ANGEL CARLOS;MARTINEZ ASOANGEL CARLOS. Datos registrales. T 35483 , F 104, S 8, H M 571154, I/A 34 (21.03.18).
20 de Diciembre de 2017Reelecciones. Auditor: KPMG AUDITORES SL. Datos registrales. T 35483 , F 103, S 8, H M 571154, I/A 32 (12.12.17).
27 de Octubre de 2017P谩gina web de la sociedad. Creaci贸n de la p谩gina web corporativa: www.nutrecoiberia.es. Datos registrales. T 35483 , F 103, S 8,H M 571154, I/A 31 (19.10.17).
02 de Agosto de 2017Sociedad unipersonal. Cambio de identidad del socio 煤nico: AGRIFOOD HISPANIA SL. Datos registrales. T 35483 , F 103, S 8,H M 571154, I/A 30 (26.07.17).
07 de Marzo de 2017Revocaciones. Apo.Manc.: MOLINA PEREIRA LAURA. Apoderado: MOLINA PEREIRA LAURA. Apo.Manc.: MOLINA PEREIRALAURA. Datos registrales. T 33578 , F 217, S 8, H M 571154, I/A 28 (27.02.17).
Ceses/Dimisiones. Consejero: CAPILLA AZPILICUETA EULALIA. Reelecciones. Consejero: MARTINEZ ASO ANGELCARLOS;GARCIA LORENZO MANUEL;CORDERO CASTILLO PEDRO LUIS. Vicepresid.: MARTINEZ ASO ANGEL CARLOS.Consejero: BOTTER GERHARD. Presidente: BOTTER GERHARD. SecreNoConsj: GALLEGO LONGAS ESTIBALIZ. Datosregistrales. T 33578 , F 217, S 8, H M 571154, I/A 29 (27.02.17).
14 de Febrero de 2017Ceses/Dimisiones. Vicepresid.: BOTTER GERHARD. Consejero: GARCIA VAN-GEIN GABRIEL. Presidente: GARCIA VAN-GEINGABRIEL. Nombramientos. Presidente: BOTTER GERHARD. Reelecciones. SecreNoConsj: GALLEGO LONGAS ESTIBALIZ.Consejero: MARTINEZ ASO ANGEL CARLOS;CAPILLA AZPILICUETA EULALIA;GARCIA LORENZO MANUEL;CORDEROCASTILLO PEDRO LUIS. Vicepresid.: MARTINEZ ASO ANGEL CARLOS. Consejero: BOTTER GERHARD. Datos registrales. T33578 , F 216, S 8, H M 571154, I/A 26 ( 6.02.17).
Revocaciones. Apo.Man.Soli: GARCIA VAN-GEIN GABRIEL. Datos registrales. T 33578 , F 217, S 8, H M 571154, I/A 27 (7.02.17).
20 de Enero de 2017Reelecciones. Auditor: KPMG AUDITORES SL. Datos registrales. T 33578 , F 214, S 8, H M 571154, I/A 23 (12.01.17).
Nombramientos. Consejero: BOTTER GERHARD. Vicepresid.: BOTTER GERHARD. Datos registrales. T 33578 , F 214, S 8, H M571154, I/A 24 (12.01.17).
Nombramientos. Apo.Man.Soli: BOTTER GERHARD. Datos registrales. T 33578 , F 214, S 8, H M 571154, I/A 25 (13.01.17).
02 de Noviembre de 2016Ceses/Dimisiones. Presidente: MARTINEZ ASO ANGEL CARLOS. Vicepresid.: GARCIA LORENZO MANUEL. Nombramientos.Consejero: GARCIA VAN-GEIN GABRIEL. Vicepresid.: MARTINEZ ASO ANGEL CARLOS. Presidente: GARCIA VAN-GEIN GABRIEL.Reelecciones. SecreNoConsj: GALLEGO LONGAS ESTIBALIZ. Consejero: MARTINEZ ASO ANGEL CARLOS;CAPILLAAZPILICUETA EULALIA;GARCIA LORENZO MANUEL;CORDERO CASTILLO PEDRO LUIS. Datos registrales. T 33578 , F 211, S8, H M 571154, I/A 21 (24.10.16).
Nombramientos. Apo.Man.Soli: GARCIA VAN-GEIN GABRIEL. Apo.Manc.: DEL BOSQUE SAENZ MARTA;MOLINA PEREIRALAURA;FERNANDEZ DOCTOR JUAN PEDRO;MARTINEZ ASO ANGEL CARLOS;QUINTANA RODRIGUEZ MARIA ANGELES.Datos registrales. T 33578 , F 212, S 8, H M 571154, I/A 22 (24.10.16).
16 de Septiembre de 2016Nombramientos. Apo.Manc.: QUINTANA RODRIGUEZ MARIA ANGELES;MARTINEZ ASO ANGEL CARLOS. Datos registrales. T33578 , F 211, S 8, H M 571154, I/A 20 ( 8.09.16).
15 de Septiembre de 2016Revocaciones. Apoderado: RODRIGUEZ CEBALLOS FRANCISCO JAVIER. Datos registrales. T 33578 , F 210, S 8, H M 571154,I/A 19 ( 7.09.16).
07 de Septiembre de 2016Ceses/Dimisiones. Consejero: RODRIGUEZ CEBALLOS FRANCISCO JAVIER. Presidente: RODRIGUEZ CEBALLOS FRANCISCOJAVIER. Vicepresid.: MARTINEZ ASO ANGEL CARLOS. Nombramientos. Presidente: MARTINEZ ASO ANGEL CARLOS.Vicepresid.: GARCIA LORENZO MANUEL. Reelecciones. Consejero: MARTINEZ ASO ANGEL CARLOS;CAPILLA AZPILICUETAEULALIA;GARCIA LORENZO MANUEL;CORDERO CASTILLO PEDRO LUIS. SecreNoConsj: GALLEGO LONGAS ESTIBALIZ.Datos registrales. T 33578 , F 210, S 8, H M 571154, I/A 18 (30.08.16).
31 de Diciembre de 2015Reelecciones. Auditor: KPMG AUDITORES SL. Datos registrales. T 33578 , F 210, S 8, H M 571154, I/A 17 (22.12.15).