Buscador CIF Logo

Actos BORME Obras Coman Sa

驴Quieres acceder a la API de EMPRESAS CIF? Obten la informaci贸n de todas las empresas en tiempo real desde tu plataforma.
Ahora con un 25% de DESCUENTO el primer MES. Quiero la API de EMPRESAS

Logo cabecera Obras Coman Sa

Actos BORME Obras Coman Sa - A19160563

Tenemos registrados 35 Actos BORME del Registro Mercantil de Guadalajara para Obras Coman Sa con CIF A19160563

馃敊 Perfil de Obras Coman Sa
馃洅 Comprar listado completo de Empresas de Guadalajara

Actos BORME de Obras Coman Sa

20 de Marzo de 2020
Revocaciones. Apoderado: DE AGUSTIN RECAREDO MARIA DEL AMOR. Datos registrales. T 28129 , F 223, S 8, H M 250197,I/A 71 (13.03.20).

04 de Abril de 2019
Situaci贸n concursal. Procedimiento concursal 451/2013. FIRME: Si, Fecha de resoluci贸n 29/05/2018. Auto de apertura de la fase deconvenio. Juzgado: num. 0 JUZGADO DE LO MERCANTIL NUMERO 2 DE MADRID. Juez: DON ANDRES SANCHEZ MAGRO.Resoluciones: Convertida en inscripci贸n la Anotaci贸n preventiva Letra C, por haber ganado firmeza el Auto de apertura de la fase deConvenio, dictado con fecha 29 de mayo de.2018, por el Juzgado de lo Mercantil n潞 2 de Madrid, procedimiento n煤mero 455/2013.Datos registrales. T 28129 , F 223, S 8, H M 250197, I/A 70 (28.03.19).

23 de Octubre de 2018
Situaci贸n concursal. Procedimiento concursal 451/2013. FIRME: No, Fecha de resoluci贸n 29/05/2018. Auto de apertura de la fase deconvenio. Juzgado: num. 2 JUZGADO DE LO MERCANTIL DE MADRID. Juez: DON ANDRES SANCHEZ MAGRO. Resoluciones:MEDIANTE AUTO DE FECHA 29 DE MAYO DE 2018, SE ACUERDA LA APERTURA DE LA FASE DE.CONVENIO. Datosregistrales. T 28129 , F 223, S 8, H M 250197, I/A C (16.10.18).

14 de Mayo de 2018
Revocaciones. Apoderado: TORRUBIANO ROMERO GUSTAVO. Datos registrales. T 28129 , F 222, S 8, H M 250197, I/A 69 (4.05.18).

07 de Mayo de 2018
Revocaciones. Apoderado: MORENO BURDALO JOSE PEDRO;CARRILLO PABLO LUIS RAMON;MORENO BURDALO JOSEPEDRO. Datos registrales. T 28129 , F 222, S 8, H M 250197, I/A 68 (26.04.18).

02 de Abril de 2018
Ceses/Dimisiones. Adm. Unico: GESTESA GESTION Y SERVICIOS SL. Representan: HEREDIA MARTINEZ JAVIER.Nombramientos. Adm. Unico: PARQUES EMPRESARIALES GUADALAJARA SL. Representan: HEREDIA MARTINEZ JAVIER.Datos registrales. T 28129 , F 222, S 8, H M 250197, I/A 67 (22.03.18).

06 de Noviembre de 2017
Reelecciones. Representan: HEREDIA MARTINEZ JAVIER. Adm. Unico: GESTESA GESTION Y SERVICIOS SL. Datosregistrales. T 28129 , F 221, S 8, H M 250197, I/A 66 (27.10.17).

13 de Julio de 2015
Nombramientos. Auditor: GARRIDO AUDITORES SL. Datos registrales. T 28129 , F 221, S 8, H M 250197, I/A 65 ( 2.07.15).

26 de Diciembre de 2014
Situaci贸n concursal. Procedimiento concursal 455/2013. FIRME: No, Fecha de resoluci贸n 7/02/2014. Auto de declaraci贸n deconcurso. Voluntario. Juzgado: num. 2 JUZGADO DE LO MERCANTIL DE MADRID. Juez: DON ANDRES SANCHEZ MAGRO.Resoluciones: Declarada en concurso voluntario ordinario. Conservar谩 las facultades de administraci贸n y disposici贸n sobre supatrimonio, quedando sometido el ejercicio a la administraci贸n concursal, mediante su autorizaci贸n o conformidad. Situaci贸nconcursal. Procedimiento concursal 451/2013. Fecha de resoluci贸n 7/02/2014. Nombramiento de administradores. Juzgado: num. 2JUZGADO DE LO MERCANTIL DE MADRID. Juez: DON ANDRES SANCHEZ MAGRO. Administrador Concursal. Fecha 7/02/2014,NIF/CIF 50283113F. FRAILE BARTOLOME GREGORIO. Datos registrales. T 28129 , F 220, S 8, H M 250197, I/A B (16.12.14).

27 de Mayo de 2014
Revocaciones. Apoderado: NOVELLA OTERINO GONZALO;GONZALEZ AYALA OSCAR;MARTINEZ LEDESMA MANUEL;GABRIELCORTES AGUSTIN;MARTIN JUAN ESTHER;PE脩UELAS CASTILLO MARIA ESTHER;MU脩OZ MORA ALEJANDRO;LOZANOESCUDERO ALMUDENA;SAN ANTONIO MANZANO SONIA;HERRERA HIRUELO LIDIA;CAMACHO MAESO SONIA;ADAN

26 de Noviembre de 2013
Reducci贸n de capital. Importe reducci贸n: 8.001.280,00 Euros. Resultante Suscrito: 428.295,00 Euros. Modificaciones estatutarias.Art铆culo de los estatutos: 6. Capital.-. Datos registrales. T 28129 , F 219, S 8, H M 250197, I/A 63 (19.11.13).

18 de Noviembre de 2013
Situaci贸n concursal. Procedimiento concursal 451/2013. FIRME: No, Fecha de resoluci贸n 17/09/2013. Auto de declaraci贸n deconcurso. Necesario. Juzgado: num. 2 JUZGADO DE LO MERCANTIL DE MADRID. Juez: DON ANDRES SANCHEZ MAGRO.Resoluciones: Por AUTO FIRME DE FECHA 14 DE OCTUBRE DE 2013 se declara la NULIDAD DEL AUTO DE FECHA 17 DESEPTIEMBRE DE 2013 de declaraci贸n de concurso, quedando en consecuencia sin efecto la anotaci贸n preventiva A. que motiv贸 elmismo. Situaci贸n concursal. Procedimiento concursal 451/2013. Fecha de resoluci贸n 17/09/2013. Revocaci贸n de administradoresconcursales. Juzgado: num. 2 JUZGADO DE LO MERCANTIL DE MADRID. Juez: DON ANDRES SANCHEZ MAGRO. AdministradorConcursal. Fecha 14/10/2013, NIF/CIF 50283113F. FRAILE BARTOLOME GREGORIO. Datos registrales. T 28129 , F 219, S 8, H M250197, I/A 62 ( 8.11.13).

22 de Octubre de 2013
Situaci贸n concursal. Procedimiento concursal 451/2013. FIRME: No, Fecha de resoluci贸n 17/09/2013. Auto de declaraci贸n deconcurso. Necesario. Juzgado: num. 2 JUZGADO DE LO MERCANTIL DE MADRID. Juez: DON ANDRES SANCHEZ MAGRO.Resoluciones: El deudor conservar谩 las facultades de administraci贸n y disposici贸n sobre su patrimonio, quedando intervenidas por laadministraci贸n concursal, mediante su autorizaci贸n o conformidad. Situaci贸n concursal. Procedimiento concursal 451/2013. Fechade resoluci贸n 17/09/2013. Nombramiento de administradores. Juzgado: num. 2 JUZGADO DE LO MERCANTIL DE MADRID. Juez:DON ANDRES SANCHEZ MAGRO. Administrador Concursal. Fecha 17/09/2013, NIF/CIF 50283113F. FRAILE BARTOLOMEGREGORIO. Datos registrales. T 28129 , F 216, S 8, H M 250197, I/A A (14.10.13).

21 de Febrero de 2013
Revocaciones. Apoderado: MEGIAS BA脩ON JOSE. Datos registrales. T 28129 , F 216, S 8, H M 250197, I/A 61 (13.02.13).

11 de Diciembre de 2012
Revocaciones. Apoderado: LUENGO ROMERO JESUS-MARIA;CARBONERO TARAVILLO ALMUDENA;ALCAZAR PEREZ MARIADEL PILAR;GONZALEZ MORALES JUAN MANUEL;DE AGUSTIN CABALLERO LUIS FERNANDO;BERROCAL DE LA CALLE JOSEVICENTE;LOPEZ GARCIA JAVIER;SANCHEZ GUERRERO FABIOLA;TORRECILLA ALCALDE AMALIO TEODORO;DE AGUSTINRECAREDO MARIA DEL AMOR;LUENGO ROMERO JESUS-MARIA. Apo.Man.Soli: POZO DE CASTRO JESUSMIGUEL;TORRECILLA ALCALDE AMALIO TEODORO. Datos registrales. T 28129 , F 216, S 8, H M 250197, I/A 60 (30.11.12).

30 de Marzo de 2012
Reelecciones. Adm. Unico: GESTESA GESTION Y SERVICIOS SL. Representan: HEREDIA MARTINEZ JAVIER. Datosregistrales. T 28129 , F 215, S 8, H M 250197, I/A 59 (20.03.12).

15 de Febrero de 2012
Nombramientos. Auditor: GARRIDO AUDITORES SL. Datos registrales. T 28129 , F 212, S 8, H M 250197, I/A 56 ( 3.02.12).

Nombramientos. Apoderado: DE AGUSTIN RECAREDO MARIA DEL AMOR. Datos registrales. T 28129 , F 213, S 8, H M 250197,I/A 57 ( 3.02.12).

Nombramientos. Apoderado: TORRUBIANO ROMERO GUSTAVO. Datos registrales. T 28129 , F 215, S 8, H M 250197, I/A 58 (3.02.12).

07 de Octubre de 2011
Revocaciones. Apoderado: VOLPINI REYES CARLOS-MANUEL;CALVO MARIN EMILIO;VECINA MORENO JESUS;SORIA LOPEZFRANCISCO JAVIER;MU脩OZ CASSONI DANIEL;ALVAREZ GARCIA RAFAEL JESUS;LOPEZ SERRANO ANTONIO;VICENTEMARTINEZ ALBERTO;LINARES AGUIRRE FEDERICO;SEIJO PEREZ BEGO脩A;ALVAREZ MU脩OZ MANUEL;MINGO MELEROIZIAR;GARCIA TOBARUELA LUIS MANUEL. Datos registrales. T 28129 , F 212, S 8, H M 250197, I/A 55 (28.09.11).

08 de Junio de 2011
Revocaciones. Apoderado: MADRIGAL NAVARRO JOAQUIN JOSE. Datos registrales. T 28129 , F 211, S 8, H M 250197, I/A 54(23.05.11).

08 de Abril de 2011
Revocaciones. Apoderado: CALVO MARIN EMILIO;TORRECILLA ALCALDE AMALIO;LOPEZ OLIVERA JUAN JOSE;LAZAROLAZARO LUIS. Apo.Manc.: TORRECILLA ALCALDE AMALIO TEODORO. Apoderado: NOVELLA OTERINO GONZALO;LUENGOROMERO JESUS-MARIA;TORRECILLA ALCALDE AMALIO;TORRECILLA ALCALDE AMALIO TEODORO;TORRECILLA ALCALDEAMALIO TEODORO;LOPEZ LOBO CARLOS MANUEL;LOPEZ LOBO CARLOS MANUEL;ALVAREZ MU脩OZ MANUEL;SORIA LOPEZFRANCISCO JAVIER;LOPEZ LOBO CARLOS MANUEL. Datos registrales. T 28129 , F 211, S 8, H M 250197, I/A 53 (29.03.11).

25 de Marzo de 2011
Revocaciones. Apoderado: RANERA LEON SANTIAGO;RANERA LEON SANTIAGO;RANERA LEON SANTIAGO. Datosregistrales. T 28129 , F 211, S 8, H M 250197, I/A 52 (15.03.11).

08 de Febrero de 2011
Reelecciones. Auditor: GASSO AUDITORES SL. Datos registrales. T 15005 , F 214, S 8, H M 250197, I/A 51 (27.01.11).

20 de Enero de 2011
Cambio de objeto social. PROMOCION , DESARROLLO , URBANIZACION , CONSTRUCCION , REHABILITACION, GESTION YEXPLOTACION EN CUALQUIER FORMA DE SOLARES... Datos registrales. T 15005 , F 214, S 8, H M 250197, I/A 50 ( 7.01.11).

25 de Noviembre de 2010
Nombramientos. Apo.Man.Soli: GONZALEZ AYALA OSCAR;POZO DE CASTRO JESUS MIGUEL;TORRECILLA ALCALDE AMALIOTEODORO. Apo.Manc.: MADRIGAL NAVARRO JOAQUIN JOSE. Datos registrales. T 15005 , F 212, S 8, H M 250197, I/A 49(15.11.10).

03 de Mayo de 2010
Revocaciones. Apoderado: CATALINAS CARRETO ANGEL;ALVAREZ ARRIBAS SANTIAGO;VOLPINI REYES CARLOS-MANUEL;ALVAREZ ARRIBAS SANTIAGO;ALVAREZ ARRIBAS SANTIAGO;CATALINAS CARRETO ANGEL;ALVAREZ ARRIBASSANTIAGO;CATALINAS CARRETO ANGEL;ALVAREZ ARRIBAS SANTIAGO. Datos registrales. T 15005 , F 209, S 8, H M 250197,I/A 47 (21.04.10).

Nombramientos. Apoderado: GONZALEZ AYALA OSCAR;LOPEZ LOBO CARLOS MANUEL;TORRECILLA ALCALDE AMALIOTEODORO. Datos registrales. T 15005 , F 209, S 8, H M 250197, I/A 48 (21.04.10).

06 de Abril de 2010
Reelecciones. Auditor: GASSO AUDITORES SL. Datos registrales. T 15005 , F 209, S 8, H M 250197, I/A 46 (22.03.10).

18 de Enero de 2010
Fusi贸n por absorci贸n. Sociedades absorbidas: BAREM ESTRUCTURAS INDUSTRIALES SL. Datos registrales. T 15005 , F 208,S 8, H M 250197, I/A 45 (31.12.09).

09 de Diciembre de 2009
Nombramientos. Apoderado: ALVAREZ ARRIBAS SANTIAGO;TORRECILLA ALCALDE AMALIO TEODORO;LOPEZ LOBOCARLOS MANUEL;MINGO MELERO IZIAR;DE AGUSTIN RECAREDO MARIA DEL AMOR;FRANCHY PI脩A FERNANDO DOMINGO.Datos registrales. T 15005 , F 203, S 8, H M 250197, I/A 42 (26.11.09).

Nombramientos. Apoderado: LOPEZ LOBO CARLOS MANUEL;CATALINAS CARRETO ANGEL;MORENO BURDALO JOSEPEDRO;ALVAREZ MU脩OZ MANUEL;LUENGO ROMERO JESUS-MARIA;GONZALEZ AYALA OSCAR;SORIA LOPEZ FRANCISCOJAVIER;NOVELLA OTERINO GONZALO;RANERA LEON SANTIAGO;GARCIA TOBARUELA LUIS MANUEL;ALVAREZ ARRIBASSANTIAGO. Datos registrales. T 15005 , F 206, S 8, H M 250197, I/A 43 (26.11.09).

Nombramientos. Apoderado: SANCHEZ ALONSO JUAN;MADRIGAL NAVARRO JOAQUIN JOSE. Datos registrales. T 15005 , F207, S 8, H M 250197, I/A 44 (26.11.09).

03 de Diciembre de 2009
Revocaciones. Apoderado: ROMERO DIEZ MARIN;ROMERO DIEZ MARIN. Apo.Man.Soli: ROMERO DIEZ MARIN. Apoderado:MARTINEZ VILAR CRISTOBAL;ROMERO DIEZ MARIN;MARTINEZ VILAR CRISTOBAL;ROMERO DIEZ MARIN;MARTINEZ VILARCRISTOBAL;ROMERO DIEZ MARIN. Datos registrales. T 15005 , F 203, S 8, H M 250197, I/A 41 (24.11.09).

13 de Abril de 2009
Reelecciones. Auditor: GASSO AUDITORES SL. Datos registrales. T 15005 , F 203, S 8, H M 250197, I/A 40 (30.03.09).

Utilizamos cookies de terceros con finalidades anal铆ticas, de personalizaci贸n, y de publicidad comportamental. Puede configurar ahora el uso de esta tecnolog铆a. Si acepta o contin煤a navegando, consideramos que est谩 de acuerdo con su uso. Mas informaci贸n