Actos BORME de Obras Especiales Aragon Sa
09 de Diciembre de 2016Disoluci贸n. Fusion. Extinci贸n. Datos registrales. T 3681 , F 153, S 8, H Z 35354, I/A F (29.11.16).
07 de Octubre de 2016Otros conceptos: CERRADA LA HOJA POR PLAZO PROVISIONAL DE SEIS MESES, CONFORME AL ARTICULO 231 DELREGLAMENTO DEL REGISTRO MERCANTIL. Datos registrales. T 3681 , F 153, S 8, H Z 35354, I/A 21 N (29.09.16).
11 de Noviembre de 2014Revocaciones. Auditor: MAZARS AUDITORES SLP. Nombramientos. Auditor: KPMG AUDITORES SL. Datos registrales. T 3681, F 153, S 8, H Z 35354, I/A 21 (31.10.14).
12 de Marzo de 2014Reelecciones. Auditor: MAZARS AUDITORES SLP. Datos registrales. T 3681 , F 152, S 8, H Z 35354, I/A 20 ( 3.03.14).
10 de Octubre de 2013Reelecciones. Adm. Solid.: BALLARIN BIBIAN JOSE;JORDAN LANASPA LUIS-ALBERTO;BALLARIN DOMEQUE MARIA JOSE.Datos registrales. T 3681 , F 152, S 8, H Z 35354, I/A 19 ( 2.10.13).
07 de Septiembre de 2012Revocaciones. Apoderado: ALVAREZ HERRAIZ CARLOS. Datos registrales. T 3681 , F 152, S 8, H Z 35354, I/A 18 (27.08.12).
20 de Junio de 2012Nombramientos. Apoderado: MARTINEZ DE MORENTIN MORRAS JOSE IGNACIO. Datos registrales. T 3681 , F 152, S 8, H Z35354, I/A 17 ( 8.06.12).
18 de Mayo de 2012Revocaciones. Apoderado: MARTINEZ GUILLEN ALFREDO. Apo.Man.Soli: MARTINEZ GUILLEN ALFREDO;JUDEZ AGUADOPEDRO;HUGUET JUANENA JOSE MARIA. Datos registrales. T 3681 , F 152, S 8, H Z 35354, I/A 16 ( 7.05.12).
08 de Marzo de 2012Nombramientos. Apo.Man.Soli: GOMEZ FERNANDEZ JAVIER;JUDEZ AGUADO PEDRO;HUGUET JUANENA JOSE MARIA. Datosregistrales. T 3681 , F 150, S 8, H Z 35354, I/A 14 (28.02.12).
Nombramientos. Apoderado: GOMEZ FERNANDEZ JAVIER. Datos registrales. T 3681 , F 151, S 8, H Z 35354, I/A 15 (28.02.12).
13 de Diciembre de 2011Revocaciones. Apo.Man.Soli: MARTINEZ GUILLEN ALFREDO;DE CASTRO POZUELO ANA;HUGUET JUANENA JOSE MARIA.Nombramientos. Apo.Man.Soli: MARTINEZ GUILLEN ALFREDO;JUDEZ AGUADO PEDRO;HUGUET JUANENA JOSE MARIA.Datos registrales. T 3681 , F 150, S 8, H Z 35354, I/A 13 (29.11.11).
14 de Febrero de 2011Revocaciones. Auditor: GRANT THORNTON SLP. Nombramientos. Auditor: MAZARS AUDITORES SLP. Datos registrales. T3681 , F 150, S 8, H Z 35354, I/A 12 (31.01.11).
12 de Febrero de 2010Revocaciones. Apo.Man.Soli: HUGUET JUANENA JOSE MARIA;ALVAREZ HERRAIZ CARLOS;DE CASTRO POZUELO ANA.Nombramientos. Apo.Man.Soli: MARTINEZ GUILLEN ALFREDO;DE CASTRO POZUELO ANA;HUGUET JUANENA JOSE MARIA.Datos registrales. T 3046 , F 98, S 8, H Z 35354, I/A 10 ( 3.02.10).
Revocaciones. Apoderado: ALVAREZ HERRAIZ CARLOS. Nombramientos. Apoderado: MARTINEZ GUILLEN ALFREDO. Datosregistrales. T 3046 , F 98, S 8, H Z 35354, I/A 11 ( 3.02.10).
05 de Octubre de 2009Cambio de domicilio social. CTRA DEL AEROPUERTO 4 - CENTRO EMPRESARIAL SAN LAM (ZARAGOZA). Datos registrales.T 3046 , F 98, S 8, H Z 35354, I/A 9 (24.09.09).
20 de Enero de 2009Sociedad unipersonal. Cambio de identidad del socio 煤nico: GRUPO OBRAS ESPECIALES PROYECTOS EINFRAESTRUCTURA. Cambio de objeto social. A) La construcci贸n, promoci贸n, adquisici贸n, venta, y en general la explotaci贸n porcualquier medio admitido en Derecho y permitido bajo la presente forma social de todo tipo de inmuebles, y en concreto, de viviendas ylocales comerciales, pabellones industriales, garajes, terrenos, e inmuebles en ge. Datos registrales. T 3046 , F 98, S 8, H Z 35354,I/A 8 ( 8.01.09).