Actos BORME de Obrerol Sa
18 de Enero de 2022Nombramientos. Aud.Supl.: LOY MADERA MARIA DEL ROSARIO. Reelecciones. Auditor: VILLANUEVA SOMONTE JOSERAMON. Datos registrales. T 3174 , F 212, S 8, H AS 9150, I/A 39 (11.01.22).
09 de Agosto de 2021Ceses/Dimisiones. Consejero: SIERRA SANCHEZ AMADOR JOSE;SIERRA SANCHEZ ALEJANDRO;BARBES FERNANDEZALVARO;J. LLANOS Y F. LEIVA SL. Presidente: SIERRA SANCHEZ AMADOR JOSE. Secretario: SIERRA SANCHEZ ALEJANDRO.Con.Delegado: SIERRA SANCHEZ AMADOR JOSE. Nombramientos. Consejero: SIERRA SANCHEZ AMADOR JOSE. Presidente:SIERRA SANCHEZ AMADOR JOSE. Consejero: SIERRA SANCHEZ ALEJANDRO. Secretario: SIERRA SANCHEZ ALEJANDRO.Consejero: BARBES FERNANDEZ ALVARO;LLANOS RIERA FRANCISCO JAVIER. Con.Delegado: SIERRA SANCHEZ AMADORJOSE. Datos registrales. T 3174 , F 212, S 8, H AS 9150, I/A 38 ( 2.08.21).
04 de Agosto de 2020P谩gina web de la sociedad. Creaci贸n de la p谩gina web corporativa: www.obrerol-monza.com. Datos registrales. T 3174 , F 212, S8, H AS 9150, I/A 37 (28.07.20).
20 de Abril de 2018Nombramientos. Aud.Supl.: MORO HERES MARIA TERESA. Reelecciones. Auditor: VILLANUEVA SOMONTE JOSE RAMON.Datos registrales. T 3174 , F 212, S 8, H AS 9150, I/A 36 (11.04.18).
11 de Febrero de 2016Ceses/Dimisiones. Consejero: BARBES FERNANDEZ ALVARO;SIERRA SANCHEZ AMADOR JOSE;SIERRA SANCHEZALEJANDRO. Presidente: SIERRA SANCHEZ AMADOR JOSE. Cons.Del.Sol: SIERRA SANCHEZ AMADOR JOSE;SIERRASANCHEZ ALEJANDRO. Secretario: SIERRA SANCHEZ ALEJANDRO. Nombramientos. Consejero: SIERRA SANCHEZ AMADORJOSE;SIERRA SANCHEZ ALEJANDRO;BARBES FERNANDEZ ALVARO;J. LLANOS Y F. LEIVA SL. Presidente: SIERRA SANCHEZAMADOR JOSE. Secretario: SIERRA SANCHEZ ALEJANDRO. Con.Delegado: SIERRA SANCHEZ AMADOR JOSE. Datosregistrales. T 3174 , F 211, S 8, H AS 9150, I/A 35 ( 3.02.16).
22 de Octubre de 2014Nombramientos. Aud.Supl.: ALVAREZ-LAFUENTE IGLESIAS FERNANDO. Reelecciones. Auditor: VILLANUEVA SOMONTEJOSE RAMON. Modificaciones estatutarias. 8. Acciones/Participaciones.-. 17. Administraci贸n y Representacion.-. 25. Otros.-.Datos registrales. T 3174 , F 209, S 8, H AS 9150, I/A 34 (10.10.14).
29 de Agosto de 2013Ceses/Dimisiones. Consejero: MATEOS DE LAS VECILLAS JOSE ANTONIO;CAMARA VALGA脩ON FERNANDO. Secretario:MATEOS DE LAS VECILLAS JOSE ANTONIO. Nombramientos. Consejero: BARBES FERNANDEZ ALVARO. Secretario: SIERRA
Nombramientos. Apoderado: SIERRA SANCHEZ ALEJANDRO. Datos registrales. T 3174 , F 209, S 8, H AS 9150, I/A 33(21.08.13).
29 de Agosto de 2011Nombramientos. Auditor: VILLANUEVA SOMONTE JOSE RAMON. Aud.Supl.: RUBIO SUAREZ-PAZOS JOSE VICENTE.Modificaciones estatutarias. Art铆culo de los estatutos: 2. Objeto.-. 8. Transmisi贸n de Acciones/Participaciones.-. 10. FuncionamientoJunta Gral.-. 11. Funcionamiento Junta Gral.-. 13.Funcionamiento Junta Gral.-. 14. Funcionamiento Junta Gral.-. 15. FuncionamientoJunta Gral.-. 17. Administraci贸n y Representacion.-. 18. Administraci贸n y Representacion.-. 19. Cambio de objeto social. a.- Eldise帽o, fabricaci贸n, tratamiento, distribuci贸n, comercializaci贸n y explotaci贸n de toda clase de vestuario, calzado y equipos deprotecci贸n, as铆 como sus piezas, componentes, 煤tiles, accesorios, materiales auxiliares ycomplementos; b.- el dise帽o, fabricaci贸n,tratamiento, distribuci贸n, comerc. Datos registrales. T 3174 , F 205, S 8, H AS 9150, I/A 31 (17.08.11).
03 de Noviembre de 2010Revocaciones. Cons.Del.Sol: MATEOS DE LAS VECILLAS JOSE ANTONIO. Nombramientos. Cons.Del.Sol: SIERRA SANCHEZALEJANDRO. Reelecciones. Consejero: MATEOS DE LAS VECILLAS JOSE ANTONIO;CAMARA VALGA脩ONFERNANDO;SIERRA SANCHEZ AMADOR JOSE;SIERRA SANCHEZ ALEJANDRO. Presidente: SIERRA SANCHEZ AMADOR JOSE.Cons.Del.Sol: SIERRA SANCHEZ AMADOR JOSE. Secretario: MATEOS DE LAS VECILLAS JOSE ANTONIO. Datos registrales. T3174 , F 205, S 8, H AS 9150, I/A 30 (21.10.10).
11 de Febrero de 2009Reelecciones. Auditor: VILLANUEVA SOMONTE JOSE RAMON. Aud.Supl.: RUBIO SUAREZ-PAZOS JOSE VICENTE CAYETANO.Datos registrales. T 3174 , F 205, S 8, H AS 9150, I/A 29 (30.01.09).