Actos BORME de Ofg Adquisiciones E Ingenieria Sl
19 de Enero de 2023Nombramientos. Auditor: DELOITTE SL. Datos registrales. T 2739 , F 150, S 8, H CO 15416, I/A 26 (12.01.23).
25 de Octubre de 2022Reelecciones. Auditor: KPMG AUDITORES SL. Datos registrales. T 1739 , F 150, S 8, H CO 15416, I/A 24 (19.10.22).
13 de Julio de 2021Fe de erratas: En el borme 17/2019 se public贸 err贸neamente la denominaci贸n del nuevo Auditor de Cuentas, siendo el nombreconrrecto KPMG AUDITORES SL. Datos registrales. T 2648 , F 216, S 8, H CO 15416, I/A 17 (18.01.19).
Revocaciones. Apo.Sol.: BECERRA LOPEZ AZAHARA. Datos registrales. T 2648 , F 219, S 8, H CO 15416, I/A 21 (21.12.20).
Revocaciones. Auditor: MOORE AUDITEST SL. Nombramientos. Auditor: KPMG AUDITORES SL. Datos registrales. T 2648 , F216, S 8, H CO 15416, I/A 17 (18.01.19).
27 de Mayo de 2021Nombramientos. Apo.Sol.: LOPEZ MORENO AMPARO;RUIZ GALLEGOS GARRIDO ELENA MARIA;MARQUES CAMONA MANUELJESUS;MORALES CORDOBES DIEGO;MONTERO AHUMADA ANTONIO;RODRIGUEZ MEDINA CARLOS SANTIAGO;NAVARROCABELLO CARLOS FRANCISCO;MUDARRA PALOMARES JOSE ANTONIO. Datos registrales. T 2648 , F 219, S 8, H CO 15416,I/A 21 (21.12.20).
04 de Marzo de 2021Revocaciones. Apo.Man.Soli: AGUERA FERNANDEZ FRANCISCO JAVIER. Datos registrales. T 2648 , F 222, S 8, H CO 15416,I/A 22 (26.02.21).
Nombramientos. Apo.Man.Soli: GONZALEZ VAZQUEZ ALFONSO MANUEL. Datos registrales. T 2648 , F 223, S 8, H CO 15416,I/A 23 (26.02.21).
30 de Diciembre de 2020Revocaciones. Apo.Sol.: VIDAL TORRES ROMERO JOSE JUAN;AGUERA FERNANDEZ FRANCISCO JAVIER. Apo.Man.Soli:VIDAL TORRES ROMERO JOSE JUAN;AGUERA FERNANDEZ FRANCISCO JAVIER. Nombramientos. Apo.Man.Soli: VIDALTORRES ROMERO JOSE JUAN;AGUERA FERNANDEZ FRANCISCO JAVIER. Datos registrales. T 2648 , F 219, S 8, H CO 15416,I/A 21 (21.12.20).
29 de Agosto de 2019Nombramientos. Consejero: DAVILA DOMECQ JUAN PEDRO. Datos registrales. T 2648 , F 217, S 8, H CO 15416, I/A 20(21.08.19).
03 de Julio de 2019Nombramientos. Apo.Sol.: FERRERAS PUCHOL MANUEL;LOPEZ LORA ANTONIO JAVIER;GUILLENA SALVADOR RAFAELFRANCISCO;VEGA SANCHEZ ZAHIRA;DUE脩AS RANCHAL JOSE LUIS;ALGARRA ALVAREZ RAFAEL LUIS;BECERRA LOPEZAZAHARA. Datos registrales. T 2648 , F 217, S 8, H CO 15416, I/A 19 (25.06.19).
02 de Abril de 2019Cambio de domicilio social. C/ DIEGO GALVAN 251 B - POLIGONO LAS QUEMADAS (CORDOBA). Datos registrales. T 2648 , F216, S 8, H CO 15416, I/A 18 (25.03.19).
25 de Enero de 2019Reelecciones. Auditor: MOORE STEPHENS JMC SL. Datos registrales. T 2648 , F 216, S 8, H CO 15416, I/A 17 (18.01.19).
10 de Diciembre de 2018Nombramientos. Apo.Man.Soli: VIDAL TORRES ROMERO JOSE JUAN;AGUERA FERNANDEZ FRANCISCO JAVIER. Datosregistrales. T 2648 , F 215, S 8, H CO 15416, I/A 16 (29.11.18).
29 de Noviembre de 2018Reelecciones. Auditor: MOORE STEPHENS JMC SL. Datos registrales. T 2648 , F 215, S 8, H CO 15416, I/A 15 (22.11.18).
17 de Octubre de 2018Nombramientos. Consejero: VIDAL TORRES ROMERO JOSE JUAN. Datos registrales. T 1454 , F 22, S 8, H CO 15416, I/A 11(30.08.18).
06 de Septiembre de 2018Ceses/Dimisiones. Consejero: FUERTES GIMENO RAFAEL. Presidente: FUERTES GIMENO RAFAEL. Consejero: CHACONPAREJO MARIA INMACULADA. Secretario: CHACON PAREJO MARIA INMACULADA. Consejero: VIDAL TORRES ROMERO JOSEJUAN. Vicepresid.: VIDAL TORRES ROMERO JOSE JUAN. Con.Delegado: VIDAL TORRES ROMERO JOSE JUAN.Nombramientos. Consejero: FERNANDEZ LARREA SOCORRO. Presidente: FERNANDEZ LARREA SOCORRO. Consejero: GALLOMARTINEZ PABLO;RIOS CAVO JOSE IGNACIO. SecreNoConsj: SANGRO GOMEZ ACEBO PEDRO MARIA. Datos registrales. T1454 , F 22, S 8, H CO 15416, I/A 11 (30.08.18).
Modificaciones estatutarias. 14. Organizaci贸n de la administraci贸n de la sociedad.-. 15. Organizaci贸n de la administraci贸n de lasociedad.-. 16. Organizaci贸n de la administraci贸n de la sociedad.-. 17. Organizaci贸n de la administraci贸n de la sociedad.-. 18.Organizaci贸n de la administraci贸n de la sociedad.-. Datos registrales. T 1454 , F 23, S 8, H CO 15416, I/A 12 (30.08.18).
Nombramientos. Apoderado: VIDAL TORRES ROMERO JOSE JUAN. Datos registrales. T 1454 , F 24, S 8, H CO 15416, I/A 13(30.08.18).
Nombramientos. Apo.Sol.: VIDAL TORRES ROMERO JOSE JUAN;AGUERA FERNANDEZ FRANCISCO JAVIER. Datosregistrales. T 2648 , F 212, S 8, H CO 15416, I/A 14 (30.08.18).
24 de Octubre de 2017Ceses/Dimisiones. Adm. Solid.: FUERTES GIMENO RAFAEL;CHACON PAREJO MARIA INMACULADA. Nombramientos.Consejero: FUERTES GIMENO RAFAEL. Presidente: FUERTES GIMENO RAFAEL. Consejero: CHACON PAREJO MARIAINMACULADA. Secretario: CHACON PAREJO MARIA INMACULADA. Consejero: VIDAL TORRES ROMERO JOSE JUAN.Vicepresid.: VIDAL TORRES ROMERO JOSE JUAN. Con.Delegado: VIDAL TORRES ROMERO JOSE JUAN. Modificacionesestatutarias. 3. Domicilio social y web corporativa.-. 18. Organizaci贸n de la administraci贸n de la sociedad.-. Otros conceptos:Cambio del Organo de Administraci贸n: Administradores solidarios a Consejo de administraci贸n. Cambio de domicilio social. C/ESTEBAN CABRERA - PARCELA 84 NAVE 25 POLIGONO (CORDOBA). Datos registrales. T 1454 , F 21, S 8, H CO 15416, I/A 10(13.10.17).
25 de Octubre de 2016Cambio de objeto social. a).- Tiene por objeto la intermediaci贸n en compra, venta, alquiler de fincas urbanas y r煤sticas, alquiler debienes muebles, gesti贸n de pr茅stamos, administraci贸n de fincas tanto urbanas como r煤sticas, y el estudio de viabilidad para centralesde Telefon铆a. b).- La intermediaci贸n en la prestaci贸n de. Datos registrales. T 1454 , F 20, S 8, H CO 15416, I/A 9 (18.10.16).
04 de Octubre de 2016Cancelaciones de oficio de nombramientos. Auditor: EUDITA MV CECA AUDITORES FINANCIEROS SLP. Nombramientos.Auditor: MOORE STEPHENS JMC SL. Datos registrales. T 1454 , F 20, S 8, H CO 15416, I/A 8 (27.09.16).
18 de Diciembre de 2014Reelecciones. Auditor: EUDITA MV CECA AUDITORES FINANCIEROS SLP. Datos registrales. T 1454 , F 20, S 8, H CO 15416,I/A 7 (11.12.14).
13 de Diciembre de 2011Nombramientos. Apoderado: ALGARRA ALVAREZ RAFAEL LUIS. Datos registrales. T 1454 , F 18, S 8, H CO 15416, I/A 6 (1.12.11).
02 de Junio de 2010Reelecciones. Auditor: MV CECA AUDITORES FINANCIEROS SLP. Aud.Supl.: MU脩OZ CASCOS GABRIEL. Datos registrales. T1454 , F 18, S 8, H CO 15416, I/A 5 (24.05.10).
01 de Junio de 2009Ampliacion del objeto social. c.- Dise帽o, desarrollo, fabricaci贸n, venta, alquiler, consultor铆a, instalaci贸n y mantenimiento de lossiguientes bienes y servicios: Productos y Sistemas de Radiocomunicaciones, productos y sistemas de radiodifusi贸n y televisi贸n, v铆aradio o v铆a cable, productos o sistemas de telefon铆a y radiotelefo. Datos registrales. T 1454 , F 18, S 8, H CO 15416, I/A 4 (21.05.09).
28 de Mayo de 2009Nombramientos. Auditor: MV CECA AUDITORES FINANCIEROS SLP;MU脩OZ CASCOS GABRIEL. Datos registrales. T 1454 , F17, S 8, H CO 15416, I/A 3 (19.05.09).