Buscador CIF Logo

Actos BORME Oftalmologia Moncloa Sl

驴Quieres acceder a la API de EMPRESAS CIF? Obten la informaci贸n de todas las empresas en tiempo real desde tu plataforma.
Ahora con un 25% de DESCUENTO el primer MES. Quiero la API de EMPRESAS

Logo cabecera Oftalmologia Moncloa Sl

Actos BORME Oftalmologia Moncloa Sl - B84011535

Tenemos registrados 12 Actos BORME del Registro Mercantil de Alicante para Oftalmologia Moncloa Sl con CIF B84011535

馃敊 Perfil de Oftalmologia Moncloa Sl
馃洅 Comprar listado completo de Empresas de Alicante

Actos BORME de Oftalmologia Moncloa Sl

08 de Enero de 2021
Ceses/Dimisiones. Cons.Del.Man: ZARCO ALONSO CARLOS. Consejero: IVORRA MIRALLES FRANCISCO;TA脩A RIVEROPEDRO;ZARCO ALONSO CARLOS. Presidente: IVORRA MIRALLES FRANCISCO. Cons.Del.Man: TA脩A RIVERO PEDRO.Revocaciones. Apo.Sol.: ZARCO ALONSO CARLOS;TA脩A RIVERO PEDRO;IVORRA MIRALLES FRANCISCO;DE PORRES ORTIZDE URBINA ENRIQUE;RODRIGUEZ VILLA MATONS ANDRES;LOPEZ JERICO FRANCISCO JAVIER. Apoderado: LOPEZ JERICOFRANCISCO JAVIER. Apo.Manc.: CABALLERO CABALLERO MARIANO;LOPEZ JERICO FRANCISCO JAVIER. Apo.Sol.: ALCALDEGOMEZ MARIA DOLORES. Apo.Manc.: IVORRA MIRALLES FRANCISCO;DE PORRES ORTIZ DE URBINA ENRIQUE;GARCIALEGAZ RUIZ BENITO. Apoderado: RIVERA GONZALEZ MARTIN;SORIA FERNANDEZ DE CORDOBA MANUEL;RODRIGUEZ VILLAMATONS ANDRES;ALCALDE GOMEZ MARIA DOLORES;CABALLERO CABALLERO MARIANO;DELGADO SORIA MARIO.Apo.Manc.: ALCALDE GOMEZ MARIA DOLORES;SORIA FERNANDEZ DE CORDOBA MANUEL;ALCALDE GOMEZ MARIADOLORES;SORIA FERNANDEZ DE CORDOBA MANUEL;GARCIA LEGAZ RUIZ BENITO;CABALLERO CABALLEROMARIANO;LOPEZ JERICO FRANCISCO JAVIER;IVORRA MIRALLES FRANCISCO;DE PORRES ORTIZ DE URBINAENRIQUE;IVORRA MIRALLES FRANCISCO;DE PORRES ORTIZ DE URBINA ENRIQUE;SORIA FERNANDEZ DE CORDOBAMANUEL;GARCIA LEGAZ RUIZ BENITO;ALCALDE GOMEZ MARIA DOLORES;CABALLERO CABALLERO MARIANO;LOPEZJERICO FRANCISCO JAVIER;SORIA FERNANDEZ DE CORDOBA MANUEL;GARCIA LEGAZ RUIZ BENITO;CABALLEROCABALLERO MARIANO;ALCALDE GOMEZ MARIA DOLORES;LOPEZ JERICO FRANCISCO JAVIER;IVORRA MIRALLESFRANCISCO;DE PORRES ORTIZ DE URBINA ENRIQUE. Apoderado: RIVERA GONZALEZ MARTIN. Extinci贸n. Datos registrales.T 4303 , F 136, S 8, H A 170355, I/A 4 (30.12.20).

05 de Agosto de 2020
Nombramientos. Apoderado: RIVERA GONZALEZ MARTIN. Datos registrales. T 4303 , F 136, S 8, H A 170355, I/A 3 (28.07.20).

22 de Julio de 2020
Cambio de domicilio social. AVDA DE DENIA 103 (ALICANTE). Datos registrales. T 4303 , F 136, S 8, H A 170355, I/A 2(14.07.20).

20 de Febrero de 2019
Revocaciones. Apoderado: ALCALDE GOMEZ MARIA DOLORES;SORIA FERNANDEZ DE CORDOBA MANUEL;CABALLEROCABALLERO MARIANO;RODRIGUEZ VILLA MATONS ANDRES. Nombramientos. Apoderado: SORIA FERNANDEZ DECORDOBA MANUEL;RODRIGUEZ-VILLA MATONS ANDRES;ALCALDE GOMEZ MARIA DOLORES;CABALLERO CABALLEROMARIANO;DELGADO SORIA MARIO. Datos registrales. T 31808 , F 159, S 8, H M 356051, I/A 12 (13.02.19).

04 de Mayo de 2018
Nombramientos. Apoderado: RIVERA GONZALEZ MARTIN. Datos registrales. T 31808 , F 159, S 8, H M 356051, I/A 11(19.04.18).

26 de Septiembre de 2017
Revocaciones. Apoderado: TIRADO GUALLART JESUS. Datos registrales. T 31808 , F 159, S 8, H M 356051, I/A 10 (18.09.17).

18 de Agosto de 2017
Revocaciones. Apoderado: NAVARRO MERINO LUIS. Datos registrales. T 31808 , F 159, S 8, H M 356051, I/A 9 ( 4.08.17).

25 de Enero de 2017
Ampliaci贸n de capital. Capital: 56.850,00 Euros. Resultante Suscrito: 60.000,00 Euros. Datos registrales. T 31808 , F 158, S 8, HM 356051, I/A 8 (17.01.17).

17 de Febrero de 2014
Revocaciones. Apoderado: DIEZ PASO TOMAS. Nombramientos. Apoderado: ALCALDE GOMEZ MARIA DOLORES;IVORRAMIRALLES FRANCISCO;DE PORRES ORTIZ DE URBINA ENRIQUE;SORIA FERNANDEZ DE CORDOBA MANUEL;GARCIA-LEGAZ

30 de Julio de 2013
Revocaciones. Apo.Sol.: GUISADO DEL TORO JOSE CARLOS;BUJAN VARELA MIGUEL ANGEL;URCELAY SEGURA JOSELUIS.Apoderado: MARTINEZ MOLINA JUAN. Datos registrales. T 20164 , F 147, S 8, H M 356051, I/A 6 (23.07.13).

30 de Enero de 2012
Nombramientos. Apoderado: LOPEZ JERICO FRANCISCO JAVIER. Datos registrales. T 20164 , F 147, S 8, H M 356051, I/A 5(16.01.12).

14 de Noviembre de 2011
Ceses/Dimisiones. Consejero: GUISADO DEL TORO JOSE CARLOS;ZARCO ALONSO CARLOS. Presidente: GUISADO DELTORO JOSE CARLOS. Secretario: ZARCO ALONSO CARLOS. Consejero: BUJAN VARELA MIGUEL ANGEL. Cons.Del.Man: BUJANVARELA MIGUEL ANGEL;GUISADO DEL TORO JOSE CARLOS. Nombramientos. SecreNoConsj: CABALLERO CABALLEROMARIANO. Consejero: IVORRA MIRALLES FRANCISCO;TA脩A RIVERO PEDRO;ZARCO ALONSO CARLOS. Presidente: IVORRAMIRALLES FRANCISCO. Cons.Del.Man: TA脩A RIVERO PEDRO;ZARCO ALONSO CARLOS. Datos registrales. T 20164 , F 146, S8, H M 356051, I/A 4 ( 2.11.11).

Utilizamos cookies de terceros con finalidades anal铆ticas, de personalizaci贸n, y de publicidad comportamental. Puede configurar ahora el uso de esta tecnolog铆a. Si acepta o contin煤a navegando, consideramos que est谩 de acuerdo con su uso. Mas informaci贸n