Actos BORME de Ogilvy Commonhealth Sl
12 de Marzo de 2020Ceses/Dimisiones. SecreNoConsj: MARTINEZ IGLESIAS FRANCISCO. VsecrNoConsj: OLABARRI GORTAZAR PABLO. Consejero:CAMAS ALBAR LOURDES;ARZUBIALDE SAENZ-BADILLOS ELVIRA;VETERE MICHELINA. Presidente: ARZUBIALDE SAENZ-BADILLOS ELVIRA. Disoluci贸n. Fusion. Extinci贸n. Datos registrales. T 21026 , F 106, S 8, H M 67161, I/A 51 ( 5.03.20).
26 de Diciembre de 2019Sociedad unipersonal. Cambio de identidad del socio 煤nico: WPP MARKETING COMMUNICATIONS SPAIN SUCURSAL ENESP. Datos registrales. T 21026 , F 106, S 8, H M 67161, I/A 50 (18.12.19).
11 de Abril de 2019Cambio de domicilio social. C/ RIOS ROSAS 26 (MADRID). Datos registrales. T 21026 , F 106, S 8, H M 67161, I/A 49 ( 4.04.19).
15 de Noviembre de 2018Cambio de domicilio social. AVDA DE BURGOS 21 (MADRID). Datos registrales. T 21026 , F 103, S 8, H M 67161, I/A 46 (7.11.18).
Ceses/Dimisiones. Consejero: MUNICIO DEL CAMPO CARLOS;RIVA LARIOS LUIS. Presidente: RIVA LARIOS LUIS. Consejero:GRAU CASTELLO VICENTE. Presidente: GRAU CASTELLO VICENTE. Consejero: VETERE MICHELINA. Nombramientos.Consejero: CAMAS ALBAR LOURDES;GRAU CASTELLO VICENTE. Presidente: GRAU CASTELLO VICENTE. Consejero:ARZUBIALDE SAENZ-BADILLOS ELVIRA;VETERE MICHELINA. Presidente: ARZUBIALDE SAENZ-BADILLOS ELVIRA. Datosregistrales. T 21026 , F 103, S 8, H M 67161, I/A 47 ( 7.11.18).
Nombramientos. Apoderado: VETERE MICHELINA. Datos registrales. T 21026 , F 104, S 8, H M 67161, I/A 48 ( 7.11.18).
11 de Abril de 2016Revocaciones. Apoderado: DIAMOND STUART ALAN. Apo.Man.Soli: DE PABLO BLAYA LOURDES. Datos registrales. T 21026 ,F 102, S 8, H M 67161, I/A 45 ( 1.04.16).
29 de Marzo de 2016Revocaciones. Apo.Man.Soli: RIVA LARIOS LUIS. Apo.Manc.: MERINO LODEIRO ROSARIO. Apo.Sol.: TELLEZ GREGORIOFRANCISCO JOSE;ALVARO RUIZ LUCIA;GOENECHEA ALVAREZ BORJA. Apoderado: DOMINGUEZ LOPEZ DE CASTROALVARO. Nombramientos. Apo.Sol.: MARTINEZ IGLESIAS FRANCISCO;BOCOS MARTIN TERESA;ALVAREZ CIENFUEGOSJAVIER;BOSCH MINGUET FRANCISCO JAVIER. Datos registrales. T 21026 , F 100, S 8, H M 67161, I/A 43 (17.03.16).
Nombramientos. Apo.Man.Soli: ARZUBIALDE SAENZ-BADILLOS ELVIRA;GOLDMAN ELLEN TRACY;MAXWELL-JACKSONCRISPIN FOX;CAMAS ALBAR LOURDES. Datos registrales. T 21026 , F 100, S 8, H M 67161, I/A 44 (17.03.16).
09 de Marzo de 2016Ceses/Dimisiones. Consejero: DE PABLO BLAYA LOURDES. Presidente: DE PABLO BLAYA LOURDES. Nombramientos.Consejero: RIVA LARIOS LUIS. Presidente: RIVA LARIOS LUIS. Datos registrales. T 21026 , F 99, S 8, H M 67161, I/A 42 ( 1.03.16).
03 de Diciembre de 2014Ceses/Dimisiones. Consejero: PUJADAS ROVIROSA ENRIQUE. Presidente: PUJADAS ROVIROSA ENRIQUE. Nombramientos.Consejero: MUNICIO DEL CAMPO CARLOS. Presidente: DE PABLO BLAYA LOURDES. Datos registrales. T 21026 , F 99, S 8, H M67161, I/A 41 (25.11.14).
21 de Octubre de 2013Revocaciones. Apo.Man.Soli: GARCIA ABAD MARTINEZ BLANCO ANA. Nombramientos. Apoderado: DOMINGUEZ LOPEZ DECASTRO ALVARO. Datos registrales. T 21026 , F 97, S 8, H M 67161, I/A 40 (11.10.13).
01 de Octubre de 2013Modificaciones estatutarias. 28. CONSEJO DE ADMINISTRACION. Datos registrales. T 21026 , F 96, S 8, H M 67161, I/A 39(23.09.13).
25 de Septiembre de 2013Ceses/Dimisiones. Consejero: RODRIGUEZ MOAR MARIA-VICTORIA. Revocaciones. Apo.Man.Soli: RODRIGUEZ MOARMARIA-VICTORIA. Nombramientos. Consejero: VETERE MICHELINA. Datos registrales. T 21026 , F 95, S 8, H M 67161, I/A 37(17.09.13).
Ceses/Dimisiones. Secretario: DIEZ VERGARA MAITANE. Vicesecret.: MENDEZ ZORI JOSE MARIA. Revocaciones. Apoderado:BERNAL GIVICA ARANZAZU;MAFUZ GUMIEL ROSA MARIA. Nombramientos. SecreNoConsj: MARTINEZ IGLESIASFRANCISCO. VsecrNoConsj: OLABARRI GORTAZAR PABLO. Apo.Sol.: TELLEZ GREGORIO FRANCISCO JOSE;ALVARO RUIZLUCIA;GOENECHEA ALVAREZ BORJA. Datos registrales. T 21026 , F 96, S 8, H M 67161, I/A 38 (17.09.13).
20 de Octubre de 2011Revocaciones. Apo.Man.Soli: DE PABLO BLAYA LOURDES. Apo.Manc.: MERINO LODEIRO ROSARIO. Apoderado: CIUDADIGLESIAS JIMENA;GARCIA ABAD MARTINEZ BLANCO ANA;GIL ACACIO MARIA DEL PILAR;RIVA LARIOS LUIS;RODRIGUEZMOAR MARIA-VICTORIA. Nombramientos. Apo.Man.Soli: DE PABLO BLAYA LOURDES;GARCIA ABAD MARTINEZ BLANCOANA;RIVA LARIOS LUIS;RODRIGUEZ MOAR MARIA-VICTORIA. Apo.Manc.: MERINO LODEIRO ROSARIO. Datos registrales. T21026 , F 94, S 8, H M 67161, I/A 36 ( 6.10.11).
08 de Julio de 2011Revocaciones. Apo.Man.Soli: ALDA CAMPILLO ENRIQUE. Nombramientos. Apoderado: RODRIGUEZ MOAR MARIA-VICTORIA.Datos registrales. T 21026 , F 92, S 8, H M 67161, I/A 35 (29.06.11).
30 de Mayo de 2011Ceses/Dimisiones. Consejero: ALDA CAMPILLO ENRIQUE. Cons.Del.Sol: ALDA CAMPILLO ENRIQUE. Revocaciones.Apo.Man.Soli: LOPEZ GALAN ANA MARIA. Nombramientos. Consejero: RODRIGUEZ MOAR MARIA-VICTORIA. Apoderado: RIVALARIOS LUIS. Datos registrales. T 21026 , F 92, S 8, H M 67161, I/A 34 (18.05.11).