Buscador CIF Logo

Actos BORME Ohl Industrial Oil & Gas Sl

驴Quieres acceder a la API de EMPRESAS CIF? Obten la informaci贸n de todas las empresas en tiempo real desde tu plataforma.
Ahora con un 25% de DESCUENTO el primer MES. Quiero la API de EMPRESAS

Logo cabecera Ohl Industrial Oil & Gas Sl

Actos BORME Ohl Industrial Oil & Gas Sl - B86775327

Tenemos registrados 18 Actos BORME del Registro Mercantil de Madrid para Ohl Industrial Oil & Gas Sl con CIF B86775327

馃敊 Perfil de Ohl Industrial Oil & Gas Sl
馃洅 Comprar listado completo de Empresas de Madrid

Actos BORME de Ohl Industrial Oil & Gas Sl

28 de Diciembre de 2015
Ceses/Dimisiones. Adm. Mancom.: SICRE DIAZ ALBERTO;MOLINA ESTEBAN MARCELO. Revocaciones. Apoderado:WEICKERT MOLINA ENRIQUE;VALENTIN CARCIA CANDIDO;CARLSSON PATRICIO ALFONSO;GUTIERREZ GOMEZMARTA;PASTOR MATADOR MANUEL;GARCIA GIL JAIME;MORA MARTIN LUIS MIGUEL;AZULA PALACIOS IGNACIO;MORGADODE ORTUETA JOSE ALBERTO. Apo.Sol.: CANO TOROLLO IGNACIO;PALOMINO CANTARELLAS JOSE FELIX;LOPEZ COSOMARIA JESUS;CASTRO ALVAREZ JOAQUIN. Apoderado: CANO TOROLLO IGNACIO;BAYON HERNANDEZ JUAN-CARLOS.Apo.Sol.: SANCHEZ DELGADO RAFAEL;GUILLEN LOPEZ VICENTE. Apo.Man.Soli: DE VEGA CARRASCO FERNANDO MARIA.Apoderado: GARRIDO PEREZ JOSE MANUEL. Apo.Sol.: DELGADO ROBAYNA DAVID;BALLESTEROS DIAZ ANGEL;DE BENGOADIAZ JULIO MARIA. Apo.Man.Soli: SALVADOR PENDON JUAN. Disoluci贸n. Fusion. Extinci贸n. Extinci贸n. Datos registrales. T33140 , F 62, S 8, H M 563104, I/A 18 (17.12.15).

23 de Marzo de 2015
Nombramientos. Apo.Man.Soli: SALVADOR PENDON JUAN. Datos registrales. T 31285 , F 49, S 8, H M 563104, I/A 17(12.03.15).

03 de Febrero de 2015
Ceses/Dimisiones. Consejero: BERJILLOS DOBLAS ANTONIO;MOLINA ESTEBAN MARCELO;GARCIA-LINARES GARCIALUIS;DE VEGA CARRASCO FERNANDO MARIA. Presidente: BERJILLOS DOBLAS ANTONIO. Consejero: SICRE DIAZ ALBERTO.SecreNoConsj: FLORES GALLEGO ALBERTO. Nombramientos. Adm. Mancom.: SICRE DIAZ ALBERTO;MOLINA ESTEBANMARCELO. Otros conceptos: Cambio del Organo de Administraci贸n: Consejo de administraci贸n a Administradores mancomunados.Datos registrales. T 31285 , F 49, S 8, H M 563104, I/A 16 (27.01.15).

31 de Diciembre de 2014
Revocaciones. Apo.Sol.: CAMPEN REINIER PETER WILLEM PATRICK. Datos registrales. T 31285 , F 49, S 8, H M 563104, I/A 15(22.12.14).

11 de Julio de 2014
Ceses/Dimisiones. Consejero: SAN CRISTOBAL TIERRA GONZALO. Presidente: DE SAN CRISTOBAL TIERRA GONZALO.Nombramientos. Presidente: BERJILLOS DOBLAS ANTONIO. Consejero: SICRE DIAZ ALBERTO. Datos registrales. T 31285 , F48, S 8, H M 563104, I/A 14 ( 4.07.14).

07 de Julio de 2014
Nombramientos. Apo.Sol.: DELGADO ROBAYNA DAVID;BALLESTEROS DIAZ ANGEL. Datos registrales. T 31285 , F 47, S 8, HM 563104, I/A 12 (25.06.14).

Nombramientos. Apo.Sol.: DE BENGOA DIAZ JULIO MARIA. Datos registrales. T 31285 , F 48, S 8, H M 563104, I/A 13(25.06.14).

24 de Junio de 2014
Nombramientos. Apoderado: GARRIDO PEREZ JOSE MANUEL. Datos registrales. T 31285 , F 47, S 8, H M 563104, I/A 11(13.06.14).

05 de Junio de 2014
Ampliaci贸n de capital. Capital: 3.452.700,00 Euros. Resultante Suscrito: 3.952.700,00 Euros. Datos registrales. T 31285 , F 46, S8, H M 563104, I/A 10 (29.05.14).

18 de Febrero de 2014
Nombramientos. Apo.Sol.: CANO TOROLLO IGNACIO;PALOMINO CANTARELLAS JOSE FELIX;LOPEZ COSO MARIAJESUS;CASTRO ALVAREZ JOAQUIN. Apoderado: CANO TOROLLO IGNACIO. Datos registrales. T 31285 , F 43, S 8, H M 563104,I/A 6 (11.02.14).

Nombramientos. Apoderado: BAYON HERNANDEZ JUAN-CARLOS. Datos registrales. T 31285 , F 43, S 8, H M 563104, I/A 7(11.02.14).

Nombramientos. Apo.Sol.: CAMPEN REINIER PETER WILLEM PATRICK;SANCHEZ DELGADO RAFAEL;GUILLEN LOPEZVICENTE Datos registrales. T 31285 , F 44, S 8, H M 563104, I/A 8 (11.02.14).

Nombramientos. Apo.Man.Soli: DE VEGA CARRASCO FERNANDO MARIA. Datos registrales. T 31285 , F 45, S 8, H M 563104,I/A 9 (11.02.14).

03 de Febrero de 2014
Modificaciones estatutarias. MODIFICADO EL ARTICULO 12潞. Datos registrales. T 31285 , F 42, S 8, H M 563104, I/A 5(24.01.14).

31 de Enero de 2014
Nombramientos. Apoderado: WEICKERT MOLINA ENRIQUE;VALENTIN CARCIA CANDIDO;ALFONSO CARLSSONPATRICIO;GUTIERREZ GOMEZ MARTA;PASTOR MATADOR MANUEL;GARCIA GIL JAIME;MORA MARTIN LUIS MIGUEL;AZULAPALACIOS IGNACIO;MORGADO DE ORTUETA JOSE ALBERTO. Datos registrales. T 31285 , F 42, S 8, H M 563104, I/A 4(23.01.14).

28 de Noviembre de 2013
Ceses/Dimisiones. Consejero: RODRIGUEZ NORIEGA FERNANDEZ SANTIAGO. Nombramientos. Consejero: DE VEGACARRASCO FERNANDO MARIA. Datos registrales. T 31285 , F 41, S 8, H M 563104, I/A 3 (20.11.13).

01 de Agosto de 2013
Nombramientos. Presidente: DE SAN CRISTOBAL TIERRA GONZALO. SecreNoConsj: FLORES GALLEGO ALBERTO. Datosregistrales. T 31285 , F 41, S 8, H M 563104, I/A 2 (24.07.13).

31 de Julio de 2013
Constituci贸n. Comienzo de operaciones: 26.06.13. Objeto social: EL DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD DE INGENIERIAINDUSTRIAL, ESPECIALMENTE PLANTAS O SISTEMAS COMPLETOS INDUSTRIALES, INCLUYENDO EL DISE脩O, LACONSTRUCCION, LA CONCESION, EL MANTENIMIENTO, LA OPERACION Y CUALQUIER OTRA ACTIVIDAD CONEXA. Domicilio:C/ ARTURO SORIA 343 (MADRID). Capital: 500.000,00 Euros. Declaraci贸n de unipersonalidad. Socio 煤nico: OHL INDUSTRIALSL. Nombramientos. Consejero: BERJILLOS DOBLAS ANTONIO;MOLINA ESTEBAN MARCELO;RODRIGUEZ NORIEGAFERNANDEZ SANTIAGO;GARCIA-LINARES GARCIA LUIS;SAN CRISTOBAL TIERRA GONZALO. Datos registrales. T 31285 , F40, S 8, H M 563104, I/A 1 (22.07.13).

Utilizamos cookies de terceros con finalidades anal铆ticas, de personalizaci贸n, y de publicidad comportamental. Puede configurar ahora el uso de esta tecnolog铆a. Si acepta o contin煤a navegando, consideramos que est谩 de acuerdo con su uso. Mas informaci贸n